Colette Mary GRANT
Personne physique
| Titre | Mrs |
|---|---|
| Prénom | Colette |
| Deuxième prénom | Mary |
| Nom de famille | GRANT |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 0 |
| Inactif | 10 |
| Démissionné | 18 |
| Total | 28 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENLIGHT FOUNDATION | 01 déc. 2011 | Dissoute | Administrateur | Townhead Street ML3 7DP Hamilton Barncluith Business Centre Lanarkshire United Kingdom | Scotland | British | ||
| GRANT EUROPEAN FUND LIMITED | 15 nov. 2007 | Dissoute | Secrétaire | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | British | |||
| GRANT FUND MANAGEMENT LIMITED | 09 mars 2007 | Dissoute | Secrétaire | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | British | |||
| GLOBAL TREES PROPERTY LIMITED | 09 mars 2007 | Dissoute | Secrétaire | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | British | |||
| GO START A BUSINESS LIMITED | 23 févr. 2007 | Dissoute | Secrétaire | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | British | |||
| GO START A BUSINESS LIMITED | 23 févr. 2007 | Dissoute | Administrateur | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | Scotland | British | ||
| GRANT RESIDENTIAL PROPERTY LIMITED | 06 janv. 2006 | Dissoute | Administrateur | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | Scotland | British | ||
| GRANT RESIDENTIAL PROPERTY LIMITED | 20 mai 2005 | Dissoute | Secrétaire | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | British | |||
| GRANT CALEDONIA 2 LIMITED | 19 juil. 2004 | Dissoute | Administrateur | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | Scotland | British | ||
| GRANT CALEDONIA 2 LIMITED | 19 juil. 2004 | Dissoute | Secrétaire | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | British | |||
| THE ENTREPRENEURIAL SCOTLAND FOUNDATION | 30 janv. 2015 | 30 juin 2024 | Active | Administrateur | Coates Crescent Edinburgh EH3 7AF Edinburgh 13 Lothian United Kingdom | Scotland | British | |
| THE ENTREPRENEURIAL EXCHANGE LIMITED | 03 mai 2011 | 10 mai 2021 | Active | Administrateur | Cathedral Street University Of Strathclyde Business School G4 0QU Glasgow 199 - Cw6.02 Scotland | Scotland | British | |
| ENTREPRENEURIAL SCOTLAND GROUP LIMITED | 07 sept. 2017 | 22 mai 2020 | Dissoute | Administrateur | Cathedral Street Strathclyde Business School G4 0QU Glasgow 199 Scotland | Scotland | British | |
| ENTREPRENEURIAL SCOTLAND LIMITED | 07 sept. 2017 | 20 nov. 2019 | Active | Administrateur | Cathedral Street G4 0QU Glasgow 199 Scotland | Scotland | British | |
| GRANT CALEDONIA LIMITED | 19 avr. 2001 | 04 nov. 2019 | Dissoute | Secrétaire | 14 Coates Crescent Edinburgh EH3 7AF | British | ||
| GRANT CALEDONIA LIMITED | 19 avr. 2001 | 04 nov. 2019 | Dissoute | Administrateur | 14 Coates Crescent Edinburgh EH3 7AF | Scotland | British | |
| GP INVESTMENT & MANAGEMENT LTD | 17 mai 2017 | 30 juil. 2019 | Dissoute | Administrateur | EH3 7AF Edinburgh 14 Coates Crescent Scotland | Scotland | British | |
| SANDSTONE ASSET MANAGEMENT LTD | 06 janv. 2006 | 30 juil. 2019 | Active | Secrétaire | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | British | ||
| SANDSTONE ASSET MANAGEMENT LTD | 06 janv. 2006 | 30 juil. 2019 | Active | Administrateur | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | Scotland | British | |
| CENTRAL LETTING LIMITED | 13 nov. 2003 | 30 juil. 2019 | Dissoute | Secrétaire | 14 Coates Crescent Edinburgh EH3 7AF | British | ||
| CENTRAL LETTING LIMITED | 13 nov. 2003 | 30 juil. 2019 | Dissoute | Administrateur | 14 Coates Crescent Edinburgh EH3 7AF | Scotland | British | |
| SANDSTONE UK MANAGEMENT LTD | 19 juin 2002 | 30 juil. 2019 | Active | Secrétaire | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | British | ||
| SANDSTONE UK MANAGEMENT LTD | 03 mai 2001 | 30 juil. 2019 | Active | Administrateur | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | Scotland | British | |
| SANDSTONE UK PROPERTY INVESTMENT LTD | 02 juil. 1998 | 30 juil. 2019 | Liquidation | Secrétaire | 14 Coates Crescent Edinburgh EH3 7AF Midlothian | British | ||
| SANDSTONE UK PROPERTY INVESTMENT LTD | 02 juil. 1998 | 30 juil. 2019 | Liquidation | Administrateur | 14 Coates Crescent Edinburgh EH3 7AF Midlothian | Scotland | British | |
| THE ENTREPRENEURIAL SCOTLAND FOUNDATION | 15 août 2017 | 15 août 2017 | Active | Administrateur | University Of Strathclyde (624) 99 George Street G1 1RD Glasgow Technology & Innovation Centre Scotland Scotland | Scotland | British | |
| GLOBAL TREES | 18 juin 2007 | 31 mai 2017 | Dissoute | Secrétaire | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | British | ||
| BUCCLEUCH GRANT LIMITED | 13 sept. 2005 | 08 août 2007 | Dissoute | Administrateur | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | Scotland | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0