• Données
  • Grande-Bretagne
  • Entreprises
  • Rechercher des entreprises
  • Sanctions
  • Rechercher des sanctions
  • Colette Mary GRANT

    Personne physique

    TitreMrs
    PrénomColette
    Deuxième prénomMary
    Nom de familleGRANT
    Date de naissance
    Est un dirigeant de sociétéNon
    Nominations
    Actif0
    Inactif10
    Démissionné18
    Total28

    Nominations

    Dirigeants nommés
    Nommé(e) àDate de nominationDate de démissionStatut de la sociétéProfessionRôleAdressePays de résidenceNationalité
    ENLIGHT FOUNDATION01 déc. 2011DissouteCompany DirectorAdministrateur
    Townhead Street
    ML3 7DP Hamilton
    Barncluith Business Centre
    Lanarkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    GRANT EUROPEAN FUND LIMITED15 nov. 2007DissouteProperty DeveloperSecrétaire
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    British
    GRANT FUND MANAGEMENT LIMITED09 mars 2007DissouteSecrétaire
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    British
    GLOBAL TREES PROPERTY LIMITED09 mars 2007DissouteSecrétaire
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    British
    GO START A BUSINESS LIMITED23 févr. 2007DissouteDirectorSecrétaire
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    British
    GO START A BUSINESS LIMITED23 févr. 2007DissouteDirectorAdministrateur
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish
    GRANT RESIDENTIAL PROPERTY LIMITED06 janv. 2006DissouteProperty DevelopmentAdministrateur
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish
    GRANT RESIDENTIAL PROPERTY LIMITED20 mai 2005DissouteSecrétaire
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    British
    GRANT CALEDONIA 2 LIMITED19 juil. 2004DissouteCompany DirectorAdministrateur
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish
    GRANT CALEDONIA 2 LIMITED19 juil. 2004DissouteCompany DirectorSecrétaire
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    British
    THE ENTREPRENEURIAL SCOTLAND FOUNDATION30 janv. 201530 juin 2024ActiveCompany DirectorAdministrateur
    Coates Crescent
    Edinburgh
    EH3 7AF Edinburgh
    13
    Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    THE ENTREPRENEURIAL EXCHANGE LIMITED03 mai 201110 mai 2021ActiveDirectorAdministrateur
    Cathedral Street
    University Of Strathclyde Business School
    G4 0QU Glasgow
    199 - Cw6.02
    Scotland
    ScotlandBritish
    ENTREPRENEURIAL SCOTLAND GROUP LIMITED07 sept. 201722 mai 2020DissouteDirectorAdministrateur
    Cathedral Street
    Strathclyde Business School
    G4 0QU Glasgow
    199
    Scotland
    ScotlandBritish
    ENTREPRENEURIAL SCOTLAND LIMITED07 sept. 201720 nov. 2019ActiveDirectorAdministrateur
    Cathedral Street
    G4 0QU Glasgow
    199
    Scotland
    ScotlandBritish
    GRANT CALEDONIA LIMITED19 avr. 200104 nov. 2019DissouteProperty Development & Invest.Secrétaire
    14 Coates Crescent
    Edinburgh
    EH3 7AF
    British
    GRANT CALEDONIA LIMITED19 avr. 200104 nov. 2019DissouteProperty Development & Invest.Administrateur
    14 Coates Crescent
    Edinburgh
    EH3 7AF
    ScotlandBritish
    GP INVESTMENT & MANAGEMENT LTD17 mai 201730 juil. 2019DissouteDirectorAdministrateur
    EH3 7AF Edinburgh
    14 Coates Crescent
    Scotland
    ScotlandBritish
    SANDSTONE ASSET MANAGEMENT LTD06 janv. 200630 juil. 2019ActiveProperty DevelopmentSecrétaire
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    British
    SANDSTONE ASSET MANAGEMENT LTD06 janv. 200630 juil. 2019ActiveProperty DevelopmentAdministrateur
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish
    CENTRAL LETTING LIMITED13 nov. 200330 juil. 2019DissouteSecrétaire
    14 Coates Crescent
    Edinburgh
    EH3 7AF
    British
    CENTRAL LETTING LIMITED13 nov. 200330 juil. 2019DissouteProperty DevelopmentAdministrateur
    14 Coates Crescent
    Edinburgh
    EH3 7AF
    ScotlandBritish
    SANDSTONE UK MANAGEMENT LTD19 juin 200230 juil. 2019ActiveSecrétaire
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    British
    SANDSTONE UK MANAGEMENT LTD03 mai 200130 juil. 2019ActiveProperty Development InvestmenAdministrateur
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish
    SANDSTONE UK PROPERTY INVESTMENT LTD02 juil. 199830 juil. 2019LiquidationProperty Development & InvestmSecrétaire
    14 Coates Crescent
    Edinburgh
    EH3 7AF Midlothian
    British
    SANDSTONE UK PROPERTY INVESTMENT LTD02 juil. 199830 juil. 2019LiquidationProperty Development & InvestmAdministrateur
    14 Coates Crescent
    Edinburgh
    EH3 7AF Midlothian
    ScotlandBritish
    THE ENTREPRENEURIAL SCOTLAND FOUNDATION15 août 201715 août 2017ActiveDirectorAdministrateur
    University Of Strathclyde
    (624) 99 George Street
    G1 1RD Glasgow
    Technology & Innovation Centre
    Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish
    GLOBAL TREES18 juin 200731 mai 2017DissouteSecrétaire
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    British
    BUCCLEUCH GRANT LIMITED13 sept. 200508 août 2007DissouteDirectorAdministrateur
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0