ENTREPRENEURIAL SCOTLAND GROUP LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ENTREPRENEURIAL SCOTLAND GROUP LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | SC478348 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ENTREPRENEURIAL SCOTLAND GROUP LIMITED ?
| Adresse du siège social | 199 Cathedral Street Strathclyde Business School G4 0QU Glasgow Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ENTREPRENEURIAL SCOTLAND GROUP LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour ENTREPRENEURIAL SCOTLAND GROUP LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 23 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Colin Dugaid Robertson en tant que directeur le 22 mai 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Malcolm Ian Offord en tant que directeur le 22 mai 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Helen Elizabeth Russell Sayles en tant que directeur le 22 mai 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Colette Mary Grant en tant que directeur le 22 mai 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Lesley Jayne Ross Eccles en tant que directeur le 22 mai 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Alan Carnegie Brown en tant que directeur le 22 mai 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Graeme Bissett en tant que directeur le 22 mai 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Mark Robert Bamforth en tant que directeur le 22 mai 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Alexander Kennedy en tant qu'administrateur le 20 avr. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Sean Ailbe Mcgrath en tant qu'administrateur le 20 avr. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Lady Janice Theresa Gammell en tant que directeur le 20 nov. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2018 | 28 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 23 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Richard Michael Dixon en tant que directeur le 27 juin 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Inovo 121 George Street Glasgow G1 1rd Scotland à 199 Cathedral Street Strathclyde Business School Glasgow G4 0QU le 24 mai 2019 | 1 pages | AD01 | ||
Cessation de la nomination de Steve Dunlop en tant que directeur le 14 déc. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2017 | 28 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Christiaan Richard David Van Der Kuyl en tant que directeur le 18 sept. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Colin Robertson en tant qu'administrateur le 18 sept. 2018 | 2 pages | AP01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Technology & Innovation Centre University of Strathclyde (624) 99 George Street Glasgow Scotland G1 1rd Scotland à Inovo 121 George Street Glasgow G1 1rd le 20 sept. 2018 | 1 pages | AD01 | ||
Qui sont les dirigeants de ENTREPRENEURIAL SCOTLAND GROUP LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENNEDY, Alexander | Administrateur | Cathedral Street Strathclyde Business School G4 0QU Glasgow 199 Scotland | Scotland | British | 76223770002 | |||||||||
| MCGRATH, Sean Ailbe | Administrateur | Cathedral Street Strathclyde Business School G4 0QU Glasgow 199 Scotland | Scotland | Irish | 266608950001 | |||||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom |
| 76579530001 | ||||||||||
| BAMFORTH, Mark Robert | Administrateur | Cathedral Street Strathclyde Business School G4 0QU Glasgow 199 Scotland | United States | British | 243221750001 | |||||||||
| BISSETT, Graeme | Administrateur | Cathedral Street Strathclyde Business School G4 0QU Glasgow 199 Scotland | Scotland | British | 237830590001 | |||||||||
| BLACKWOOD, Derek Stuart | Administrateur | Katy Freeway TX 77094 Houston 17000 Texas Usa | United States | British | 37448730003 | |||||||||
| BROWN, Alan Carnegie | Administrateur | Cathedral Street Strathclyde Business School G4 0QU Glasgow 199 Scotland | Canada | British | 241128220001 | |||||||||
| BROWN, Sir Ewan | Administrateur | Queen Street EH2 3NR Edinburgh 48 Midlothian United Kingdom | United Kingdom | British | 190923010001 | |||||||||
| BRUCE-GARDYNE, Lucinda Emma Kate | Administrateur | Northumberland Street South West Lane EH3 6JD Edinburgh 22 Midlothian United Kingdom | Scotland | British | 131359810001 | |||||||||
| DIXON, Richard Michael, Dr | Administrateur | Castle Riggs KY11 8SG Dunfermline Vets Now Limited Fife United Kingdom | United Kingdom | British | 75654310004 | |||||||||
| DUNLOP, Steve | Administrateur | 121 George Street G1 1RD Glasgow Inovo Scotland | Scotland | British | 241002010001 | |||||||||
| ECCLES, Lesley Jayne Ross | Administrateur | 15 Lauriston Place EH3 9EN Edinburgh Quartermile One Scotland Scotland | United Kingdom | British | 210099820001 | |||||||||
| GAMMELL, Lady Janice Theresa | Administrateur | Dick Place EH9 2JB Edinburgh 36 City Of Edinburgh United Kingdom | Scotland | British | 190922050001 | |||||||||
| GRANT, Colette Mary | Administrateur | Cathedral Street Strathclyde Business School G4 0QU Glasgow 199 Scotland | Scotland | British | 59059290003 | |||||||||
| LEDERER, Peter Julian | Administrateur | Great Stuart Street EH3 7TN Edinburgh 18 Midlothian United Kingdom | Scotland | British | 134568040001 | |||||||||
| MACLEOD, Donald | Administrateur | Glenridge Avenue CA 95030 Los Gatos 133 California Usa | United States | Usa | 268771470001 | |||||||||
| MCEWING, David | Administrateur | Queen's Road AB15 4YL Aberdeen 13 United Kingdom | United Kingdom | British | 137839130001 | |||||||||
| OFFORD, Malcolm Ian | Administrateur | Charlotte Square EH2 4ET Edinburgh 26 United Kingdom | Scotland | British | 58718940008 | |||||||||
| ROBERTSON, Colin Dugaid | Administrateur | Cathedral Street Strathclyde Business School G4 0QU Glasgow 199 Scotland | Scotland | British | 77076440002 | |||||||||
| SAYLES, Helen Elizabeth Russell | Administrateur | Lanes End MA 01742 Concord 95 Massachusetts United States | United States | American | 210132270001 | |||||||||
| VAN DER KUYL, Christiaan Richard David | Administrateur | 30 & 34 Reform Street DD1 1RJ Dundee Blackadders Angus United Kingdom | Scotland | British | 45567930004 | |||||||||
| PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED | Administrateur | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom |
| 142521290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ENTREPRENEURIAL SCOTLAND GROUP LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Mr Alexander Kennedy | 06 avr. 2016 | Cathedral Street Strathclyde Business School G4 0QU Glasgow 199 Scotland | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0