Andrew Christopher LAPPING - Page 4
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Andrew |
Deuxième prénom | Christopher |
Nom de famille | LAPPING |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 9 |
Inactif | 93 |
Démissionné | 93 |
Total | 195 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVER TRAVEL ADVISOR LIMITED | 06 déc. 2012 | 22 déc. 2020 | Active | Director | Administrateur | Hurst Road Milford On Sea SO41 0PY Lymington 9b Hampshire England | United Kingdom | British |
BLACKFORD MEDIA LLP | 16 nov. 2004 | 05 avr. 2020 | Dissoute | Membre de la LLP | Hindley House Hindley NH43 7SA Stocksfield | United Kingdom | ||
MAYBURY MEDIA LLP | 11 août 2003 | 05 avr. 2019 | Dissoute | Membre de la LLP | Hindley House Hindley NH43 7SA Stocksfield | United Kingdom | ||
ST JAMES MEDIA LLP | 14 mars 2003 | 05 avr. 2019 | Dissoute | Membre de la LLP | Hindley House Hindley NH43 7SA Stocksfield | United Kingdom | ||
PRINCES STREET SUITES LIMITED | 06 févr. 2004 | 01 avr. 2019 | Active | Director | Administrateur | Hindley House Hindley Estate NE43 7SA Stocksfield Northumberland | United Kingdom | British |
GRACE DARLING HOLIDAYS LIMITED | 11 févr. 2008 | 19 févr. 2019 | Dissoute | Director | Administrateur | Hindley House Hindley Estate NE43 7SA Stocksfield Northumberland | United Kingdom | British |
CORBRIDGE DUCKHOUSE LLP | 03 oct. 2017 | 18 janv. 2018 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Hindley NE43 7SA Stocksfield Hindley House Northumberland | United Kingdom | ||
SRT MARINE SYSTEMS PLC | 20 sept. 2005 | 17 août 2017 | Active | Director | Administrateur | Hindley House Hindley Estate NE43 7SA Stocksfield Northumberland | United Kingdom | British |
NETPLAY TV LIMITED | 01 févr. 2007 | 31 mars 2017 | Dissoute | Director | Administrateur | 80 Silverthorne Road SW8 3HE London Battersea Studios United Kingdom | United Kingdom | British |
IMPRIMATUR CAPITAL LIMITED | 18 août 2015 | 06 févr. 2017 | Dissoute | Director | Administrateur | Golders Green NW11 8ED London 10-14 Accommodation Road United Kingdom | United Kingdom | British |
HINDLEY ASHWOOD COURT LTD | 29 juil. 2015 | 04 août 2016 | Active | Director | Administrateur | Ground Floor 120 Bothwell Street G2 7JS Glasgow The Aurora Building | United Kingdom | British |
REGENCY GUEST SERVICES LIMITED | 10 juin 2016 | 10 juin 2016 | Dissoute | Director | Administrateur | Bothwell Street G2 7JS Glasgow The Aurora Building Scotland | United Kingdom | British |
HYPERDRIVE INNOVATION HOLDINGS LIMITED | 27 janv. 2016 | 30 mars 2016 | Active | Director | Administrateur | Barmston Court Nissan Way SR5 3NY Sunderland Future Technology Centre Tyne And Wear United Kingdom | United Kingdom | British |
PWC ASSEMBLIES LIMITED | 22 mai 2014 | 19 août 2015 | Dissoute | Director | Administrateur | Cottage 35a North Street DL17 8HX Ferryhill Dunelm County Durham | United Kingdom | British |
AANE REALISATIONS (NE) LIMITED | 22 mai 2014 | 19 août 2015 | Dissoute | Director | Administrateur | Gurney Way DL5 6UJ Newton Aycliffe Dpe Automotive Limited County Durham England | United Kingdom | British |
DPE HOLDINGS LIMITED | 22 mai 2014 | 19 août 2015 | Dissoute | Director | Administrateur | Gurney Way DL5 6UJ Newton Aycliffe Dpe Holdings Limited County Durham England | United Kingdom | British |
DPE AUTO ENGINEERING GROUP LIMITED | 22 mai 2014 | 19 août 2015 | Dissoute | Director | Administrateur | Gurney Way Newton Aycliffe DL5 6UJ County Durham Dpe Auto Engineering Group Limited United Kingdom | United Kingdom | British |
ARDOCH LLP | 01 juil. 2015 | 01 juil. 2015 | Dissoute | Membre de la LLP | c/o Hamilton Capital Partners 120 Bothwell Street G2 7JS Glasgow The Aurora Building | United Kingdom | ||
SANTON INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED | 06 nov. 2014 | 13 mai 2015 | Active | None | Administrateur | Hindley NE43 7SA Stocksfield Hindley House Northumberland United Kingdom | United Kingdom | British |
MAVEN INCOME AND GROWTH VCT 4 PLC | 01 sept. 2004 | 29 avr. 2015 | Active | Director | Administrateur | Hindley House Hindley Estate NE43 7SA Stocksfield Northumberland | United Kingdom | British |
CLIPPENS DEVELOPMENTS LIMITED | 05 déc. 2005 | 04 déc. 2013 | Dissoute | Director | Administrateur | Hindley House Hindley Estate NE43 7SA Stocksfield Northumberland | United Kingdom | British |
B L DEVELOPMENTS (PORTOBELLO) LIMITED | 08 nov. 2005 | 04 déc. 2013 | Dissoute | Director | Administrateur | Hindley House Hindley Estate NE43 7SA Stocksfield Northumberland | United Kingdom | British |
BDL SELECT HOTELS LIMITED | 09 janv. 2013 | 22 août 2013 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Commerce Road TW8 8GA Brentford C/O Redefine Bdl Hotels Middlesex England | United Kingdom | British |
YORKHILL INVESTMENTS LIMITED | 02 nov. 2000 | 10 juin 2013 | Active | Director | Administrateur | Hindley House Hindley Estate NE43 7SA Stocksfield Northumberland | United Kingdom | British |
RAMCORE OPERATIONS (TWO) LIMITED | 09 juin 2008 | 26 févr. 2013 | Active | Director | Administrateur | Hindley House Hindley Estate NE43 7SA Stocksfield Northumberland | United Kingdom | British |
RAMCORE HOTELS LIMITED | 27 mars 2007 | 26 févr. 2013 | Active | Accountant | Administrateur | Hindley House Hindley Estate NE43 7SA Stocksfield Northumberland | United Kingdom | British |
RAMCORE OPERATIONS LIMITED | 27 mars 2007 | 26 févr. 2013 | Active | Accountant | Administrateur | Hindley House Hindley Estate NE43 7SA Stocksfield Northumberland | United Kingdom | British |
GHT DEVELOPMENTS LLP | 30 mars 2006 | 20 oct. 2012 | Active | Membre désigné de la LLP | Hindley House Hindley NH43 7SA Stocksfield | United Kingdom | ||
MOTHERWELL FOOTBALL AND ATHLETIC CLUB LIMITED (THE) | 29 mars 1999 | 20 juin 2012 | Active | Finance Director | Administrateur | Hindley House Hindley Estate NE43 7SA Stocksfield Northumberland | United Kingdom | British |
HINDLEY INVESTMENTS LIMITED | 01 sept. 2006 | 06 janv. 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Hindley House Hindley Estate NE43 7SA Stocksfield Northumberland | United Kingdom | British |
HINDLEY INVESTMENTS LIMITED | 01 sept. 2006 | 06 janv. 2012 | Dissoute | Secrétaire | Hindley House Hindley Estate NE43 7SA Stocksfield Northumberland | British | ||
LODGE SS LIMITED | 11 juil. 2008 | 20 sept. 2011 | Active | Director | Administrateur | Hindley House Hindley Estate NE43 7SA Stocksfield Northumberland | United Kingdom | British |
SANDBANK DEVELOPMENTS LLP | 16 mars 2005 | 01 avr. 2011 | Dissoute | Membre de la LLP | Hindley House Hindley NH43 7SA Stocksfield | United Kingdom | ||
WATERSIDE (N.M.) LIMITED | 30 janv. 2009 | 28 mars 2011 | Active | Director | Administrateur | Hindley House Hindley Estate NE43 7SA Stocksfield Northumberland | United Kingdom | British |
BDL SELECT HOTELS LIMITED | 03 avr. 2008 | 26 mars 2010 | Dissoute | Director | Administrateur | Hindley House Hindley Estate NE43 7SA Stocksfield Northumberland | United Kingdom | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0