WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED - Page 7
Dirigeant de société
Nom | WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 6 |
Inactif | 51 |
Démissionné | 183 |
Total | 240 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
WILMOT WEALTH MANAGEMENT LIMITED | 18 mai 2010 | 30 juin 2010 | Dissoute | Secrétaire | Town Hall Square DN31 1HE Grimsby New Oxford House North East Lincolnshire |
DIVERSE EMPLOYMENT LIMITED | 18 mai 2010 | 26 mai 2010 | Dissoute | Secrétaire | Town Hall Square DN31 1HE Grimsby New Oxford House North East Lincolnshire |
DE SERIO LIMITED | 27 avr. 2010 | 06 mai 2010 | Dissoute | Secrétaire | Town Hall Square DN31 1HE Grimsby New Oxford House South Humberside |
ALDERFORCE NORTH LIMITED | 17 févr. 2010 | 21 avr. 2010 | Active | Secrétaire | Town Hall Square DN31 1HE Grimsby New Oxford House North East Lincolnshire |
JSRO LIMITED | 09 avr. 2010 | 14 avr. 2010 | Active | Secrétaire | Town Hall Square DN31 1HE Grimsby New Oxford House North East Lincolnshire |
N V (ALFORD) LIMITED | 17 févr. 2010 | 02 avr. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Town Hall Square DN31 1HE Grimsby New Oxford House North East Lincolnshire |
H V ACCOUNTANCY LIMITED | 16 oct. 2009 | 03 févr. 2010 | Active | Secrétaire | Town Hall Square DN31 1HE Grimsby New Oxford House North East Lincolnshire |
TATTERSHALL KART CENTRE LIMITED | 16 oct. 2009 | 15 déc. 2009 | Active | Secrétaire | Town Hall Square DN31 1HE Grimsby New Oxford House North East Lincolnshire |
ZEST CREATIVE ARTS LIMITED | 08 oct. 2009 | 23 oct. 2009 | Dissoute | Secrétaire | Town Hall Square DN31 1HE Grimsby New Oxford House South Humberside |
JPL LIVE! LTD | 27 oct. 2003 | 14 mai 2008 | Dissoute | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
HUMBER DIGIVISION LIMITED | 03 mai 2005 | 03 mai 2008 | Active | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
BARROWDEN AND WAKERLEY COMMUNITY SHOP LIMITED | 06 mars 2006 | 06 mars 2006 | Active | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
LINX PICTURES INTERNATIONAL LIMITED | 09 sept. 2003 | 16 déc. 2005 | Dissoute | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
MINSTER VETERINARY CENTRE LIMITED | 06 avr. 2005 | 06 avr. 2005 | Active | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
TOPAZ GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED | 10 janv. 2005 | 04 févr. 2005 | Active | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
45 CADOGAN PLACE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 10 mai 2004 | 31 août 2004 | Active | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
ASSURED HEALTH AND SAFETY LIMITED | 11 mars 2003 | 11 mars 2003 | Dissoute | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
FAIRBANK HALL LIMITED | 29 août 2002 | 25 sept. 2002 | Active | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
YOUNGS BLUECREST PENSION TRUSTEES LIMITED | 18 juin 2002 | 20 août 2002 | Active | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
IMMAGE STUDIOS LIMITED | 24 nov. 1997 | 28 mars 2002 | Dissoute | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
BARFORD BUILDERS LTD | 03 avr. 2001 | 29 oct. 2001 | Dissoute | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
GRIMSBY COMPANY 1 LTD | 11 oct. 2001 | 15 oct. 2001 | Dissoute | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
MIZA PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED | 02 mai 2001 | 29 août 2001 | Dissoute | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
SUNTRAP (GRIMSBY) LIMITED | 02 août 1999 | 15 août 2001 | Dissoute | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
JOHN TURNER BUTCHER BAKER SANDWICH MAKER LIMITED | 03 avr. 2001 | 19 juil. 2001 | Liquidation | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
ENDOTEC LIMITED | 03 avr. 2001 | 29 juin 2001 | Active | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
CAM SHIPPING LIMITED | 01 mars 1997 | 03 avr. 2001 | Dissoute | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
TS & S GLOBAL LIMITED | 02 mai 2000 | 23 mai 2000 | Dissoute | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
THURLBY ST HUGHS MANAGEMENT CO LTD | 01 sept. 1997 | 07 août 1998 | Active | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
MCE VALVE SERVICES LTD | 03 avr. 1998 | 14 avr. 1998 | Dissoute | Secrétaire | PO BOX 16 New Oxford House Town Hall Square DN31 1HE Grimsby North East Lincolnshire |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0