Paul Andrew BROWN - Page 2
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Paul |
Deuxième prénom | Andrew |
Nom de famille | BROWN |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 5 |
Inactif | 55 |
Démissionné | 53 |
Total | 113 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYO DESPATCH LIMITED | 10 sept. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 9 St Bartholomews Close Cresswell NE61 5JX Morpeth Northumberland | British | |||
INTRUDER DETECTION & SURVEILLANCE LTD. | 03 mai 2003 | Active | Secrétaire | Waterside Drive Metro East Business Park NE11 9HU Gateshead Unit One Tyne & Wear | British | |||
ARB ENGINEERING OPERATIVE LIMITED | 21 janv. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 9 St Bartholomews Close Cresswell NE61 5JX Morpeth Northumberland | British | |||
GARY WOOD LTD | 15 janv. 2003 | Dissoute | Secrétaire | c/o Essell Accountants Howard Street NE30 1AR North Shields 29 Tyne And Wear England | British | |||
D L S (N.E) LTD | 14 janv. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 9 Oldgate NE61 1PY Morpeth Tower Buildings Northumberland England | British | |||
PARTNORTH LIMITED | 20 déc. 2002 | Dissoute | Secrétaire | Old Elvet DH1 3HN Durham 26a England | British | |||
J K PROPERTY MAINTENANCE LTD | 25 oct. 2002 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | C/O P A Brown & Co 4 Tyne View NE15 8DE Lemington Newcastle Upon Tyne | British | ||
SPOT GROUP UK LTD | 29 juil. 2002 | Dissoute | Secrétaire | C/O Pa Brown & Co 4 Tyne View NE15 8DE Lemington Newcastle Upon Tyne | British | |||
IKON PROPERTIES LTD | 12 avr. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 9 St Bartholomews Close Cresswell NE61 5JX Morpeth Northumberland | British | |||
APPLIED MEASUREMENT AND CONTROL LTD | 25 mars 2002 | Dissoute | Secrétaire | c/o P A Brown & Co 9 Oldgate NE61 1PY Morpeth Tower Buildings Northumberland England | British | |||
USA INVESTMENTS LTD | 15 mars 2002 | Dissoute | Secrétaire | Mayford House Old Elvet DH1 3HN Durham Suite 2 | British | |||
SCOTT HEATING SERVICES LTD | 13 mars 2002 | Dissoute | Secrétaire | 9 St Bartholomews Close Cresswell NE61 5JX Morpeth Northumberland | British | |||
OROTAVA NOMINEES LTD | 11 mars 2002 | Dissoute | Secrétaire | C/O P A Brown & Co Ltd 4 Tyne View NE15 8DE Lemington Newcastle Upon Tyne | British | |||
ACORNFORD (KENSINGTON) LIMITED | 01 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 4th Floor NE1 1PG Cathedral Buildings C/O Begbies-Traynor (Central)Llp Newcastle Upon Tyne | British | |||
P A BROWN & COMPANY LTD | 05 mars 2001 | Active | Accountant | Secrétaire | Abbey Meadows NE61 2BD Morpeth 16 England | British | ||
P A BROWN & COMPANY LTD | 05 mars 2001 | Active | Accountant | Administrateur | Abbey Meadows NE61 2BD Morpeth 16 England | England | British | |
CARNIVORES LIMITED | 05 déc. 2000 | Dissoute | Secrétaire | Abbey Meadows NE61 2BD Morpeth 16 England | British | |||
WHEELERS AUTO CENTRE LIMITED | 06 sept. 2000 | Dissoute | Secrétaire | Front Street Seaton Burn NE13 6EN Newcastle Upon Tyne 88 England | British | |||
MOUNTJOY TECHNOLOGIES LTD | 19 juin 2000 | Dissoute | Secrétaire | C/O P A Brown & Co Ltd 4 Tyne View NE15 8DE Lemington Newcastle Upon Tyne | British | |||
SPOT ON DISPLAYS LTD | 22 mai 2000 | Dissoute | Secrétaire | Cathedral Buildings Dean Street NE1 1PG Newcastle Upon Tyne 4th Floor | British | |||
CHESTERFORD ASHBOURNE LTD | 04 mai 2000 | Dissoute | Secrétaire | Mayford House Old Elvet DH1 3HN Durham Suite 2 United Kingdom | British | |||
ALBANY FINE CHINA LIMITED | 15 oct. 1999 | Dissoute | Secrétaire | c/o P A Brown & Co 9 Oldgate NE61 1PY Morpeth Tower Buildings Northumberland England | British | |||
LONDON & REGIONAL DEVELOPMENTS (CARE HOMES) LIMITED | 05 mars 1999 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | 4 Tyne View Lemington NE15 8DE Newcastle Upon Tyne C/O P A Brown & Co | British | ||
CHESTERFORD PROPERTIES LIMITED | 20 févr. 1999 | Dissoute | Secrétaire | 9 St Bartholomews Close Cresswell NE61 5JX Morpeth Northumberland | British | |||
ASTILBE LIMITED | 10 févr. 1998 | Dissoute | Secrétaire | Gosforth Park Avenue NE12 8EG Newcastle Rmt | British | |||
IDS FIRE AND SECURITY (CUMBRIA) LTD | 02 sept. 2003 | 17 juil. 2024 | Active | Secrétaire | Abbey Meadows NE61 2BD Morpeth 16 England | British | ||
KARENIC COMMUNICATIONS LIMITED | 26 févr. 2007 | 16 juil. 2024 | Active | Secrétaire | Abbey Meadows NE61 2BD Morpeth 16 England | British | ||
MAYFORD EQUITIES LIMITED | 01 déc. 2005 | 16 juil. 2024 | Active | Secrétaire | Old Elvet DH1 3HN Durham 26a England | British | ||
TYNEDEX LIMITED | 30 sept. 2002 | 16 juil. 2024 | Active | Accountant | Secrétaire | Old Elvet DH1 3HN Durham 26a England | British | |
LANGLEY MOOR B3 LTD. | 07 févr. 2000 | 16 juil. 2024 | Active | Secrétaire | Old Elvet DH1 3HN Durham 26a England | British | ||
WILLOUGHBY (465) LIMITED | 14 janv. 2004 | 16 juil. 2024 | Dissoute | Secrétaire | Old Elvet DH1 3HN Durham 26a England | British | ||
HEALTH PARTNERSHIPS LTD | 29 juil. 2014 | 10 juil. 2024 | Active | Accountant | Administrateur | Old Elvet DH1 3HN Durham 26a England | England | British |
HEALTH PARTNERSHIPS LTD | 01 août 2005 | 10 juil. 2024 | Active | Accountant | Secrétaire | Old Elvet DH1 3HN Durham 26a England | British | |
M2 MANAGEMENT SERVICES LTD. | 21 mai 1999 | 30 janv. 2024 | Active | Secrétaire | Abbey Meadows NE61 2BD Morpeth 16 England | British | ||
LONDON & REGIONAL CAPITAL LTD | 05 mars 1999 | 30 janv. 2024 | Active | Accountant | Secrétaire | Abbey Meadows NE61 2BD Morpeth 16 England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0