Deborah Mary VELLEMAN - Page 5
Personne physique
Titre | Mrs |
---|---|
Prénom | Deborah |
Deuxième prénom | Mary |
Nom de famille | VELLEMAN |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 2 |
Démissionné | 198 |
Total | 200 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 BATHWICK STREET (BATH) MANAGEMENT CO. LIMITED | 21 janv. 2009 | 01 janv. 2014 | Active | Secrétaire | Gay Street BA1 2PH Bath 6 England | British | ||
11 KENSINGTON PLACE BATH LIMITED | 01 déc. 2008 | 13 déc. 2013 | Active | Secrétaire | Gay Street BA1 2PH Bath 6 Avon United Kingdom | British | ||
27/28, ROYAL CRESCENT, BATH LIMITED | 01 mai 2008 | 26 juil. 2013 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 2PH Bath 6 Avon | British | ||
19 HENRIETTA STREET BATH MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 02 déc. 2003 | 29 avr. 2013 | Active | Secrétaire | Gay Street BA1 2PH Bath 6 Avon United Kingdom | British | ||
COLUMBUS HOUSE LIMITED | 24 mars 2000 | 27 mars 2013 | Active | Secrétaire | 6 Gay Street Bath BA1 2PH Avon | British | ||
LINCOTT VIEW MANAGEMENT LIMITED | 01 févr. 2005 | 28 févr. 2013 | Dissoute | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
GROUNDRATE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 01 déc. 1999 | 30 janv. 2013 | Active | Secrétaire | 6 Gay Street Bath BA1 2PH Avon | British | ||
WEST HOUSE BATHAMPTON MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 06 janv. 2003 | 01 juin 2012 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
5 PERCY PLACE BATH MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 19 juin 2006 | 07 mai 2012 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
17/18 BROAD STREET (BATH) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 01 févr. 2006 | 05 avr. 2012 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
ST NONS APARTMENTS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 26 janv. 2004 | 31 mars 2012 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
16 HENRIETTA STREET (BATH) LIMITED | 15 mai 2007 | 31 janv. 2012 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
SEVENTEEN CATHARINE PLACE (BATH) MANAGEMENT LIMITED | 01 févr. 2005 | 30 juil. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
THE SAWMILLS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 01 févr. 2008 | 30 juin 2011 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
THE SAWMILLS APARTMENTS COMPANY LIMITED | 01 févr. 2008 | 30 juin 2011 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
MONTE MANSIONS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 01 sept. 2008 | 31 déc. 2010 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
5 RIVERS STREET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 02 mai 2008 | 06 juil. 2010 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
3 MONTPELIER (BATH) LIMITED | 06 juil. 2006 | 27 avr. 2010 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
24 NEW KING STREET (BATH) LIMITED | 01 févr. 2001 | 18 mars 2010 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
LAMBRIDGE GRANGE, LOWER SWAINSWICK, BATH LIMITED | 01 nov. 2000 | 02 mars 2010 | Dissoute | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
CAREY COURT RESIDENTS MANAGEMENT LIMITED | 01 août 2005 | 04 févr. 2010 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
RACKVERNAL COURT MANAGEMENT LIMITED | 01 juin 2004 | 22 oct. 2009 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
NEW WORKSHOPS LIMITED | 22 nov. 2004 | 19 oct. 2009 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
SOMER COURT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 21 nov. 2002 | 02 oct. 2009 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
3 LANSDOWN PLACE WEST (BATH) LIMITED | 01 févr. 2004 | 12 août 2009 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
11 CAVENDISH CRESCENT (BATH) LIMITED | 09 juil. 2003 | 30 avr. 2009 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
SUTTON COURT RESIDENTS LIMITED | 01 avr. 2002 | 30 avr. 2009 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
CHATHAM PARK ESTATE MANAGEMENT COMPANY LIMITED(THE) | 01 avr. 1998 | 31 mars 2009 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
HAMILTON HOUSE MANAGEMENT (BATH) LIMITED | 01 févr. 2007 | 26 févr. 2009 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
3-5 CAVENDISH CRESCENT (BATH) LIMITED | 11 juin 1997 | 31 janv. 2009 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
AVONDALE FACILITIES LIMITED | 09 mars 2007 | 08 janv. 2009 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
AUDLEY LODGE RESIDENTS LIMITED | 01 oct. 2003 | 04 janv. 2009 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
7 EDWARD STREET BATHWICK MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 19 juin 1996 | 31 déc. 2008 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
ST. NICHOLAS HOUSE MANAGEMENT (BATH) LIMITED | 13 nov. 2000 | 03 déc. 2008 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British | ||
WALCOT BUILDINGS (BATH) LIMITED | 19 avr. 2001 | 07 oct. 2008 | Active | Secrétaire | Gay Street BA2 6PH Bath 6 Avon | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0