Michael James Wallace ASHLEY - Page 7
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Michael |
Deuxième prénom | James Wallace |
Nom de famille | ASHLEY |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 10 |
Inactif | 19 |
Démissionné | 194 |
Total | 223 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGROVE DEVELOPMENTS LIMITED | 29 mai 2014 | 01 avr. 2015 | Active | Director | Administrateur | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | England | British |
SPORTSDIRECT.COM MEDIA LIMITED | 11 juil. 2014 | 26 sept. 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | England | British |
HARGREAVES (SPORTS) LIMITED | 31 déc. 2013 | 20 août 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | England | British |
STIRLINGS (ARGYLE STREET) LIMITED | 08 févr. 2007 | 31 oct. 2012 | Active | Company Director | Administrateur | The Windsor Charter Close S44 5LU Glapwell 6 Derbyshire England | England | British |
SPORTS DIRECT HOLDINGS LIMITED | 04 janv. 2008 | 10 juin 2011 | Active | Director | Administrateur | The Windsor Charter Close S44 5LU Glapwell 6 Derbyshire England | England | British |
SDI PROPERTIES (WIGAN) LIMITED | 01 févr. 2010 | 02 févr. 2010 | Dissoute | Director | Administrateur | The Windsor Charter Close S44 5LU Glapwell 6 Derbyshire England | England | British |
ETAIL SERVICES LIMITED | 07 juin 2004 | 22 déc. 2009 | Active | Director | Administrateur | The Windsor Charter Close S44 5LU Glapwell 6 Derbyshire England | England | British |
EXSPORTS LIMITED | 24 mai 2001 | 27 oct. 2008 | Dissoute | Director | Administrateur | The Windsor Charter Close S44 5LU Glapwell 6 Derbyshire England | England | British |
BRAINS INC LIMITED | 14 déc. 1998 | 13 sept. 2007 | Dissoute | Director | Administrateur | Hamberlins Tring Road Northchurch Dudswell HP4 3TL Berkhamsted Hertfordshire | British | |
DUNLOP INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 30 juin 2004 | 31 juil. 2007 | Active | Company Director | Administrateur | Hamberlins Tring Road Northchurch Dudswell HP4 3TL Berkhamsted Hertfordshire | British | |
BRANDS 001 LIMITED | 31 janv. 2005 | 31 janv. 2005 | Active | Retail Director | Administrateur | Hamberlins Tring Road Northchurch Dudswell HP4 3TL Berkhamsted Hertfordshire | British | |
BRANDS INC LIMITED | 06 févr. 2002 | 31 mars 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | Hamberlins Tring Road Northchurch Dudswell HP4 3TL Berkhamsted Hertfordshire | British | |
0353 H ST REDCAR (FREEHOLDCO) LIMITED | 14 sept. 1992 | 15 juil. 1995 | Active | Director | Secrétaire | Hamberlins Tring Road Northchurch Dudswell HP4 3TL Berkhamsted Hertfordshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0