Allan Leigh WOOD
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Allan |
| Deuxième prénom | Leigh |
| Nom de famille | WOOD |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 1 |
| Inactif | 3 |
| Démissionné | 25 |
| Total | 29 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARDVARNA INVESTMENT CAPITAL LIMITED | 05 mai 2011 | Dissoute | Administrateur | c/o Ernst & Young Llp Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place Yorkshire | England | British | ||
| WCI GROUP TRUSTEE COMPANY LIMITED | 20 juin 2005 | Dissoute | Administrateur | Sherborne House Milton Lilbourne SN9 5LQ Pewsey Wiltshire | England | British | ||
| HWH PLUS LIMITED | 30 sept. 2004 | Dissoute | Administrateur | Sherborne House Milton Lilbourne SN9 5LQ Pewsey Wiltshire | England | British | ||
| THE AUGUSTA FILM LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | 22 sept. 2003 | Active | Membre de la LLP | Sherbourne House Milton Lilbourne SN9 5LQ Pewsey | England | |||
| LIBERATA UK LIMITED | 01 févr. 2017 | 31 déc. 2024 | Active | Administrateur | 2nd Floor Front 60 Cheapside EC2V 6AX London 60 Cheapside England | England | British | |
| ECLIPSE FILM PARTNERS NO. 22 LLP | 24 juil. 2006 | 13 févr. 2024 | Dissoute | Membre de la LLP | Sherbourne House Milton Lilbourne SN9 5LQ Pewsey | England | ||
| INDIGO IT TOPCO LIMITED | 19 déc. 2016 | 29 déc. 2021 | Dissoute | Administrateur | Lees Street Swinton M27 6DB Manchester Lowry Mill England | England | British | |
| HVIVO PLC | 20 sept. 2016 | 11 déc. 2018 | Active | Administrateur | Railway Road Dalkey Dublin 19 Ireland | England | British | |
| OXEHEALTH LIMITED | 01 mai 2013 | 30 août 2017 | Active | Administrateur | 103 Clarendon Road LS2 9DF Leeds Leeds Inovation Centre West Yorkshire Uk | England | British | |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | 28 mai 2015 | 21 juin 2016 | Active | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | |
| DECAF BRIOCHE ONE LTD | 29 août 2014 | 03 mai 2016 | Dissoute | Administrateur | Brownsover Road CV21 1HL Rugby Boughton Leigh House Warwickshire England | England | British | |
| DECAF BRIOCHE THREE LTD | 29 août 2014 | 03 mai 2016 | Dissoute | Administrateur | Brownsover Road CV21 1HL Rugby Boughton Leigh House Warwickshire England | England | British | |
| DECAF BRIOCHE FIVE LTD | 15 août 2011 | 03 mai 2016 | Dissoute | Administrateur | Brownsover Road CV21 1HL Rugby Boughton Leigh House Warwickshire England | England | British | |
| DECAF BRIOCHE TWO LTD | 15 août 2011 | 03 mai 2016 | Dissoute | Administrateur | Brownsover Road CV21 1QL Rugby Boughton Leigh House Warwickshire | England | British | |
| HEALTHCARE HOMES HOLDINGS LIMITED | 01 févr. 2013 | 09 juin 2015 | Active | Administrateur | Lodge Lane Langham CO4 5NE Colchester Lodge House Essex | England | British | |
| DECAF BRIOCHE ONE LTD | 15 août 2011 | 29 août 2014 | Dissoute | Administrateur | Brownsover Road CV21 1QL Rugby Boughton Leigh House Warwickshire England | England | British | |
| PRACTICE PLUS GROUP URGENT CARE HOLDINGS LIMITED | 15 mars 2006 | 05 nov. 2012 | Active | Administrateur | Sherborne House Milton Lilbourne SN9 5LQ Pewsey Wiltshire | England | British | |
| PRACTICE PLUS GROUP URGENT CARE LIMITED | 01 juin 2005 | 04 août 2009 | Active | Administrateur | Sherborne House Milton Lilbourne SN9 5LQ Pewsey Wiltshire | England | British | |
| NAVITAS LIFE SCIENCES LIMITED | 09 avr. 2005 | 05 déc. 2008 | Active | Administrateur | Sherborne House Milton Lilbourne SN9 5LQ Pewsey Wiltshire | England | British | |
| CANACCORD GENUITY FINANCIAL PLANNING LIMITED | 12 avr. 2006 | 01 déc. 2008 | Active | Administrateur | Sherborne House Milton Lilbourne SN9 5LQ Pewsey Wiltshire | England | British | |
| AMICUS ITS LIMITED | 30 sept. 2004 | 27 avr. 2006 | Active | Administrateur | Sherborne House Milton Lilbourne SN9 5LQ Pewsey Wiltshire | England | British | |
| SOPRA STERIA LIMITED | 26 avr. 2001 | 29 févr. 2004 | Active | Administrateur | Sherborne House Milton Lilbourne SN9 5LQ Pewsey Wiltshire | England | British | |
| GAMUT TECHNOLOGIES LIMITED | 31 mai 2000 | 29 févr. 2004 | Dissoute | Administrateur | Sherborne House Milton Lilbourne SN9 5LQ Pewsey Wiltshire | England | British | |
| DELTAWORTH LIMITED | 31 mai 2000 | 29 févr. 2004 | Dissoute | Administrateur | Sherborne House Milton Lilbourne SN9 5LQ Pewsey Wiltshire | England | British | |
| DRUID GROUP LIMITED | 01 oct. 1997 | 29 févr. 2004 | Dissoute | Administrateur | Sherborne House Milton Lilbourne SN9 5LQ Pewsey Wiltshire | England | British | |
| DRUID SYSTEMS LIMITED | 01 oct. 1997 | 29 févr. 2004 | Dissoute | Administrateur | Sherborne House Milton Lilbourne SN9 5LQ Pewsey Wiltshire | England | British | |
| SOPRA STERIA UK CORPORATE LIMITED | 10 mars 2000 | 28 janv. 2004 | Active | Administrateur | Sherborne House Milton Lilbourne SN9 5LQ Pewsey Wiltshire | England | British | |
| GAMUT TECHNOLOGIES LIMITED | 28 janv. 1999 | 10 mai 1999 | Dissoute | Administrateur | 22 St Andrews Close RG45 6UP Crowthorne Berkshire | British | ||
| DELTAWORTH LIMITED | 09 déc. 1993 | 25 nov. 1997 | Dissoute | Administrateur | 22 St Andrews Close RG45 6UP Crowthorne Berkshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0