• Données
  • Grande-Bretagne
  • Entreprises
  • Rechercher des entreprises
  • Sanctions
  • Rechercher des sanctions
  • Anne STEELE - Page 3

    Personne physique

    TitreMrs
    PrénomAnne
    Nom de familleSTEELE
    Date de naissance
    Est un dirigeant de sociétéNon
    Nominations
    Actif5
    Inactif31
    Démissionné157
    Total193

    Nominations

    Dirigeants nommés
    Nommé(e) àDate de nominationDate de démissionStatut de la sociétéProfessionRôleAdressePays de résidenceNationalité
    DS SMITH INTERNATIONAL LIMITED28 juin 201331 oct. 2018ActiveChartered SecretaryAdministrateur
    Euston Road
    NW1 3AX London
    350
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    DSS EASTERN EUROPE LIMITED28 juin 201331 oct. 2018ActiveChartered SecretaryAdministrateur
    Euston Road
    NW1 3AX London
    350
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    DS SMITH ITALY LIMITED28 juin 201331 oct. 2018ActiveChartered SecretaryAdministrateur
    Euston Road
    NW1 3AX London
    350
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    MULTIGRAPHICS HOLDINGS LIMITED28 juin 201331 oct. 2018ActiveChartered SecretaryAdministrateur
    Euston Road
    NW1 3AX London
    350
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    CONEW LIMITED28 juin 201331 oct. 2018ActiveChartered SecretaryAdministrateur
    Euston Road
    NW1 3AX London
    350
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    DS SMITH EURO FINANCE LIMITED28 juin 201331 oct. 2018ActiveChartered SecretaryAdministrateur
    Euston Road
    NW1 3AX London
    350
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    MILJOINT LIMITED28 juin 201331 oct. 2018ActiveChartered SecretaryAdministrateur
    Euston Road
    NW1 3AX London
    350
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    THEBANNERPEOPLE.COM LIMITED28 juin 201331 oct. 2018ActiveChartered SecretaryAdministrateur
    Euston Road
    NW1 3AX London
    350
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    THE DS SMITH CHARITABLE FOUNDATION01 juin 201131 oct. 2018ActiveChartered SecretaryAdministrateur
    Euston Road
    NW1 3AX London
    350
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    CORPLEX PLASTICS UK LTD24 mars 200931 oct. 2018ActiveChartered SecretaryAdministrateur
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United KingdomBritish
    DS SMITH HOLDINGS LIMITED03 nov. 200831 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    British
    DS SMITH FINCO LIMITED03 nov. 200831 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British
    MULTIGRAPHICS SERVICES LIMITED04 mars 200831 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British
    MULTIGRAPHICS LIMITED04 mars 200831 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British
    MULTIGRAPHICS HOLDINGS LIMITED04 mars 200831 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British
    THEBANNERPEOPLE.COM LIMITED04 mars 200831 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British
    GROVEHURST ENERGY LIMITED29 févr. 200831 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British
    DS SMITH UKRAINE LIMITED28 août 200731 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British
    DS SMITH EURO FINANCE LIMITED02 nov. 200631 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British
    CORPLEX PLASTICS UK LTD22 oct. 200431 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British
    DS SMITH PACKAGING LIMITED22 mars 200431 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British
    DS SMITH ITALY LIMITED24 avr. 200231 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Euston Road
    NW1 3AX London
    350
    United Kingdom
    British
    D.W. PLASTICS (UK) LIMITED09 juil. 200131 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British
    TREFOREST MILL PLC09 juil. 200131 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British
    ST. REGIS PAPER COMPANY LIMITED09 juil. 200131 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British
    PRIORY PACKAGING LIMITED09 juil. 200131 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    British
    ASHTON CORRUGATED09 juil. 200131 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    British
    DSSH NO.1 LIMITED09 juil. 200131 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British
    W.ROWLANDSON & COMPANY LIMITED09 juil. 200131 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British
    ST. REGIS KEMSLEY LIMITED09 juil. 200131 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    British
    WADDINGTON & DUVAL LIMITED09 juil. 200131 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British
    DS SMITH SUDBROOK LIMITED09 juil. 200131 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British
    CORRUGATED PRODUCTS LIMITED09 juil. 200131 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    British
    DSS POZNAN LIMITED09 juil. 200131 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British
    UNITED SHOPPER MARKETING LIMITED09 juil. 200131 oct. 2018ActiveSecrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    British

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0