James Cameron WALL - Page 3
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | James |
Deuxième prénom | Cameron |
Nom de famille | WALL |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 24 |
Inactif | 59 |
Démissionné | 49 |
Total | 132 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORRIS (S.P.) HOLDINGS LIMITED | 05 juil. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 30 Gresham Street London EC2V 7PG | British | |||
DRESDNER KLEINWORT CAPITAL INVESTMENT TRUST LIMITED | 28 juin 2002 | Dissoute | Secrétaire | 95 Willow Park Otford TN14 5NF Sevenoaks Kent | British | |||
COMMERZBANK CAPITAL INVESTMENT COMPANY LIMITED | 28 juin 2002 | Dissoute | Chartered Secretary | Secrétaire | 30 Gresham Street London EC2V 7PG | British | ||
COMMERZBANK CAPITAL VENTURES MANAGEMENT LIMITED | 29 avr. 2002 | Dissoute | Chartered Secretary | Secrétaire | 30 Gresham Street London EC2V 7PG | British | ||
PARC CONTINENTAL LIMITED | 07 mars 2002 | Dissoute | Chartered Secretary | Secrétaire | 30 Gresham Street London EC2V 7PG | British | ||
DRESDNER KLEINWORT PARTNERSHIP 2001 LIMITED | 19 févr. 2002 | Dissoute | Chartered Secretary | Secrétaire | 30 Gresham Street London EC2V 7PG | British | ||
COMMERZBANK LEASING LIMITED | 31 janv. 2002 | Active | Secrétaire | 30 Gresham Street London EC2V 7PG | British | |||
COMMERZBANK LEASING DECEMBER (3) LIMITED | 31 janv. 2002 | Active | Secrétaire | 30 Gresham Street London EC2V 7PG | British | |||
COMMERZBANK LEASING MARCH (3) LIMITED | 31 janv. 2002 | Active | Secrétaire | 30 Gresham Street London EC2V 7PG | British | |||
COMMERZBANK LEASING DECEMBER (4) LIMITED | 31 janv. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 30 Gresham Street London EC2V 7PG | British | |||
RIVERBANK TRUSTEES LIMITED | 31 janv. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 30 Gresham Street London EC2V 7PG | British | |||
COMMERZBANK LEASING DECEMBER (1) LIMITED | 31 janv. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 30 Gresham Street London EC2V 7PG | British | |||
COMMERZBANK FINANCE LIMITED | 19 déc. 2001 | Active | Secrétaire | 30 Gresham Street London EC2V 7PG | British | |||
HERRADURA LIMITED | 28 juin 2005 | 07 janv. 2020 | Dissoute | Chartered Secretary | Administrateur | 30 Gresham Street London EC2V 7PG | United Kingdom | British |
COMMERZBANK INVESTMENTS (UK) LIMITED | 12 oct. 2009 | 02 déc. 2013 | Dissoute | Chartered Secretary | Administrateur | 30 Gresham Street London EC2V 7PG | United Kingdom | British |
O L DEC 2 LIMITED | 31 janv. 2002 | 07 déc. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Old London Road Knockholt TN14 7LU Sevenoaks Verrington House Kent | British | ||
O L DEC 16 LIMITED | 31 janv. 2002 | 07 déc. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Old London Road Knockholt TN14 7LU Sevenoaks Verrington House Kent | British | ||
ZEUS 11 LIMITED | 31 janv. 2002 | 01 juil. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 95 Willow Park Otford TN14 5NF Sevenoaks Kent | British | ||
ALLIANZ PRIVATE EQUITY UK HOLDINGS LIMITED | 19 déc. 2002 | 31 déc. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 95 Willow Park Otford TN14 5NF Sevenoaks Kent | British | ||
ALLIANZ SPECIALISED INVESTMENTS LIMITED | 29 avr. 2002 | 31 déc. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 95 Willow Park Otford TN14 5NF Sevenoaks Kent | British | ||
ALLIANZ RISK TRANSFER (U.K.) LIMITED | 02 oct. 2006 | 11 déc. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 95 Willow Park Otford TN14 5NF Sevenoaks Kent | British | ||
LEASING DECEMBER (14) LIMITED | 17 sept. 2004 | 25 sept. 2007 | Dissoute | Secrétaire | 95 Willow Park Otford TN14 5NF Sevenoaks Kent | British | ||
AMALIE PFI (UK) LIMITED | 08 mars 2006 | 09 août 2007 | Active | Secrétaire | 95 Willow Park Otford TN14 5NF Sevenoaks Kent | British | ||
KB FUND III GP LIMITED | 03 mai 2002 | 31 mars 2004 | Dissoute | Secrétaire | 95 Willow Park Otford TN14 5NF Sevenoaks Kent | British | ||
CIT EQUIPMENT FINANCE (UK) LIMITED | 07 mars 2002 | 20 déc. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 95 Willow Park Otford TN14 5NF Sevenoaks Kent | British | ||
METALMARK FINANCIAL SERVICES LIMITED | 31 janv. 2002 | 13 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 66 Blackmead Riverhead TN13 2QU Sevenoaks Kent | British | ||
BOWTHORPE LIMITED | 22 déc. 1999 | 28 févr. 2001 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 66 Blackmead Riverhead TN13 2QU Sevenoaks Kent | British | |
BOWTHORPE LIMITED | 22 déc. 1999 | 28 févr. 2001 | Active | Company Secretary | Administrateur | 66 Blackmead Riverhead TN13 2QU Sevenoaks Kent | British | |
VANTIS SECRETARIES LIMITED | 14 janv. 1993 | 18 juin 1998 | Dissoute | Company Secretary | Administrateur | 66 Blackmead Riverhead TN13 2QU Sevenoaks Kent | British | |
VANTIS SECRETARIES LIMITED | 14 janv. 1993 | 18 juin 1998 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 66 Blackmead Riverhead TN13 2QU Sevenoaks Kent | British | |
VANTIS NOMINEES LIMITED | 08 janv. 1993 | 18 juin 1998 | Dissoute | Secrétaire | 66 Blackmead Riverhead TN13 2QU Sevenoaks Kent | British | ||
9 GUILDFORD ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 31 déc. 1996 | Active | Chartered Secretary | Administrateur | Flat 4 9 Guildford Road BN1 3LU Brighton East Sussex | British | ||
9 GUILDFORD ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 12 août 1992 | 31 mars 1994 | Active | Secrétaire | Flat 4 9 Guildford Road BN1 3LU Brighton East Sussex | British | ||
TFC (UK) LIMITED | 11 févr. 1991 | 11 févr. 1994 | Dissoute | Secrétaire | Flat 4 9 Guildford Road BN1 3LU Brighton East Sussex | British | ||
FIS PENSIONS LIMITED | 22 déc. 1992 | 25 févr. 1993 | Active | Secrétaire | Flat 4 9 Guildford Road BN1 3LU Brighton East Sussex | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0