Anthony George HUNTER - Page 2
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Anthony |
Deuxième prénom | George |
Nom de famille | HUNTER |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 13 |
Inactif | 24 |
Démissionné | 40 |
Total | 77 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGONAUT MANAGEMENT LIMITED | 04 déc. 1996 | Active | Company Secretary | Administrateur | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | United Kingdom | British | |
NAUTILUS MANAGEMENT LIMITED | 29 avr. 1996 | Active | Company Secretary | Administrateur | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | United Kingdom | British | |
NATUREX LIMITED | 03 nov. 2001 | 30 avr. 2017 | Dissoute | Secrétaire | Overseal DE12 6JX Swadlincote Park Road United Kingdom | British | ||
WORKING LINKS (EMPLOYMENT) LIMITED | 31 mars 2006 | 29 juin 2016 | Liquidation | Secrétaire | 107 Hammersmith Road W14 0QH London Masters House Great Britain | British | ||
HIGHTEX GROUP PLC | 14 juil. 2006 | 27 juin 2014 | Dissoute | Secrétaire | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | British | ||
DAILY BREAD LIMITED | 01 avr. 2008 | 12 juin 2014 | Active | Secrétaire | Killingbeck Drive LS14 6UF Leeds 4 England | British | ||
HAIN FROZEN FOODS UK LIMITED | 30 août 2007 | 12 juin 2014 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Killingbeck Drive LS14 6UF Leeds 4 England | British | |
THE HAIN DANIELS GROUP LIMITED | 30 août 2007 | 12 juin 2014 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Killingbeck Drive LS14 6UF Leeds 4 England | British | |
HAIN FOODS LIMITED | 30 août 2007 | 12 juin 2014 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Killingbeck Drive LS14 6UF Leeds 4 England | British | |
A D SCIENCE LIMITED | 26 janv. 2009 | 24 avr. 2013 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 33 Wellington Street LS1 4JP Leeds Benson House West Yorkshire | British | |
AERTE LIMITED | 02 févr. 2007 | 24 avr. 2013 | Dissoute | Secrétaire | 33 Wellington Street LS1 4JP Leeds Benson House West Yorkshire | British | ||
MOVING SUN LIMITED | 05 oct. 2006 | 24 avr. 2013 | Active | Solicitor | Secrétaire | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | British | |
ENSCO 720 LIMITED | 26 janv. 2009 | 14 janv. 2013 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 107 Hammersmith Road W14 0QH London Masters House | British | |
INOV8 SCIENCE LIMITED | 26 juin 1998 | 14 janv. 2013 | Active | Secrétaire | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | British | ||
MID-STATES INVESTMENTS LIMITED | 26 juin 1998 | 14 janv. 2013 | Dissoute | Secrétaire | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | British | ||
OLD STYLUS LIMITED | 26 juin 1998 | 14 janv. 2013 | Dissoute | Secrétaire | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | British | ||
KETCHICAN LTD | 26 juin 1998 | 14 janv. 2013 | Dissoute | Solicitor | Secrétaire | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | British | |
DSC (CONSUMER PRODUCTS) LIMITED | 26 juin 1998 | 14 janv. 2013 | Dissoute | Solicitor | Secrétaire | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | British | |
JUNEAU LTD | 26 juin 1998 | 14 janv. 2013 | Dissoute | Secrétaire | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | British | ||
AERTE GROUP PLC | 26 juin 1998 | 14 janv. 2013 | Dissoute | Solicitor | Secrétaire | Hill House Richmond Hill BH2 6HR Bournemouth Pricewaterhousecoopers Llp | British | |
INSTITUTE OF PROFESSIONAL ADMINISTRATORS LIMITED | 03 oct. 2008 | 31 mars 2010 | Dissoute | Director | Administrateur | 68 Philbeach Gardens SW5 9EE London | United Kingdom | British |
LESTERS PROFESSIONAL SOLUTIONS LIMITED | 29 juil. 2002 | 28 févr. 2010 | Dissoute | Secrétaire | 3rd Floor Threshold House 65/69 Shepherds Bush Green W12 8TX London | British | ||
SYBERSOLVE SOLUTIONS LIMITED | 29 juin 2001 | 28 févr. 2010 | Active | Secrétaire | 68 Philbeach Gardens SW5 9EE London | British | ||
SYBERSOLVE LIMITED | 15 juil. 1999 | 28 févr. 2010 | Dissoute | Solicitor | Secrétaire | 68 Philbeach Gardens SW5 9EE London | British | |
THE LINKS FOUNDATION LIMITED | 05 sept. 2006 | 10 juil. 2009 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 68 Philbeach Gardens SW5 9EE London | British | |
CAPAC LIMITED | 24 oct. 2006 | 23 mars 2009 | Dissoute | Secrétaire | 68 Philbeach Gardens SW5 9EE London | British | ||
COMSCORE UK LTD | 18 oct. 2005 | 28 mai 2008 | Active | Secrétaire | 68 Philbeach Gardens SW5 9EE London | British | ||
SRC COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED | 13 sept. 2006 | 03 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 68 Philbeach Gardens SW5 9EE London | British | ||
MYRTEX RESEARCH LIMITED | 11 juil. 2000 | 01 sept. 2007 | Active | Solicitor | Secrétaire | 68 Philbeach Gardens SW5 9EE London | British | |
AMSTERDAM HEALTH LIMITED | 12 déc. 2005 | 25 janv. 2007 | Dissoute | Secrétaire | 68 Philbeach Gardens SW5 9EE London | British | ||
CAULDRON FOODS LIMITED | 05 mars 2001 | 31 oct. 2005 | Active | Secrétaire | 68 Philbeach Gardens SW5 9EE London | British | ||
NAUTILUS MANAGEMENT LIMITED | 25 avr. 2003 | 01 août 2005 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 68 Philbeach Gardens SW5 9EE London | British | |
NUTRIAD LTD | 19 oct. 1999 | 27 mai 2003 | Active | Secrétaire | 68 Philbeach Gardens SW5 9EE London | British | ||
COWAN, DE GROOT NOMINEES LIMITED | 20 avr. 2001 | 06 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 68 Philbeach Gardens SW5 9EE London | British | ||
WF HORWOOD & CO (BRISTOL) LIMITED | 20 mars 2001 | 06 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 68 Philbeach Gardens SW5 9EE London | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0