Graham Roger WHITE
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Graham |
Deuxième prénom | Roger |
Nom de famille | WHITE |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 3 |
Démissionné | 17 |
Total | 20 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKES 4 FUN LTD | 01 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | Main St Sibford Ferris OX15 5RE Banbury Home Close Oxfordshire England | British | |||
C4F LTD | 30 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire | Sibford Ferris OX15 5RE Banbury Home Close Oxfordshire England | British | |||
HEALTHSTAR INTERNET LIMITED | 08 oct. 1999 | Dissoute | Secrétaire | Fanthorpe Street SW15 1DZ London 33 | British | |||
HEALTHCARE AT HOME SPECIALITY PHARMACEUTICALS LIMITED | 14 déc. 2006 | 29 avr. 2015 | Dissoute | Finance Director | Administrateur | Fifth Avenue Centrum One Hundred DE14 2WS Burton-On-Trent | United Kingdom | British |
HEALTHCARE AT HOME SPECIALITY PHARMACEUTICALS LIMITED | 14 déc. 2006 | 17 déc. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fanthorpe Street SW15 1DZ London 33 | British | ||
MEDICINES INTELLIGENCE LIMITED | 04 janv. 2002 | 28 oct. 2008 | Active | Director | Secrétaire | Fanthorpe Street SW15 1DZ London 33 | British | |
SCIENSUS PHARMA SERVICES LIMITED | 14 janv. 1999 | 28 oct. 2008 | Active | Secrétaire | Fanthorpe Street SW15 1DZ London 33 | British | ||
ARGONAUT BIDCO LIMITED | 27 juil. 2007 | 28 oct. 2008 | Dissoute | Director | Secrétaire | Fanthorpe Street SW15 1DZ London 33 | British | |
ARGONAUT MIDCO LIMITED | 27 juil. 2007 | 28 oct. 2008 | Dissoute | Director | Secrétaire | Fanthorpe Street SW15 1DZ London 33 | British | |
INVENTIVE SOLUTIONS LTD | 05 juil. 2005 | 28 oct. 2008 | Dissoute | Company Director | Secrétaire | Fanthorpe Street SW15 1DZ London 33 | British | |
EGX LIMITED | 13 mai 2005 | 28 oct. 2008 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Fanthorpe Street SW15 1DZ London 33 | British | |
MERIDIAN PHARMASERVICES LIMITED | 23 janv. 2001 | 28 oct. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fanthorpe Street SW15 1DZ London 33 | British | ||
HEALTHCARE AT HOME TRUSTEES LIMITED | 01 sept. 1999 | 28 oct. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fanthorpe Street SW15 1DZ London 33 | British | ||
EGX GROUP LIMITED | 13 août 1999 | 28 oct. 2008 | Dissoute | Chartered Accountant | Secrétaire | Fanthorpe Street SW15 1DZ London 33 | British | |
HOSPITAL AT HOME LIMITED | 30 juin 1999 | 28 oct. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fanthorpe Street SW15 1DZ London 33 | British | ||
TELECARE LIMITED | 18 févr. 1999 | 28 oct. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fanthorpe Street SW15 1DZ London 33 | British | ||
PHARMASERVICE LIMITED | 14 déc. 1998 | 28 oct. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fanthorpe Street SW15 1DZ London 33 | British | ||
REFER2US UK LIMITED | 14 déc. 1998 | 28 oct. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fanthorpe Street SW15 1DZ London 33 | British | ||
ARGONAUT TOPCO LIMITED | 27 juil. 2007 | 08 oct. 2008 | Dissoute | Director | Secrétaire | Fanthorpe Street SW15 1DZ London 33 | British | |
EDX LIMITED | 25 juil. 2007 | 24 sept. 2007 | Dissoute | Director | Administrateur | 20 Bangalore Street SW15 1QE Putney London | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0