EGX GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEGX GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03827627
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EGX GROUP LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe EGX GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Suite A, 7th Floor
    City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Nottingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EGX GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HEALTHCARE AT HOME GROUP LIMITED13 août 199913 août 1999

    Quels sont les derniers comptes de EGX GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour EGX GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de 107 Station Street Burton-on-Trent Staffordshire DE14 1SZ England à Suite a, 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill Nottingham NG1 5FS le 25 nov. 2019

    2 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    14 pagesMR04

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 18 nov. 2019

    LRESSP

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 21 oct. 2019

    • Capital: GBP 0.00001
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduction of the share premium account to nil and reduction of the capital redemption reserve to nil 17/10/2019
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 13 août 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2018

    22 pagesAA

    Nomination de Mr John Spencer Sheridan en tant qu'administrateur le 30 août 2018

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 13 août 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Darryn Stanley Gibson en tant qu'administrateur le 23 mai 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Edward Roderick en tant que directeur le 08 juin 2018

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2017

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 août 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Mark Edward Roderick en tant qu'administrateur le 17 mai 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Matthew Stevens en tant que directeur le 17 mai 2017

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Fifth Avenue Centrum 100 Burton on Trent Staffordshire DE14 2WS à 107 Station Street Burton-on-Trent Staffordshire DE14 1SZ le 15 mai 2017

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2016

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Matthew Stevens en tant qu'administrateur le 20 avr. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Anthony Daniel Graff en tant que directeur le 20 févr. 2017

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de EGX GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRADSHAW, John
    City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Suite A, 7th Floor
    Nottingham
    Secrétaire
    City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Suite A, 7th Floor
    Nottingham
    183399280001
    BRADSHAW, John Richard
    City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Suite A, 7th Floor
    Nottingham
    Administrateur
    City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Suite A, 7th Floor
    Nottingham
    EnglandBritishSolicitor224052330001
    GIBSON, Darryn Stanley
    City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Suite A, 7th Floor
    Nottingham
    Administrateur
    City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Suite A, 7th Floor
    Nottingham
    EnglandNew ZealanderCeo245702030001
    SHERIDAN, John Spencer
    City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Suite A, 7th Floor
    Nottingham
    Administrateur
    City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Suite A, 7th Floor
    Nottingham
    EnglandBritishCfo238643210001
    ROBERTS, Sharon Mary
    6 Hillwood Road
    Four Oaks
    B75 5QL Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    6 Hillwood Road
    Four Oaks
    B75 5QL Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishAccountant78653860002
    WHITE, Graham Roger
    Fifth Avenue
    Centrum 100
    DE14 2WS Burton On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    Fifth Avenue
    Centrum 100
    DE14 2WS Burton On Trent
    Staffordshire
    181719340001
    WHITE, Graham Roger
    Fanthorpe Street
    SW15 1DZ London
    33
    Secrétaire
    Fanthorpe Street
    SW15 1DZ London
    33
    BritishChartered Accountant62438660003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BEECROFT, Paul Adrian Barlow
    13 Hampstead Hill Gardens
    NW3 2PH London
    Administrateur
    13 Hampstead Hill Gardens
    NW3 2PH London
    United KingdomBritishVenture Capital40497200002
    COHEN, Jonathan Edward
    39 Park Lane
    Roundhay
    LS8 2EH Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    39 Park Lane
    Roundhay
    LS8 2EH Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector71405040001
    FEATHERSTONE, James Michael, Dr
    Fifth Avenue
    Centrum 100
    DE14 2WS Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Fifth Avenue
    Centrum 100
    DE14 2WS Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritishCoo199344900002
    GORDON, Michael Andrew
    Fifth Avenue
    Centrum 100
    DE14 2WS Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Fifth Avenue
    Centrum 100
    DE14 2WS Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Director56076310002
    GRAFF, Anthony Daniel
    Fifth Avenue
    Centrum 100
    DE14 2WS Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Fifth Avenue
    Centrum 100
    DE14 2WS Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandEnglishCfo128576530001
    HODGSON, Jonathan Andrew
    Plumley Moor Road
    Plumley
    WA16 9SB Knutsford
    93
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Plumley Moor Road
    Plumley
    WA16 9SB Knutsford
    93
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector119903450002
    JONES, Edward Gareth, Dr
    Manor Barn
    Lyndon Road, Manton
    LE15 8SR Oakham
    Leicestershire
    Administrateur
    Manor Barn
    Lyndon Road, Manton
    LE15 8SR Oakham
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector70448220001
    POOLE, Jennifer Ruth
    1 Cleeve Court
    Downend
    BS16 6DL Bristol
    Administrateur
    1 Cleeve Court
    Downend
    BS16 6DL Bristol
    United KingdomBritishDirector70448020003
    RODERICK, Mark Edward
    Station Street
    DE14 1SZ Burton-On-Trent
    107
    Staffordshire
    England
    Administrateur
    Station Street
    DE14 1SZ Burton-On-Trent
    107
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishGroup Operations Director231004120001
    STEVENS, Matthew
    Station Street
    DE14 1SZ Burton-On-Trent
    107
    Staffordshire
    England
    Administrateur
    Station Street
    DE14 1SZ Burton-On-Trent
    107
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishCfo197656180001
    WALSH, Charles Anthony
    Flat 7 25 Luxborough Street
    W1U 5AR London
    Administrateur
    Flat 7 25 Luxborough Street
    W1U 5AR London
    EnglandIrishDirector36957990002
    WHITE, Graham Roger
    Fifth Avenue
    Centrum 100
    DE14 2WS Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Fifth Avenue
    Centrum 100
    DE14 2WS Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritishFinance Director257851790001
    WOOD, Martin Francis, Sir
    The Manor House
    Little Wittenham
    OX14 4RA Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Manor House
    Little Wittenham
    OX14 4RA Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Director72338340001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EGX GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Fifth Avenue
    Centrum One Hundred
    DE14 2WS Burton-On-Trent
    Hah Ltd
    England
    06 avr. 2016
    Fifth Avenue
    Centrum One Hundred
    DE14 2WS Burton-On-Trent
    Hah Ltd
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement5452541
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    EGX GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Group debenture
    Créé le 01 févr. 2012
    Livré le 02 févr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the security agent and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited (The “Security Agent”)
    Transactions
    • 02 févr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 31 août 2007
    Livré le 07 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nomura International PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 07 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 02 déc. 2005
    Livré le 07 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 août 2003
    Livré le 16 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    EGX GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 août 2020Dissolved on
    18 nov. 2019Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Patrick B Ellward
    Suite A 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    practitioner
    Suite A 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Adrian David Allen
    Suite A 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    practitioner
    Suite A 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0