NEWBRIDGE REGISTRARS LIMITED - Page 2
Dirigeant de société
Nom | NEWBRIDGE REGISTRARS LIMITED |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 3 |
Inactif | 29 |
Démissionné | 75 |
Total | 107 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
ILIOS TRAVEL LTD | 06 janv. 2003 | 17 févr. 2021 | Active | Secrétaire | 27 Hatchlands Road RH1 6RW Redhill Sterling House England |
AC CONSULTANCY & DEVELOPMENT LIMITED | 15 févr. 2006 | 15 févr. 2021 | Dissoute | Secrétaire | 27 Hatchland Road RH1 6RW Redhill Sterling House Surrey England |
PIE-DATA(U.K.) LIMITED | 30 juil. 2012 | 08 févr. 2021 | Active | Secrétaire | 27 Hatchlands Road RH1 6RW Redhill Sterling House Surrey England |
CHESHAM CLOSE LIMITED | 25 avr. 2005 | 15 janv. 2021 | Active | Secrétaire | 27 Hatchlands Road RH1 6RW Redhill Sterling House Surrey England |
RARE SIGN LIMITED | 04 févr. 2003 | 05 janv. 2021 | Dissoute | Secrétaire | Hatchlands Road RH1 6RW Redhill 27 England |
LANGTRON LIMITED | 06 oct. 2020 | Active | Secrétaire | 27 Hatchlands Road RH1 6RW Redhill Sterling House Surrey England | |
D.G. COLES & SON LIMITED | 30 sept. 2020 | Active | Secrétaire | 27 Hatchlands Road RH1 6RW Redhill Sterling House Surrey United Kingdom | |
MACNIVEN & CAMERON HOMES LIMITED | 15 juil. 2013 | 03 sept. 2020 | Active | Secrétaire | 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Ringley Park House Surrey United Kingdom |
ATACAMA TEXTILES LIMITED | 05 juin 2008 | 30 juin 2020 | Active | Secrétaire | 27 Hatchlands Road RH1 6RW Redhill Sterling House Surrey England |
AOT ENERGY UK LTD | 08 avr. 2020 | Active | Secrétaire | 27 Hatchlands Road RH1 6RW Redhill Sterling House England | |
GREEN SELF STORAGE WORCESTER LIMITED | 14 mars 2020 | Active | Secrétaire | 27 Hatchlands Road RH1 6RW Redhill Sterling House England | |
DAVID BALL RESTORATION (LONDON) LIMITED | 27 mars 2018 | 24 févr. 2020 | Active | Administrateur | 27 Hatchland Road RH1 6RW Redhill Sterling House Surrey England |
CAMREG LIMITED | 28 nov. 2006 | 01 juil. 2019 | Active | Secrétaire | 27 Hatchland Road RH1 6RW Redhill Sterling House Surrey England |
DAVID BALL RESTORATIONS LIMITED | 27 mars 2018 | 30 nov. 2018 | Active | Administrateur | 27 Hatchlands Road RH1 6RW Redhill Sterling House Surrey England |
DAVID BALL RESTORATIONS LIMITED | 27 mars 2018 | 30 nov. 2018 | Active | Administrateur | 27 Hatchland Road RH1 6RW Redhill Sterling House Surrey England |
RACHEL HALSALL LIMITED | 07 août 2012 | 31 juil. 2016 | Active | Secrétaire | 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Ringley Park House Surrey United Kingdom |
HARTLAND UK LIMITED | 04 juil. 2001 | 07 juin 2016 | Active | Secrétaire | 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Ringley Park House Surrey United Kingdom |
MORRISS COURT MANAGEMENT LIMITED | 16 juil. 2015 | Active | Secrétaire | 27 Hatchlands Road RH1 6RW Redhill Sterling House Surrey England | |
NORTHFIELD TRADING CO. LIMITED | 31 oct. 2014 | Active | Secrétaire | 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Ringley Park House Surrey United Kingdom | |
POLLARDS LIMITED | 04 juin 2001 | 24 mars 2014 | Active | Secrétaire | 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Ringley Park House Surrey |
TYSON FOODS PRODUCTS LIMITED | 18 mars 2014 | Active | Secrétaire | 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Ringley Park House Surrey United Kingdom | |
PETER N. DICKIN & CO. LIMITED | 09 avr. 2013 | 23 févr. 2014 | Active | Secrétaire | 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Ringley Park House Surrey England |
AUGMENTUM CONSULTING LIMITED | 25 janv. 2002 | 02 mai 2013 | Dissoute | Secrétaire | 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Ringley Park House Surrey United Kingdom |
TALAMEWS LIMITED | 02 avr. 1998 | 01 avr. 2011 | Active | Secrétaire | 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Ringley Park House Surrey |
PROMTRANS TRADING CO. LTD. | 29 mai 2010 | Dissoute | Secrétaire | Ringley Park House 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Surrey | |
QUERCUS ENTERPRISES LIMITED | 12 avr. 2010 | Active | Secrétaire | 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Ringley Park House Surrey United Kingdom | |
L. STYLES LIMITED | 18 août 2005 | 01 avr. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Ringley Park House 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Surrey |
R.A. GREEN (MECHANICAL SERVICES) LIMITED | 21 nov. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Ringley Park House 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Surrey | |
IAIN WEATHERBY LIMITED | 21 mars 2003 | 06 oct. 2008 | Active | Secrétaire | Ringley Park House 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Surrey |
PANELOCK LIMITED | 11 avr. 2005 | 01 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Ringley Park House 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Surrey |
REX BOUSFIELD (CORBY) LIMITED | 21 févr. 2007 | 22 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Ringley Park House 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Surrey |
REX BOUSFIELD HOLDINGS LIMITED | 21 févr. 2007 | 22 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Ringley Park House 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Surrey |
DARTA UK LTD | 30 janv. 2003 | 05 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Ringley Park House 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Surrey |
FAST FRUIT DISTRIBUTION LIMITED | 25 juin 2007 | Dissoute | Secrétaire | Ringley Park House 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Surrey | |
WILLIAMS HARLOW COMMERCIAL LTD. | 15 avr. 2003 | 06 févr. 2007 | Dissoute | Secrétaire | Ringley Park House 59 Reigate Road RH2 0QJ Reigate Surrey |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0