Anthony Christopher Stephen CREED - Page 3
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Anthony |
Deuxième prénom | Christopher Stephen |
Nom de famille | CREED |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 5 |
Inactif | 44 |
Démissionné | 86 |
Total | 135 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N K BOOKS LIMITED | 29 mai 2002 | 29 mai 2018 | Active | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
CRAYMILL TRANSPORT SERVICE LIMITED | 24 mai 2005 | 29 mai 2018 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
MARSH HARRIER LIMITED | 16 mai 2003 | 16 mai 2018 | Active | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
WILSON ELLIS BUILDING SERVICES LIMITED | 23 mars 2006 | 23 avr. 2018 | Active | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
THOMAS CALLUM ASSOCIATES LIMITED | 01 janv. 2003 | 23 avr. 2018 | Active | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | ||
C.K. TILING LIMITED | 22 avr. 2002 | 23 avr. 2018 | Active | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
B C LOCATION SERVICES LIMITED | 21 avr. 1997 | 23 avr. 2018 | Active | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
BLUE BRIDGE EDITING LIMITED | 26 janv. 2002 | 23 avr. 2018 | Dissoute | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | ||
NICK LONDON PRODUCTIONS LIMITED | 16 mars 2001 | 16 mars 2018 | Active | Company Director | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
DESIGNLINE TECHNICAL SERVICES LIMITED | 09 mars 2006 | 09 mars 2018 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
D J GOLDING LIMITED | 05 mars 2003 | 06 mars 2018 | Active | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
P S CAB SERVICE LIMITED | 04 mars 2003 | 06 mars 2018 | Active | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
CORBYN PROPERTY MAINTENANCE LTD | 28 nov. 2003 | 23 févr. 2018 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
JAMES KENT LIMITED | 20 févr. 2000 | 20 févr. 2018 | Active | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | ||
BJL LIMITED | 13 avr. 2000 | 07 févr. 2018 | Active | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | ||
RED SHRIKE PROPERTIES LIMITED | 30 janv. 2004 | 30 janv. 2018 | Active | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
GLNOW LIMITED | 05 sept. 2001 | 29 janv. 2018 | Active | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
STATE OF GRACE FILMS LIMITED | 24 oct. 2006 | 24 oct. 2017 | Active | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
GOOD TRANSPORT LIMITED | 27 sept. 2001 | 29 sept. 2017 | Active | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
JSG ENTERPRISES LIMITED | 16 sept. 2002 | 18 sept. 2017 | Active | Accountants | Secrétaire | The Coach House St Business Centre Bourne Road DA5 1LU Bexley Unit 42 Kent | British | |
POMFREY CREED ACCOUNTANTS LTD | 05 sept. 2001 | 05 sept. 2017 | Active | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
JAY BROOKS LIMITED | 29 août 2001 | 29 août 2017 | Active | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
BRUNEL INSURANCE SERVICES LIMITED | 27 août 1999 | 29 août 2017 | Active | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | ||
SIVA ENTERPRISE LIMITED | 07 mai 2014 | 31 déc. 2016 | Dissoute | Company Director | Administrateur | St Mary's Business Centre, 66-70 Bourne Road, DA5 1LU Bexley, Unit 42 The Coach House Kent | England | British |
AUTOWAY SUNDRY SUPPLIES LIMITED | 26 févr. 2002 | 22 oct. 2015 | Active | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
K & L ELECTRICAL SERVICES LIMITED | 16 mai 2011 | 30 juil. 2015 | Dissoute | Company Director | Administrateur | St Mary's Business Centre 66-70 Bourne Rd DA5 1LU Bexley Unit 42 The Coach House Kent Uk | England | British |
A W A SHOPFITTERS LIMITED | 04 avr. 1997 | 29 juin 2014 | Liquidation | Acountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
SIVA ENTERPRISE LIMITED | 16 déc. 2010 | 31 déc. 2011 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Rochester Drive DA5 1QG Bexley 182 Kent | England | British |
SIVA ENTERPRISE LIMITED | 16 déc. 2010 | 31 déc. 2011 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Rochester Drive DA5 1QG Bexley 182 Kent | England | British |
RJM BRICKWORK LIMITED | 11 oct. 2006 | 31 juil. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Rochester Drive DA5 1QG Bexley 182 Kent | British | ||
PURPLE PIG CLAIMS LIMITED | 10 déc. 2010 | 21 mars 2011 | Dissoute | None | Administrateur | Rochester Drive DA5 1QG Bexley 182 Kent | England | British |
PURPLE PIG CLAIMS LIMITED | 10 déc. 2010 | 21 mars 2011 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Rochester Drive DA5 1QG Bexley 182 Kent | England | British |
L & A INSPIRATIONS LIMITED | 03 oct. 2002 | 17 mars 2011 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
BEACON FINANCIAL SERVICES LIMITED | 17 juin 2002 | 14 sept. 2010 | Active | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British | |
REGENCY F.I.C. LIMITED | 22 sept. 2003 | 11 mai 2010 | Active | Accountant | Secrétaire | 182 Rochester Drive DA5 1QG Bexley Kent | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0