Steven Francis TURNBULL - Page 2
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Steven |
Deuxième prénom | Francis |
Nom de famille | TURNBULL |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 10 |
Inactif | 34 |
Démissionné | 37 |
Total | 81 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOLBILLBOARDS (INTERNATIONAL) LIMITED | 21 mai 2004 | Dissoute | Company Director | Administrateur | 6 Deeside Place KY11 8GL Dunfermline Fife | Scotland | British | |
URANUS INVESTMENTS LIMITED | 06 août 2003 | Dissoute | Secrétaire | 16 Comely Park Dunfermline KY12 7HU Fife | British | |||
URANUS INVESTMENTS LIMITED | 06 août 2003 | Dissoute | Financial Director | Administrateur | Comely Park KY12 7HU Dunfermline 16 Fife Scotland | Scotland | British | |
RIVER INTERNATIONAL LIMITED | 05 juin 2003 | Dissoute | Company Director | Administrateur | 16 Comely Park Dunfermline KY12 7HU Fife | Scotland | British | |
RIVER INTERNATIONAL LIMITED | 05 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire | 16 Comely Park Dunfermline KY12 7HU Fife | British | |||
COOL CAR MEDIA LIMITED | 28 mai 2003 | Dissoute | Company Director | Administrateur | 6 Deeside Place KY11 8GL Dunfermline Fife | Scotland | British | |
KIRKGATE PROPERTY LIMITED | 05 nov. 2002 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Viewfield Terrace KY12 7LB Dunfermline 26 Scotland | Scotland | British | |
ROPE ACCESS INTERNATIONAL LIMITED | 10 nov. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 16 Comely Park Dunfermline KY12 7HU Fife | British | |||
STRUAN PARK PROPERTY LTD | 26 oct. 1998 | Dissoute | Secrétaire | Dublin Street EH1 3PG Edinburgh 11a | British | |||
KIRKGATE PROPERTY LIMITED | 05 nov. 2002 | 02 sept. 2024 | Dissoute | Secrétaire | Viewfield Terrace KY12 7LB Dunfermline 26 Scotland | British | ||
GRANGE CONSULTANTS LIMITED | 16 août 2000 | 11 avr. 2024 | Active | Manager | Administrateur | George Square EH8 9LD Edinburgh 26 Scotland | Scotland | British |
GRANGE CONSULTANTS LIMITED | 26 juil. 1999 | 11 avr. 2024 | Active | Secrétaire | George Square EH8 9LD Edinburgh 26 Scotland | British | ||
DALGETY INVESTMENTS LIMITED | 10 janv. 2001 | 01 juin 2023 | Active | Secrétaire | Constitution Street Leith EH6 6RR Edinburgh 60 Lothian Scotland | British | ||
GRUPPOFORTE LIMITED | 21 janv. 2000 | 14 mars 2022 | Active | Secrétaire | Leith EH6 6RR Edinburgh 60 Constitution Street Lothain Scotland | British | ||
KENMORE ESTATES LIMITED | 31 mars 2004 | 17 juil. 2020 | Active | Director | Administrateur | Kenmore Hotel Kenmore PH15 2NU Perthshire | Scotland | British |
FLOATRICH LIMITED | 26 oct. 1998 | 30 oct. 2019 | Active | Secrétaire | George Square EH8 9LD Edinburgh 26 Scotland | British | ||
FOUNDRY PROPERTY LIMITED | 01 janv. 2018 | 20 nov. 2018 | Dissoute | Compnay Director | Administrateur | George Square EH8 9LD Edinburgh 26 Scotland | Scotland | British |
NICOLA MURRAY FOUNDATION | 23 juin 2010 | 01 mai 2018 | Active | Company Director | Administrateur | Comely Park KY12 7HU Dunfermline 16 Fife | Scotland | British |
KENMORE ESTATES LIMITED | 07 déc. 1998 | 31 déc. 2017 | Active | Secrétaire | Kenmore Hotel Kenmore PH15 2NU Perthshire | British | ||
NQF CONSULTING LIMITED | 04 nov. 2003 | 07 nov. 2014 | Dissoute | Company Director | Secrétaire | 6 Deeside Place KY11 8GL Dunfermline Fife | British | |
M.G.M. CONSULTANCY LIMITED | 09 juin 2000 | 01 mai 2014 | Active | Secrétaire | 16 Comely Park Dunfermline KY12 7HU Fife | British | ||
MARCO POLO STORICA LIMITED | 19 févr. 2008 | 07 juin 2013 | Dissoute | Secrétaire | 6 Deeside Place KY11 8GL Dunfermline Fife | British | ||
STRUAN PARK PROPERTY LTD | 07 juin 2000 | 01 déc. 2012 | Dissoute | Export + Finance Manager | Administrateur | 16 Comely Park Dunfermline KY12 7HU Fife | Scotland | British |
TELEVOX LIMITED | 24 oct. 2006 | 18 nov. 2009 | Active | Secrétaire | Manchester Square Milner House W1U 3PP London 14 | British | ||
LUXURY CHAUFFEUR LIMOUSINES LIMITED | 23 mars 2007 | 01 nov. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 6 Deeside Place KY11 8GL Dunfermline Fife | British | ||
GIGI TRADING LIMITED | 23 nov. 2005 | 01 nov. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 6 Deeside Place KY11 8GL Dunfermline Fife | British | ||
SULTANA LIMITED | 10 nov. 2005 | 01 nov. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 6 Deeside Place KY11 8GL Dunfermline Fife | British | ||
TREPEZ (UK) LIMITED | 29 mars 2005 | 01 nov. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 6 Deeside Place KY11 8GL Dunfermline Fife | British | ||
EGO FASHION BOX LIMITED | 29 juin 2004 | 01 nov. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 6 Deeside Place KY11 8GL Dunfermline Fife | British | ||
IBS OIL SERVICES LIMITED | 22 mars 2004 | 01 nov. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 6 Deeside Place KY11 8GL Dunfermline Fife | British | ||
KKI SALES INTERNATIONAL LIMITED | 21 nov. 2003 | 01 nov. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 6 Deeside Place KY11 8GL Dunfermline Fife | British | ||
REBIANA CONSTRUCTION AND OIL FIELD SERVICES LIMITED | 19 juil. 2003 | 01 nov. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 6 Deeside Place KY11 8GL Dunfermline Fife | British | ||
COOL CAR MEDIA LIMITED | 28 mai 2003 | 01 nov. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 6 Deeside Place KY11 8GL Dunfermline Fife | British | ||
INTERNATIONAL BUILDING SUPPLIES LIMITED | 22 janv. 2003 | 01 nov. 2009 | Active | Secrétaire | 6 Deeside Place KY11 8GL Dunfermline Fife | British | ||
CIRRUS HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED | 16 d éc. 2002 | 01 nov. 2009 | Active | Secrétaire | 6 Deeside Place KY11 8GL Dunfermline Fife | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0