Andrew Firth MCLEAN
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Andrew |
Deuxième prénom | Firth |
Nom de famille | MCLEAN |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 4 |
Inactif | 2 |
Démissionné | 18 |
Total | 24 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIRLING ANGLIAN PHARMACEUTICALS LIMITED | 21 déc. 2021 | Active | Director | Administrateur | Ainslie Road Hillington Park G52 4RU Glasgow Hillington Park Innovation Centre | Scotland | British | |
AFM CONSULTING LTD | 07 janv. 2021 | Dissoute | Director | Administrateur | The Square TD5 7HW Kelso 47-49 United Kingdom | Scotland | British | |
KELSO PHARMA LIMITED | 06 janv. 2021 | Active | Director | Administrateur | , TD5 8HG Kelso Wooden House United Kingdom | Scotland | British | |
BUSTAN INVESTMENTS LIMITED | 16 mars 2007 | Active | Solicitor | Secrétaire | Mill Road Holton IP19 8PP Halesworth The Old Post Office Suffolk England | British | ||
BUSTAN INVESTMENTS LIMITED | 16 mars 2007 | Active | Solicitor | Administrateur | Mill Road Holton IP19 8PP Halesworth The Old Post Office Suffolk England | Scotland | British | |
STRAKAN INTERNATIONAL LIMITED | 18 août 2003 | Converti / Fermé | Solicitor | Administrateur | Greenknowe Farmhouse TD3 6LA Gordon Berwickshire | Scotland | British | |
MEDHERANT LIMITED | 11 mars 2021 | 04 avr. 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Sir William Lyons Road, University Of Warwick Science Park CV4 7EZ Coventry The Venture Centre England | Scotland | British |
ARCHIMEDES PHARMA UK LIMITED | 05 août 2014 | 22 avr. 2020 | Active | General Counsel | Administrateur | Sackville House 143-149 Fenchurch Street EC3M 6BL London 1st Floor England | Scotland | British |
KYOWA KIRIN SERVICES LTD | 05 août 2014 | 22 avr. 2020 | Active | General Counsel | Administrateur | 143-149 Fenchurch Street EC3M 6BN London 1st Floor, Sackville House England | Scotland | British |
KYOWA KIRIN PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED | 17 avr. 2007 | 22 avr. 2020 | Active | General Counsel | Administrateur | Sackville House 143-149 Fenchurch Street EC3M 6BL London 1st Floor England | Scotland | British |
KYOWA KIRIN LIMITED | 25 mai 2000 | 22 avr. 2020 | Active | General Counsel | Administrateur | Sackville House 143-149 Fenchurch Street EC3M 6BL London 1st Floor England | Scotland | British |
STRAKAN INTERNATIONAL S.A. | 30 nov. 2011 | 22 avr. 2020 | Converti / Fermé | None | Administrateur | Queen Street Galabank Business Park TD1 1QH Galashiels 3 Selkirkshire United Kingdom | Scotland | British |
ARCHIMEDES PHARMA LIMITED | 05 août 2014 | 22 avr. 2020 | Dissoute | General Counsel | Administrateur | Sackville House 143-149 Fenchurch Street EC3M 6BL London 1st Floor England | Scotland | British |
KYOWA KIRIN INTERNATIONAL PLC | 20 janv. 2000 | 24 mars 2020 | Active | Lawyer | Secrétaire | Greenknowe Farmhouse TD3 6LA Gordon Berwickshire | British | |
ARCHIMEDES PHARMA EUROPE LIMITED | 05 août 2014 | 09 févr. 2016 | Dissoute | General Counsel | Administrateur | More London Place SE1 2AF London Ernst & Young Llp1 | Scotland | British |
ARCHIMEDES HOLDINGS LIMITED | 05 août 2014 | 09 févr. 2016 | Dissoute | General Counsel | Administrateur | More London Place SE1 2AF London 1 | Scotland | British |
ARCHIMEDES PHARMA TRUSTEES LIMITED | 05 août 2014 | 09 févr. 2016 | Dissoute | General Counsel | Administrateur | More London Place SE1 2AF London Ernst & Young Llp 1 | Scotland | British |
KYOWA KIRIN PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED | 02 déc. 1997 | 28 févr. 2003 | Active | Solicitor | Administrateur | Fansloanend House TD4 6BD Earlston Berwickshire | Scotland | British |
SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LIMITED | 18 sept. 1995 | 30 nov. 1995 | Active | Solicitor | Secrétaire | Beech Cottage London Road RG27 8RN Hartley Wintney Hampshire | British | |
SHIRE PHARMACEUTICALS LIMITED | 27 oct. 1993 | 30 nov. 1995 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Beech Cottage London Road RG27 8RN Hartley Wintney Hampshire | British | |
SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP | 12 déc. 1994 | 30 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire | Beech Cottage London Road RG27 8RN Hartley Wintney Hampshire | British | ||
RYBAR LABORATORIES LIMITED | 27 oct. 1993 | 30 nov. 1995 | Dissoute | Secrétaire | Beech Cottage London Road RG27 8RN Hartley Wintney Hampshire | British | ||
SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED | 27 oct. 1993 | 30 nov. 1995 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Beech Cottage London Road RG27 8RN Hartley Wintney Hampshire | British | |
RECALLBATCH LIMITED | 16 oct. 1991 | 01 juin 1993 | Active | Solicitor | Administrateur | Dragoon House 37 Artillery Lane E1 7LT London | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0