SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité illimitée |
| Numéro de société | 02883758 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP ?
| Adresse du siège social | 1 Kingdom Street W2 6BD London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Takeda Corporate Services Limited en tant que secrétaire le 31 mai 2023 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 4 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Clark Neal en tant que directeur le 18 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Gibbons en tant que directeur le 08 nov. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Nomination de Ms Seyda Atadan Memis en tant qu'administrateur le 01 août 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Nomination de Peter Michael Grubin en tant qu'administrateur le 01 mars 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Kentaro Shirahata en tant que directeur le 01 mars 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2020 | 37 pages | AA | ||||||||||||||||||||||
Nomination de Mr Mark Gibbons en tant qu'administrateur le 30 nov. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Nicholas Hugh Meryon Insall en tant que directeur le 30 nov. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Shire Corporate Services Limited le 28 avr. 2020 | 1 pages | CH04 | ||||||||||||||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2019 au 31 mars 2020 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan Clark Neal le 06 févr. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 33 pages | AA | ||||||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2019 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Damien Rodolphe Edmond Bailly en tant que directeur le 06 mai 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Attribution d'une nouvelle catégorie d'actions par une société en nom collectif | 3 pages | SH09 | ||||||||||||||||||||||
Nomination de Mr Jonathan Clark Neal en tant qu'administrateur le 12 mars 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUBIN, Peter Michael | Administrateur | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | England | American | 293835890001 | |||||||||
| MEMIS, Seyda Atadan | Administrateur | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | England | Turkish | 299191490001 | |||||||||
| GUTHRIE, Anthony James | Secrétaire | Hampshire Int Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Lime Tree Way Hampshire | British | 131668010002 | ||||||||||
| HARRIS, Neil Charles | Secrétaire | Old Tiles Church Lane SP6 3LE Martin Hampshire | British | 96188470001 | ||||||||||
| MAY, Tatjana Anni Hilde | Secrétaire | Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | British | 75855670003 | ||||||||||
| MCLEAN, Andrew Firth | Secrétaire | Beech Cottage London Road RG27 8RN Hartley Wintney Hampshire | British | 55993260003 | ||||||||||
| RUSSSELL, Angus Charles | Secrétaire | High View Monks Well GU10 1RH Farnham Surrey | British | 75381100001 | ||||||||||
| STRAWBRIDGE, Oliver | Secrétaire | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | 202187490001 | |||||||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||||||
| TAKEDA CORPORATE SERVICES LIMITED | Secrétaire | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom |
| 244206590002 | ||||||||||
| BAILLY, Damien Rodolphe Edmond | Administrateur | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | France | French | 242039150001 | |||||||||
| BELLINI, Francesco, Dr | Administrateur | 307 Rue Portland H3R 1V4 Ville Mont Royal Quebec Canada | Canadian | 76159220001 | ||||||||||
| BOWLING, James Nicholas | Administrateur | Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire International Business Park Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 178036960001 | |||||||||
| BOWLING, James Nicholas | Administrateur | Hampshire International Busines Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 178036960001 | |||||||||
| BRANSGROVE, Roderick Granville | Administrateur | Fetter Lane EC4A 1BN London 100 | United Kingdom | British | 48749520001 | |||||||||
| BUCHANAN, Robin William Turnbull | Administrateur | Shire Plc Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | British | 25905100002 | ||||||||||
| CANAVAN, Bernard | Administrateur | 19700 Beach Road Apartment 2 North Jupiter Island Florida Usa 33469 | American | 63249680001 | ||||||||||
| CARRUTHERS, Fearghas Macgilp Kerr | Administrateur | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 178667180002 | |||||||||
| CAVANAUGH, James Henry, Doctor | Administrateur | Shire Plc Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | American | 52100100002 | ||||||||||
| CHARLTON, Peter John | Administrateur désigné | 17 Kirkdale Road AL5 2PT Harpenden Hertfordshire | British | 900005610001 | ||||||||||
| CLEMENTS, Patrick Norris | Administrateur | Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 122369120001 | |||||||||
| CLEMENTS, Patrick Norris | Administrateur | Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 122369120001 | |||||||||
| EMMENS, Matthew William | Administrateur | Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | American | 88969740002 | ||||||||||
| GARVEY, James | Administrateur | One Beacon Street Boston FOREIGN Usa 02108 | American | 43825460001 | ||||||||||
| GIBBONS, Mark | Administrateur | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | England | South African | 248159240001 | |||||||||
| GRANT, James Andrews, Honorable Pc | Administrateur | Shire Plc Hampshire International Business Park RG24 8EP Chineham Basingstoke | Canadian | 76159160001 | ||||||||||
| GRIGGS, Roger | Administrateur | 7900 Tanners Gate Dr Suite 200 KY 41042 Florence Kentucky Usa | American | 55196760001 | ||||||||||
| HARTLEY, Daniel William David | Administrateur | Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire International Business Park Hampshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | 184526870001 | |||||||||
| HARTLEY, Daniel William David | Administrateur | Hampshire International Business Park RG24 8EP Basingstoke Hampshire | United Kingdom | Australian | 184526870001 | |||||||||
| HETHERINGTON, Graham Charles | Administrateur | Lime Tree Way Hampshire Int Business Park, Chineham RG24 8EP Basingstoke . Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 132396390001 | |||||||||
| HOROVITZ, Zola, Doctor | Administrateur | 6110 N.W. 42nd Way Boca Raton 33496 Florida Usa | American | 67993590001 | ||||||||||
| INSALL, Nicholas Hugh Meryon | Administrateur | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 248118390001 | |||||||||
| KAPPLER, David John | Administrateur | Hampshire International Business Park Chineham RG24 3EP Basingstoke Shire Plc Hampshire | England | British | 137007730001 | |||||||||
| LANGLOIS, Patrick Jean Marie | Administrateur | Shire Plc, Hampshire International Business Park, Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | French | 109662720001 | ||||||||||
| MARTEL, Timothy John | Administrateur | Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire International Business Park Hampshire United Kingdom | United Kingdom | English | 162356650001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shire Biopharmaceuticals Holdings | 06 avr. 2016 | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 23 déc. 1999 Livré le 06 janv. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations (monetary or otherwise ) of the company to the chargee arising under or in connection with the amended and restated credit agreement dated 19TH november 1999, any interest rate swap,cap,collar or similar agreement entered into pursuant to the terms of the credit agreement, any promissory note payable to any lender under the credit agreement evidencing the agrregate indebtedness to any such lender ,any standby or commercial letters of credit any loan request any letter of credit request,the letter dated 19TH november 199 and any agreements defined therein | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 19 déc. 1994 Livré le 05 janv. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from shire pharmaceutical development limited to the noteholders (as defined) in respect of the £10,000,000 10% fixed rate secured loan notes of 1995 of spdl originally constituted by the deed poll of spdl dated 1994 or under the terms of the loan note instrument and all reasonable costs,charges and expenses incurred under or in respect of the debenture by the instructing group (as defined) or by the noteholders or by any receiver appointed under the debenture | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0