SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSHIRE PHARMACEUTICALS GROUP
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 02883758
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP ?

    Adresse du siège social
    1 Kingdom Street
    W2 6BD London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP LIMITED25 nov. 200525 nov. 2005
    SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP PLC 13 déc. 199413 déc. 1994
    BARNHILL PLC01 janv. 199401 janv. 1994

    Quels sont les derniers comptes de SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Takeda Corporate Services Limited en tant que secrétaire le 31 mai 2023

    1 pagesTM02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution de capitalisation ou d'émission d'actions gratuites

    Re: the sum of usd 625,000 be capitalised / the sum of usd 29,426,000 be capitalised 30/03/2023
    RES14
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Re: cancel share premium account 30/03/2023
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Cessation de la nomination de Jonathan Clark Neal en tant que directeur le 18 janv. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark Gibbons en tant que directeur le 08 nov. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Seyda Atadan Memis en tant qu'administrateur le 01 août 2022

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Peter Michael Grubin en tant qu'administrateur le 01 mars 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kentaro Shirahata en tant que directeur le 01 mars 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2020

    37 pagesAA

    Nomination de Mr Mark Gibbons en tant qu'administrateur le 30 nov. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Nicholas Hugh Meryon Insall en tant que directeur le 30 nov. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Shire Corporate Services Limited le 28 avr. 2020

    1 pagesCH04

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2019 au 31 mars 2020

    1 pagesAA01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan Clark Neal le 06 févr. 2020

    2 pagesCH01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    33 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 juin 2019 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Damien Rodolphe Edmond Bailly en tant que directeur le 06 mai 2019

    1 pagesTM01

    Attribution d'une nouvelle catégorie d'actions par une société en nom collectif

    3 pagesSH09

    Nomination de Mr Jonathan Clark Neal en tant qu'administrateur le 12 mars 2019

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GRUBIN, Peter Michael
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    EnglandAmerican293835890001
    MEMIS, Seyda Atadan
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    EnglandTurkish299191490001
    GUTHRIE, Anthony James
    Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Lime Tree Way
    Hampshire
    Secrétaire
    Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Lime Tree Way
    Hampshire
    British131668010002
    HARRIS, Neil Charles
    Old Tiles
    Church Lane
    SP6 3LE Martin
    Hampshire
    Secrétaire
    Old Tiles
    Church Lane
    SP6 3LE Martin
    Hampshire
    British96188470001
    MAY, Tatjana Anni Hilde
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    British75855670003
    MCLEAN, Andrew Firth
    Beech Cottage
    London Road
    RG27 8RN Hartley Wintney
    Hampshire
    Secrétaire
    Beech Cottage
    London Road
    RG27 8RN Hartley Wintney
    Hampshire
    British55993260003
    RUSSSELL, Angus Charles
    High View Monks Well
    GU10 1RH Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    High View Monks Well
    GU10 1RH Farnham
    Surrey
    British75381100001
    STRAWBRIDGE, Oliver
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    202187490001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    TAKEDA CORPORATE SERVICES LIMITED
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement11022500
    244206590002
    BAILLY, Damien Rodolphe Edmond
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    FranceFrench242039150001
    BELLINI, Francesco, Dr
    307 Rue Portland
    H3R 1V4 Ville Mont Royal
    Quebec
    Canada
    Administrateur
    307 Rue Portland
    H3R 1V4 Ville Mont Royal
    Quebec
    Canada
    Canadian76159220001
    BOWLING, James Nicholas
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire International Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire International Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish178036960001
    BOWLING, James Nicholas
    Hampshire International Busines Park
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Hampshire International Busines Park
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish178036960001
    BRANSGROVE, Roderick Granville
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    Administrateur
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    United KingdomBritish48749520001
    BUCHANAN, Robin William Turnbull
    Shire Plc Hampshire International
    Business Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Shire Plc Hampshire International
    Business Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    British25905100002
    CANAVAN, Bernard
    19700 Beach Road Apartment 2 North
    Jupiter Island
    Florida
    Usa 33469
    Administrateur
    19700 Beach Road Apartment 2 North
    Jupiter Island
    Florida
    Usa 33469
    American63249680001
    CARRUTHERS, Fearghas Macgilp Kerr
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish178667180002
    CAVANAUGH, James Henry, Doctor
    Shire Plc Hampshire International
    Business Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Shire Plc Hampshire International
    Business Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    American52100100002
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur désigné
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    CLEMENTS, Patrick Norris
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish122369120001
    CLEMENTS, Patrick Norris
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish122369120001
    EMMENS, Matthew William
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    American88969740002
    GARVEY, James
    One Beacon Street
    Boston
    FOREIGN Usa 02108
    Administrateur
    One Beacon Street
    Boston
    FOREIGN Usa 02108
    American43825460001
    GIBBONS, Mark
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    EnglandSouth African248159240001
    GRANT, James Andrews, Honorable Pc
    Shire Plc
    Hampshire International Business Park
    RG24 8EP Chineham
    Basingstoke
    Administrateur
    Shire Plc
    Hampshire International Business Park
    RG24 8EP Chineham
    Basingstoke
    Canadian76159160001
    GRIGGS, Roger
    7900 Tanners Gate Dr
    Suite 200
    KY 41042 Florence
    Kentucky
    Usa
    Administrateur
    7900 Tanners Gate Dr
    Suite 200
    KY 41042 Florence
    Kentucky
    Usa
    American55196760001
    HARTLEY, Daniel William David
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire International Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire International Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomAustralian184526870001
    HARTLEY, Daniel William David
    Hampshire International Business Park
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Hampshire International Business Park
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomAustralian184526870001
    HETHERINGTON, Graham Charles
    Lime Tree Way
    Hampshire Int Business Park, Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    .
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Lime Tree Way
    Hampshire Int Business Park, Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    .
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish132396390001
    HOROVITZ, Zola, Doctor
    6110 N.W. 42nd Way
    Boca Raton
    33496
    Florida Usa
    Administrateur
    6110 N.W. 42nd Way
    Boca Raton
    33496
    Florida Usa
    American67993590001
    INSALL, Nicholas Hugh Meryon
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish248118390001
    KAPPLER, David John
    Hampshire International Business Park
    Chineham
    RG24 3EP Basingstoke
    Shire Plc
    Hampshire
    Administrateur
    Hampshire International Business Park
    Chineham
    RG24 3EP Basingstoke
    Shire Plc
    Hampshire
    EnglandBritish137007730001
    LANGLOIS, Patrick Jean Marie
    Shire Plc, Hampshire International
    Business Park, Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Shire Plc, Hampshire International
    Business Park, Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    French109662720001
    MARTEL, Timothy John
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire International Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire International Business Park
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomEnglish162356650001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueUnlimited With Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement5492592
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 23 déc. 1999
    Livré le 06 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations (monetary or otherwise ) of the company to the chargee arising under or in connection with the amended and restated credit agreement dated 19TH november 1999, any interest rate swap,cap,collar or similar agreement entered into pursuant to the terms of the credit agreement, any promissory note payable to any lender under the credit agreement evidencing the agrregate indebtedness to any such lender ,any standby or commercial letters of credit any loan request any letter of credit request,the letter dated 19TH november 199 and any agreements defined therein
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Dlj Capital Funding Inc.
    Transactions
    • 06 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 déc. 1994
    Livré le 05 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from shire pharmaceutical development limited to the noteholders (as defined) in respect of the £10,000,000 10% fixed rate secured loan notes of 1995 of spdl originally constituted by the deed poll of spdl dated 1994 or under the terms of the loan note instrument and all reasonable costs,charges and expenses incurred under or in respect of the debenture by the instructing group (as defined) or by the noteholders or by any receiver appointed under the debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sun Life Nominees Limitedplease See M395 for Full Details
    • Sun Life Assurance Society PLC
    • 525 Investments Limited
    Transactions
    • 05 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0