Andrew Stephen PIKE - Page 8
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Andrew |
Deuxième prénom | Stephen |
Nom de famille | PIKE |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 1 |
Inactif | 32 |
Démissionné | 254 |
Total | 287 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMMON & SMITH LIMITED | 28 avr. 2000 | 15 avr. 2013 | Dissoute | Company Director | Secrétaire | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | |
EDWARD HENTHORNE AND COMPANY LIMITED | 06 août 2004 | 01 août 2012 | Dissoute | Secrétaire | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | ||
JAMES LADD & SONS (PROPERTY) LIMITED | 28 avr. 2000 | 01 août 2012 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | |
BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED | 28 avr. 2000 | 01 août 2012 | Dissoute | Company Director | Secrétaire | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | |
SHARPE & FISHER (BUILDING SUPPLIES) LIMITED | 31 mai 2000 | 21 déc. 2011 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | |
EDWARD JONES (CROWTHORNE) LTD | 28 avr. 2000 | 21 déc. 2011 | Dissoute | Company Director | Secrétaire | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | |
NETTLEWOOD LIMITED | 23 janv. 2004 | 04 mai 2011 | Active | Secrétaire | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | ||
MERCHANT PROPERTIES NOMINEES LIMITED | 16 nov. 2006 | 22 déc. 2006 | Dissoute | Secrétaire | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | ||
MERCHANT PROPERTIES GENERAL PARTNER LIMITED | 16 nov. 2006 | 22 déc. 2006 | Dissoute | Secrétaire | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | ||
JOHN CLEMENTS (BUILDERS MERCHANTS) LIMITED | 09 août 1999 | 03 mai 2006 | Dissoute | Secrétaire | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | ||
E. SALISBURY LIMITED | 09 août 1999 | 03 mai 2006 | Dissoute | Secrétaire | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | ||
CARMICHAEL BROWNE ASSOCIATES LIMITED | 09 août 1999 | 20 oct. 2005 | Dissoute | Company Director | Secrétaire | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | |
CRH AUSTRALIA HOLDINGS UK LIMITED | 29 oct. 1998 | 28 mai 1999 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | |
CRH SERBIA HOLDINGS UK LIMITED | 01 déc. 1997 | 28 mai 1999 | Active | Director | Administrateur | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | |
IBSTOCK BRICKS (1996) LIMITED | 04 avr. 1997 | 28 mai 1999 | Active | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | ||
IBSTOCK BRICKS (1996) LIMITED | 04 mars 1997 | 28 mai 1999 | Active | Company Director | Administrateur | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | |
IBSTOCK (JJW) LIMITED | 29 oct. 1998 | 24 mai 1999 | Dissoute | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | ||
CRH AUSTRALIA HOLDINGS UK LIMITED | 29 oct. 1998 | 24 mai 1999 | Dissoute | Company Director | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | |
CRH SERBIA HOLDINGS UK LIMITED | 01 déc. 1997 | 24 mai 1999 | Active | Director | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | |
IBSTOCK BRICK ROUGHDALES LIMITED | 04 avr. 1997 | 24 mai 1999 | Active | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | ||
IBSTOCK HOLDINGS LIMITED | 04 avr. 1997 | 24 mai 1999 | Dissoute | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | ||
IBSTOCK BRICK HUDSONS LIMITED | 04 avr. 1997 | 24 mai 1999 | Dissoute | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | ||
IBSTOCK WESTBRICK LIMITED | 04 avr. 1997 | 24 mai 1999 | Active | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | ||
IBSTOCK HATHERNWARE LIMITED | 04 avr. 1997 | 24 mai 1999 | Active | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | ||
SCOTTISH BRICK CORPORATION LIMITED | 04 avr. 1997 | 24 mai 1999 | Dissoute | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | ||
IBSTOCK BRICK LEICESTER LIMITED | 04 avr. 1997 | 24 mai 1999 | Active | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | ||
IBSTOCK BRICK ALDRIDGE LIMITED | 04 avr. 1997 | 24 mai 1999 | Active | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | ||
EUCALYPTUS PULP MILLS LIMITED | 04 avr. 1997 | 24 mai 1999 | Dissoute | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | ||
PRESTAGE AND BROSELEY TILERIES COMPANY LIMITED(THE) | 04 avr. 1997 | 24 mai 1999 | Dissoute | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | ||
IBSTOCK SCOTTISH BRICK LIMITED | 04 avr. 1997 | 24 mai 1999 | Dissoute | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | ||
CENTURION BRICK (TANNOCHSIDE) LIMITED | 04 avr. 1997 | 24 mai 1999 | Dissoute | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | ||
UNITED FIRECLAY PRODUCTS LIMITED | 04 avr. 1997 | 24 mai 1999 | Dissoute | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | ||
IBSTOCK BRICK NOSTELL LIMITED | 04 avr. 1997 | 24 mai 1999 | Active | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | ||
IBSTOCK BRICK HIMLEY LIMITED | 04 avr. 1997 | 24 mai 1999 | Active | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | ||
IBSTOCK BRICK TELFORD LIMITED | 04 avr. 1997 | 24 mai 1999 | Dissoute | Secrétaire | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0