W.I.S. SECRETARY SERVICES LTD - Page 2
Dirigeant de société
| Nom | W.I.S. SECRETARY SERVICES LTD |
|---|---|
| Est un dirigeant de société | Oui |
| Nominations | |
| Actif | 0 |
| Inactif | 20 |
| Démissionné | 98 |
| Total | 118 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| NEODICA LTD | 28 mars 2011 | 09 déc. 2020 | Dissoute | Secrétaire | Fetter Lane EC4A 1BR London Room 4.01, 1 England |
| TRODOS LIMITED | 28 mars 2011 | 09 déc. 2020 | Dissoute | Secrétaire | Fetter Lane EC4A 1BR London Office 4.01, 1 England |
| ROMFORD COMMERCE LTD | 21 févr. 2011 | 09 déc. 2020 | Dissoute | Secrétaire | Fetter Lane EC4A 1BR London Room 4.01, 1 England |
| BEXLEY PARTNERS LTD | 21 févr. 2011 | 09 déc. 2020 | Dissoute | Secrétaire | Fetter Lane EC4A 1BR London Room 4.01, 1 England |
| DELGADO FINANCIAL LTD | 27 août 2010 | 09 déc. 2020 | Dissoute | Secrétaire | 8-12 Fleet House New Bridge Street EC4V 6AL London Room 4.08 United Kingdom |
| BRUNIS LIMITED | 10 mars 2010 | 09 déc. 2020 | Dissoute | Secrétaire | Fetter Lane EC4A 1BR London Room 4.01, 1 England |
| LET ME CLOUD LIMITED | 28 sept. 2015 | 17 nov. 2020 | Dissoute | Secrétaire | 1 Fetter Lane EC4A 1BR London Office 4.01 England |
| ARONEX COMMERCE LTD | 16 mai 2014 | 17 nov. 2020 | Dissoute | Secrétaire | Fetter Lane EC4A 1BR London Room 4.01, 1 England |
| ATLANTICUS PARTNERS LTD | 20 mars 2013 | 02 oct. 2020 | Active | Secrétaire | Fetter Lane EC4A 1BR London Room 4.01, 1 England |
| ARISTO HOLDINGS LTD | 20 janv. 2017 | 14 juil. 2020 | Dissoute | Secrétaire | Office 4.01 EC4A 1BR London 1 Fetter Lane United Kingdom |
| NORDIC INVEST LTD | 09 oct. 2015 | 13 nov. 2019 | Dissoute | Secrétaire | 1 Fetter Lane EC4A 1BR London Office 4.01 United Kingdom |
| MELTON ALLIANCE LTD | 18 janv. 2016 | 28 janv. 2019 | Active | Secrétaire | 1 Fetter Lane EC4A 1BR London Office 4.01 United Kingdom |
| INTERNATIONAL SPACE SERVICES LTD | 22 juin 2011 | 03 avr. 2018 | Dissoute | Secrétaire | 8-12 Fleet House New Bridge Street EC4V 6AL London Room 4.08 United Kingdom |
| CORONA COLLECTOR LTD | 08 juin 2011 | 13 mars 2018 | Dissoute | Secrétaire | Fetter Lane EC4A 1BR London Room 4.01, 1 England |
| NEWBRIDGE TRADING LTD | 11 janv. 2011 | 11 janv. 2017 | Dissoute | Secrétaire | 1 Fetter Lane EC4A 1BR London Room 4.01 England |
| PETROS GLOBAL LTD | 05 janv. 2015 | 05 janv. 2016 | Dissoute | Secrétaire | 1 Fetter Lane EC4A 1BR London Room 4.01 United Kingdom |
| DORRIS LTD | 05 janv. 2012 | 05 janv. 2016 | Dissoute | Secrétaire | Fetter Lane EC4A 1BR London Room 4.01,1 England |
| MEDMARKET LTD | 06 déc. 2011 | 06 déc. 2015 | Dissoute | Secrétaire | 8-12 Fleet House New Bridge Street EC4V 6AL London Room 4.08 United Kingdom |
| LUXURIOUS HOTELS LTD | 03 nov. 2014 | 03 nov. 2015 | Dissoute | Secrétaire | 8-12 Fleet House New Bridge Street EC4V 6AL London Room 4.08 United Kingdom |
| ARTUR AYKKHORN LTD | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2015 | Dissoute | Secrétaire | 8-12 Fleet House New Bridge Street EC4V 6AL London Room 4.08 United Kingdom |
| REUNION ART & SCIENCE LTD | 23 oct. 2014 | 23 oct. 2015 | Dissoute | Secrétaire | 8-12 Fleet House New Bridge Street EC4V 6AL London Room 4.08 United Kingdom |
| SPECIALIST MEDIA CENTER LTD | 11 oct. 2013 | 11 oct. 2015 | Dissoute | Secrétaire | 8-12 Fleet House New Bridge Street EC4V 6AL London Room 4.08 United Kingdom |
| STILTON GROUP LIMITED | 10 sept. 2014 | 10 sept. 2015 | Dissoute | Secrétaire | 8 - 12 Fleet House New Bridge Street EC4V 6AL London Room 4. 08 United Kingdom |
| SOFTWARE DEVELOPMENT C.V. LIMITED | 14 juil. 2014 | 14 juil. 2015 | Dissoute | Secrétaire | 8-12 Fleet House New Bridge Street EC4V 6AL London Room 4.08 United Kingdom |
| CONSTRUCTION MACHINES LTD | 10 juin 2014 | 10 juin 2015 | Dissoute | Secrétaire | 8-12 Fleet House New Bridge Street EC4V 6AL London Room 4.08 United Kingdom |
| DESIGN AND SERVICE LIMITED | 26 janv. 2011 | 27 févr. 2015 | Dissoute | Secrétaire | Fleet House 8-12 New Bridge Street EC4V 6AL London 4.08 England |
| DIRECT DESIGN VISUAL BRANDING LTD | 16 janv. 2015 | 16 janv. 2015 | Dissoute | Secrétaire | Fetter Lane EC4A 1BR London Room 4.01, 1 England |
| DIRECT DESIGN VISUAL BRANDING LTD | 16 janv. 2013 | 16 janv. 2015 | Dissoute | Secrétaire | 8-12 Fleet House New Bridge Street EC4V 6AL London Room 4.08 United Kingdom |
| MIDWEST TRADE LTD | 03 janv. 2014 | 03 janv. 2015 | Dissoute | Secrétaire | Fetter Lane EC4A 1BR London Room 4.01, 1 England |
| VELES CAPITAL LTD | 24 oct. 2013 | 24 oct. 2014 | Dissoute | Secrétaire | 8-12 Fleet House New Bridge Street EC4V 6AL London Room 4.08 United Kingdom |
| HIGH TECHNOLOGY ENGINEERING LTD | 21 oct. 2013 | 21 oct. 2014 | Dissoute | Secrétaire | 8-12 Fleet House New Bridge Street EC4V 6AL London Room 4.08 United Kingdom |
| WESTLINEBUSINESS LTD | 16 oct. 2012 | 16 oct. 2014 | Dissoute | Secrétaire | 8-12 Fleet House New Bridge Street EC4V 6AL London Room 4.08 United Kingdom |
| NEXXUS PRODUCTION LTD | 04 janv. 2014 | 23 juil. 2014 | Dissoute | Secrétaire | Fetter Lane EC4A 1BR London Room 4.01, 1 England |
| DIMIRA SYSTEMS LTD | 23 juil. 2013 | 23 juil. 2014 | Dissoute | Secrétaire | 8-12 Fleet House New Bridge Street EC4V 6AL London Room 4.08 United Kingdom |
| WIWE & CO LTD | 29 mai 2013 | 29 mai 2014 | Dissoute | Secrétaire | 8-12 Fleet House New Bridge Street EC4V 6AL London Room 4.08 United Kingdom |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0