JUST NOMINEES LIMITED - Page 4
Dirigeant de société
Nom | JUST NOMINEES LIMITED |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 10 |
Inactif | 86 |
Démissionné | 73 |
Total | 169 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
RHONDA WOOTTEN CONSULTING LTD | 11 janv. 2007 | 07 janv. 2019 | Active | Secrétaire | Northside House Mount Pleasent EN4 9EB Barnet Suite 3b2, London United Kingdom |
PERSONA TRANSPORT LIMITED | 06 sept. 2010 | 02 nov. 2018 | Dissoute | Secrétaire | Northside House Mount Pleasant EN4 9EB London Suite 3b2 United Kingdom |
ADEEVO LIMITED | 30 sept. 2005 | 31 août 2017 | Active | Secrétaire | Northside House Mount Pleasant EN4 9EB Cockfosters Suite 3b2, Barnet |
SENSIFY SOLUTIONS LIMITED | 22 sept. 2014 | 14 juil. 2017 | Active | Secrétaire | Northside House Mount Pleasant EN4 9EB London Suite 3b2 United Kingdom |
MUSMUS LIMITED | 01 févr. 2008 | 23 avr. 2017 | Active | Secrétaire | Northside House Mount Pleasent EN4 9EB Barnet Suite 3b2, London United Kingdom |
DANIEL SANDLER LTD | 02 févr. 2005 | 05 oct. 2015 | Active | Secrétaire | Northside House Mount Pleasent EN4 9EB Barnet Suite 3b2, London United Kingdom |
NARRATO LIMITED | 17 sept. 2012 | 26 mars 2015 | Dissoute | Secrétaire | Northside House Mount Pleasant EN4 9EB Cockfosters Suite 3b2 Herts United Kingdom |
CONFIAR LIMITED | 01 août 2012 | 10 oct. 2014 | Liquidation | Secrétaire | Northside House Mount Pleasant EN4 9EB London Suite 3b2 United Kingdom |
GLOMMAN LIMITED | 05 sept. 2014 | 24 sept. 2014 | Dissoute | Secrétaire | Northside House Mount Pleasant EN4 9EB London Suite 3b2 United Kingdom |
STILL RIVER FILMS LTD | 20 juil. 2011 | 19 juil. 2014 | Active | Secrétaire | Northside House Mount Pleasant EN4 9EB Cockfosters Suite 3b2 Herts United Kingdom |
IXD CONSULTING LIMITED | 08 juin 2010 | 04 avr. 2014 | Dissoute | Secrétaire | Northside House Mount Pleasant EN4 9EB Cockfosters Suite 3b2 Herts United Kingdom |
BRIDGELIGHT CONNECT LIMITED | 27 mars 2012 | 27 mars 2014 | Dissoute | Secrétaire | Northside House Mount Pleasant EN4 9EB London Suite 3b2 United Kingdom |
SHAND FD LIMITED | 26 avr. 2010 | 13 sept. 2013 | Active | Secrétaire | Northside House Mount Pleasant EN4 9EB Cockfosters Suite 3b2, Barnet United Kingdom |
MDGD LIMITED | 04 janv. 2008 | 20 août 2013 | Dissoute | Secrétaire | Northside House Mount Pleasent EN4 9EB Barnet Suite 3b2, London United Kingdom |
ORIGIN MOBILE LIMITED | 19 juil. 2006 | 30 juin 2013 | Dissoute | Secrétaire | 2, Northside House Mount Pleasent EN4 9EB Barnet Suite 3b London United Kingdom |
FINDSYOU LIMITED | 28 févr. 2011 | 14 juin 2013 | Dissoute | Secrétaire | Northside House Mount Pleasant EN4 9EB London Suite 3b2 United Kingdom |
THE LONDON SCHOOL OF MAKE-UP LIMITED | 01 avr. 2000 | 26 févr. 2013 | Liquidation | Secrétaire | Northside House Mount Pleasent EN4 9EB Barnet Suite 3b2, London United Kingdom |
CHATTERIS COMPLEMENTARY HEALTH LIMITED | 12 oct. 2012 | 31 oct. 2012 | Active | Secrétaire | Mount Pleasant EN4 9EB Cockfosters Northside House Herts United Kingdom |
HOMESONICA LIMITED | 05 oct. 2012 | 10 oct. 2012 | Dissoute | Secrétaire | Northside House Mount Pleasant EN4 9EB Cockfosters Suite 3b2 Herts United Kingdom |
ATUM TECHNOLOGIES LIMITED | 10 sept. 2012 | 14 sept. 2012 | Active | Secrétaire | Northside House Mount Pleasant EN4 9EB Cockfosters Suite 3b2 Herts United Kingdom |
CHARLES B HOCKEN ASSOCIATES LIMITED | 11 juil. 2011 | 20 juin 2012 | Dissoute | Administrateur | Northside House Mount Pleasant EN4 9EB Cockfosters Suite 3b2 United Kingdom |
LANTERNS LOCATIONS LIMITED | 27 sept. 2010 | 25 avr. 2012 | Dissoute | Secrétaire | Northside House Mount Pleasant EN4 9EB London Suite 3b2 United Kingdom |
ROJA DOVE LIMITED | 29 sept. 2004 | 29 sept. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Barbican House 1st Floor, 26-34 Old Street EC1V 9QQ London |
ASHNORTHSIDE INVESTMENTS LIMITED | 04 mai 2010 | 05 mai 2010 | Dissoute | Administrateur | Northside House Moutn Pleasant EN4 9EB Cockfosters Suite 3b2, Herts. United Kingdom |
DROOL LIMITED | 24 déc. 2001 | 23 déc. 2009 | Dissoute | Secrétaire | Northside House Mount Pleasent EN4 9EB Barnet Suite 3b2, London United Kingdom |
NINETYTEN LIMITED | 10 juil. 2006 | 18 déc. 2008 | Dissoute | Secrétaire | First Floor Barbican House, 26-34 Old Street EC1V 9QQ London |
EREBUS LLP | 17 sept. 2008 | 06 nov. 2008 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | First Floor Barbican House 26-34 Old Street EC1V 9QQ London |
HAMMER HOLDINGS LIMITED | 18 juin 2003 | 30 juin 2008 | Active | Secrétaire | Barbican House 1st Floor, 26-34 Old Street EC1V 9QQ London |
BEAUTIQUE UK LIMITED | 14 févr. 2006 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Barbican House 26-34 Old Street EC1V 9QQ London |
C W NEWTON LIMITED | 11 juil. 2006 | 21 nov. 2007 | Active | Secrétaire | Barbican House 1st Floor, 26-34 Old Street EC1V 9QQ London |
BEAUTY PARTNERS LIMITED | 07 août 2006 | 03 sept. 2007 | Dissoute | Secrétaire | Barbican House 26-34 Old Street EC1V 9QQ London |
FABBRICA LIMITED | 27 oct. 2006 | 01 juil. 2007 | Dissoute | Secrétaire | Barbican House 26-34 Old Street EC1V 9QQ London |
WHITE COTTAGE LAKE LLP | 09 mai 2007 | 09 mai 2007 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | First Floor Barbican House 26-34 Old Street EC1V 9QQ London |
MAGPAR LLP | 30 mars 2007 | 30 mars 2007 | Liquidation | Membre désigné de la LLP | First Floor Barbican House 26-34 Old Street EC1V 9QQ London |
FAREWELL LDL LIMITED | 10 mai 2003 | 10 oct. 2006 | Dissoute | Secrétaire | Barbican House 26-34 Old Street EC1V 9QQ London |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0