Mohamed Arif HAMID
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Mohamed |
Deuxième prénom | Arif |
Nom de famille | HAMID |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 2 |
Inactif | 3 |
Démissionné | 31 |
Total | 36 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEW LODGE GARAGES MANAGEMENT CO. LIMITED | 28 nov. 2012 | Active | Chartered Accountant | Administrateur | 226 Kew Road Kew TW9 3LQ Richmond 6 Kew Lodge Surrey Uk | England | British | |
JACK MORTON UK LIMITED | 01 mars 1999 | Dissoute | Secrétaire | 11 Mackenzie Road B11 4EP Birmingham West Midlands | British | |||
SCH INTERNATIONAL LIMITED | 05 févr. 1999 | Dissoute | Secrétaire | 11 Mackenzie Road B11 4EP Birmingham West Midlands | British | |||
KEW LODGE MANAGEMENT CO.LIMITED | 26 janv. 1999 | Active | Director | Administrateur | 6 Kew Lodge 226 Kew Road TW9 3LQ Richmond Surrey | England | British | |
SPECTRUM COMMUNICATIONS LIMITED | 31 déc. 1998 | Dissoute | Secrétaire | 11 Mackenzie Road B11 4EP Birmingham West Midlands | British | |||
THE BROOKLYN BROTHERS LIMITED | 05 févr. 2016 | 11 déc. 2018 | Active | Director | Administrateur | Grosvenor Gardens SW1W 0BD London 3 England | England | British |
VIRGO HEALTH LIMITED | 05 juil. 2012 | 11 déc. 2018 | Active | Director | Administrateur | Kew Road TW9 3LQ Richmond 6 Kew Lodge 226 Surrey United Kingdom | England | British |
AMS ADVANCED MARKETING SERVICES LIMITED | 22 sept. 2011 | 11 déc. 2018 | Active | Director | Administrateur | Grosvenor Gardens SW1W 0BD London 3 England | England | British |
IPG DXTRA GROUP HOLDINGS LIMITED | 22 sept. 2011 | 11 déc. 2018 | Active | Director | Administrateur | Grosvenor Gardens SW1W 0BD London 3 England | England | British |
AMS ADVANCED MARKETING SERVICES INVESTMENTS LIMITED | 21 sept. 2010 | 11 déc. 2018 | Active | Director | Administrateur | Grosvenor Gardens SW1W 0BD London 3 England | England | British |
GOLIN LIMITED | 21 sept. 2010 | 11 déc. 2018 | Active | Director | Administrateur | Grosvenor Gardens SW1W 0BD London 3 England | England | British |
FOX IPL LIMITED | 18 nov. 2009 | 11 déc. 2018 | Active | Director | Administrateur | Grosvenor Gardens SW1W 0BD London 3 England | England | British |
IPG DXTRA (UK) LIMITED | 15 oct. 2009 | 11 déc. 2018 | Active | Director | Administrateur | Grosvenor Gardens SW1W 0BD London 3 England | England | British |
CMGRP MARKETING SERVICES LIMITED | 21 sept. 2010 | 11 déc. 2018 | Dissoute | Director | Administrateur | Grosvenor Gardens SW1W 0BD London 3 England | England | British |
WEBER SHANDWICK INTERNATIONAL LTD | 21 sept. 2010 | 11 déc. 2018 | Liquidation | Director | Administrateur | Grosvenor Gardens SW1W 0BD London 3 | England | British |
SPRINGPOINT UK LIMITED | 21 sept. 2010 | 11 déc. 2018 | Liquidation | Director | Administrateur | Grosvenor Gardens SW1W 0BD London 3 England | England | British |
WELLSET REPRO LIMITED | 31 août 2016 | 05 oct. 2018 | Active | Director | Administrateur | 116 High Street GU6 8AJ Cranleigh East Lodge House Surrey | England | British |
OCTAGON WORLDWIDE LIMITED | 21 oct. 2011 | 31 déc. 2017 | Active | Director | Administrateur | Grosvenor Gardens SW1W 0BD London 3 England | England | British |
JACK MORTON WORLDWIDE LIMITED | 18 mars 1998 | 31 déc. 2017 | Active | Director | Administrateur | 16-18 Acton Park Industrial Estate W3 7QE The Vale London | England | British |
JACK MORTON EUROPE LIMITED | 16 janv. 1998 | 31 déc. 2017 | Dissoute | Chartered Accountant | Administrateur | 16-18 Acton Park Industrial Esta The Vale W3 7QE London | England | British |
TALE LIMITED | 31 août 2016 | 27 nov. 2017 | Dissoute | Director | Administrateur | 116 High Street GU6 8AJ Cranleigh East Lodge House Surrey | England | British |
IMPACT IMAGE LIMITED | 31 août 2016 | 27 nov. 2017 | Dissoute | Director | Administrateur | 116 High Street GU6 8AJ Cranleigh East Lodge House Surrey | England | British |
IPG STUDIOS UK LIMITED | 11 avr. 2014 | 18 juil. 2017 | Active | Director | Administrateur | Grosvenor Gardens SW1W 0BD London 3 | England | British |
VIRGO HOLDINGS LTD | 05 juil. 2012 | 24 sept. 2013 | Dissoute | Director | Administrateur | Kew Road TW9 3LQ Richmond 6 Kew Lodge 226 Surrey United Kingdom | England | British |
FUSE LTD | 20 déc. 2011 | 04 sept. 2013 | Dissoute | Director | Administrateur | Kew Lodge 226 Kew Road TW9 3LQ Richmond 6 Surrey United Kingdom | England | British |
BRANDS BANDS AND FANS LIMITED | 02 mars 2012 | 03 sept. 2013 | Dissoute | Director | Administrateur | 226 Kew Road TW9 3LQ Richmond 6 Kew Lodge Surrey United Kingdom | England | British |
FRUKT LIMITED | 02 mars 2012 | 03 sept. 2013 | Dissoute | Director | Administrateur | 226 Kew Road TW9 3LQ Richmond 6 Kew Lodge Surrey United Kingdom | England | British |
JACK MORTON WORLDWIDE LIMITED | 01 mars 1999 | 31 déc. 2009 | Active | Secrétaire | 6 Kew Lodge 226 Kew Road TW9 3LQ Richmond Surrey | British | ||
JACK MORTON EUROPE LIMITED | 01 mars 1999 | 18 mai 2009 | Dissoute | Secrétaire | 11 Mackenzie Road B11 4EP Birmingham West Midlands | British | ||
SCREEN AND MUSIC TRAVEL LIMITED | 20 août 1999 | 01 nov. 2000 | Active | Chartered Accountant | Administrateur | 11 Mackenzie Road B11 4EP Birmingham West Midlands | England | British |
VISUAL ACTION HOLDINGS | 01 mars 1999 | 20 avr. 2000 | Active | Secrétaire | 11 Mackenzie Road B11 4EP Birmingham West Midlands | British | ||
AVSC EUROPE LIMITED | 15 oct. 1998 | 20 avr. 2000 | Active | Secrétaire | 6 Kew Lodge 226 Kew Road TW9 3LQ Richmond Surrey | British | ||
SCH INTERNATIONAL LIMITED | 14 févr. 1997 | 01 juil. 1997 | Dissoute | Finance Director | Secrétaire | 11 Mackenzie Road B11 4EP Birmingham West Midlands | British | |
SPECTRUM COMMUNICATIONS LIMITED | 14 févr. 1997 | 01 juil. 1997 | Dissoute | Finance Director | Secrétaire | 11 Mackenzie Road B11 4EP Birmingham West Midlands | British | |
SCH INTERNATIONAL LIMITED | 13 juin 1996 | 01 juil. 1997 | Dissoute | Chartered Surveyor | Administrateur | 11 Mackenzie Road B11 4EP Birmingham West Midlands | England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0