SCH INTERNATIONAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSCH INTERNATIONAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02467201
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SCH INTERNATIONAL LIMITED ?

    • (9305) /

    Où se situe SCH INTERNATIONAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    FISHER PARTNERS
    Acre House 11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SCH INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JACK MORTON WORLDWIDE LIMITED14 août 200014 août 2000
    SCH INTERNATIONAL LIMITED11 sept. 199211 sept. 1992
    SPECTRUM COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED16 juil. 199016 juil. 1990
    DRIVETAPE LIMITED05 févr. 199005 févr. 1990

    Quels sont les derniers comptes de SCH INTERNATIONAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour SCH INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    15 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 oct. 2009

    5 pages4.68

    legacy

    1 pages287

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 23 oct. 2008

    LRESSP

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    2 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    2 pagesAA

    legacy

    1 pages353

    legacy

    7 pages363s

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    2 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2004

    2 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    Qui sont les dirigeants de SCH INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BEAN, Louise
    18 Newbury Close
    DA2 6AQ Dartford
    Kent
    Secrétaire
    18 Newbury Close
    DA2 6AQ Dartford
    Kent
    British88994320002
    HAMID, Mohamed Arif
    11 Mackenzie Road
    B11 4EP Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    11 Mackenzie Road
    B11 4EP Birmingham
    West Midlands
    British51714150001
    HARRY III, William
    The Brake House
    Back Lane
    CV37 8SF Lower Quinton
    Warwickshire
    Administrateur
    The Brake House
    Back Lane
    CV37 8SF Lower Quinton
    Warwickshire
    EnglandAmerican117064700001
    BERNERS-PRICE, Peter Devonald
    White Gates Common Wood
    WD4 9BB Kings Langley
    Hertfordshire
    Secrétaire
    White Gates Common Wood
    WD4 9BB Kings Langley
    Hertfordshire
    British61833410001
    CALCOTT, Ronald
    The Haven Altwood Bailey
    SL6 4PQ Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    The Haven Altwood Bailey
    SL6 4PQ Maidenhead
    Berkshire
    British4221120001
    HAMID, Mohamed Arif
    11 Mackenzie Road
    B11 4EP Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    11 Mackenzie Road
    B11 4EP Birmingham
    West Midlands
    British51714150001
    SCHWARTZ, Harold
    23 West 73rd Street
    Apartment 706-A
    10023 New York
    Ny
    Usa
    Secrétaire
    23 West 73rd Street
    Apartment 706-A
    10023 New York
    Ny
    Usa
    American53562220003
    BERNERS-PRICE, Peter Devonald
    White Gates Common Wood
    WD4 9BB Kings Langley
    Hertfordshire
    Administrateur
    White Gates Common Wood
    WD4 9BB Kings Langley
    Hertfordshire
    United KingdomBritish61833410001
    BUSSY, Bernard
    Woodlands House Whittle Close
    Forest End Road
    GU17 8JT Sandhurst
    Surrey
    Administrateur
    Woodlands House Whittle Close
    Forest End Road
    GU17 8JT Sandhurst
    Surrey
    British4221140001
    CALCOTT, Ronald
    The Haven Altwood Bailey
    SL6 4PQ Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    The Haven Altwood Bailey
    SL6 4PQ Maidenhead
    Berkshire
    British4221120001
    CRAWFORD, Anthony
    The End House Parsons Wood
    Parsonage Lane
    SL2 3NZ
    Administrateur
    The End House Parsons Wood
    Parsonage Lane
    SL2 3NZ
    British4318170001
    CRONEEN, Laurence Victor
    5 Broomhouse Road
    SW6 3QU London
    Administrateur
    5 Broomhouse Road
    SW6 3QU London
    United KingdomBritish63310130002
    CRONEEN, Laurence Victor
    5 Broomhouse Road
    SW6 3QU London
    Administrateur
    5 Broomhouse Road
    SW6 3QU London
    United KingdomBritish63310130002
    DIGNAM, Arthur
    2255 Sherman Avenue
    North Merrick New York 11566
    United States Of America
    Administrateur
    2255 Sherman Avenue
    North Merrick New York 11566
    United States Of America
    America49151370001
    ELLIOTT, Timothy
    66 Cumberland Road
    Hanwell
    W7 2EB London
    Administrateur
    66 Cumberland Road
    Hanwell
    W7 2EB London
    British67673980001
    EVANS, Rupert
    Spectrum Communications Plc
    PO BOX 14208 Bin Khedia Centre 3rd
    Floor Al Garhoud Bridge Croad
    Dubai
    Administrateur
    Spectrum Communications Plc
    PO BOX 14208 Bin Khedia Centre 3rd
    Floor Al Garhoud Bridge Croad
    Dubai
    British49151840002
    HAMID, Arif
    6 Kew Lodge
    226 Kew Road
    TW9 3LQ Richmond
    Surrey
    Administrateur
    6 Kew Lodge
    226 Kew Road
    TW9 3LQ Richmond
    Surrey
    British80328030001
    HAMID, Mohamed Arif
    11 Mackenzie Road
    B11 4EP Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    11 Mackenzie Road
    B11 4EP Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish51714150001
    HOLTZ, Norman
    469 Brookline Street
    02459 Newton Center
    Massachusetts
    Usa
    Administrateur
    469 Brookline Street
    02459 Newton Center
    Massachusetts
    Usa
    Usa70742250001
    INGLEBY, Raymond Simon
    Flat 57 Abbey Lodge
    Park Road
    NW8 7RL London
    Administrateur
    Flat 57 Abbey Lodge
    Park Road
    NW8 7RL London
    United KingdomBritish73515570001
    MASON, Debra Schneider
    300 East 54th Street 4k
    New York
    10022
    America
    Administrateur
    300 East 54th Street 4k
    New York
    10022
    America
    United KingdomAmerican251723400001
    MCCALL, Joseph
    42 Glezen Lane
    01778 Wayland
    Massachusetts
    Usa
    Administrateur
    42 Glezen Lane
    01778 Wayland
    Massachusetts
    Usa
    United StatesAmerican70741140001
    PENTONY-WOOLWICH, Martin
    11 Kingsley Avenue
    GU15 2NA Camberley
    Surrey
    Administrateur
    11 Kingsley Avenue
    GU15 2NA Camberley
    Surrey
    British37722320001
    PHILBIN, Kevin
    28 Dingle Road
    Middleton
    M24 1NH Manchester
    Administrateur
    28 Dingle Road
    Middleton
    M24 1NH Manchester
    United KingdomBritish95735720001
    SHEPHERD, Brian George
    The Old Malt House
    South Side
    OX25 4RT Steeple Aston
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Old Malt House
    South Side
    OX25 4RT Steeple Aston
    Oxfordshire
    United KingdomBritish101648160001
    SWAN, Paul
    Woodlands Hollybush Hill
    Stoke Poges
    SL2 4QN Slough
    Berkshire
    Administrateur
    Woodlands Hollybush Hill
    Stoke Poges
    SL2 4QN Slough
    Berkshire
    British4221150001
    THOMPSON, John Allan
    1 Victoria Square
    SW1W 0QY London
    Administrateur
    1 Victoria Square
    SW1W 0QY London
    Australian29254280001
    WALLACE, Mark
    Woodmans Cottage Fingest Road
    Frieth
    RG9 6PU Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Woodmans Cottage Fingest Road
    Frieth
    RG9 6PU Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish61959290001
    WALLWORK, Simon John
    5 Thatcher Close
    Bowdon
    WA14 3FX Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    5 Thatcher Close
    Bowdon
    WA14 3FX Altrincham
    Cheshire
    British57880660003

    SCH INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental mortgage.
    Créé le 15 juil. 1993
    Livré le 23 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By the supplemental memorandum of deposit the company charges :- the shares -please see doc for full details.
    Personnes ayant droit
    • Girocredit Bank Aktiengellschaft Der Sparkassen,
    Transactions
    • 23 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture.
    Créé le 15 juil. 1993
    Livré le 23 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Please see doc for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Girocredit Bank Aktiengellschaft Der Sparkassen.
    Transactions
    • 23 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of deposit
    Créé le 16 mai 1990
    Livré le 24 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of loan agreement dated 6/4/90. and/or this charge.
    Brèves mentions
    For more details see form 395 ref M5. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Girozentrale Und Bank Der Osterreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 24 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 24 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 mai 1990
    Livré le 24 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under terms of loan agreement dated 6/4/90 and/or this debenture
    Brèves mentions
    All of the companys right title and interest in and to the shares stocks bonds debentures certificates of deposit & other securities of any kind of spectrum communications limited.
    Personnes ayant droit
    • Girozentral Und Bank Der Osterreichischen Sparkassen Aktiengellschaft
    Transactions
    • 24 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 24 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SCH INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 oct. 2008Commencement of winding up
    23 mai 2010Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Birne
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    practitioner
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Stephen Mark Katz
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    practitioner
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Brian N Johnson
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    practitioner
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0