INVENSYS SECRETARIES LIMITED - Page 8
Dirigeant de société
Nom | INVENSYS SECRETARIES LIMITED |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 94 |
Inactif | 158 |
Démissionné | 168 |
Total | 420 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
SOUTH WALES SWITCHGEAR LIMITED | 03 févr. 1992 | Dissoute | Secrétaire | 40 Grosvenor Place SW1X 7AW London 3rd Floor | |
FOLLAND AIRCRAFT LIMITED | 03 févr. 1992 | Dissoute | Secrétaire | Portland House Bressenden Place SW1E 5BF London | |
INVENSYS PENSION TRUSTEE LIMITED | Active | Secrétaire | 80 Victoria Street SW1E 5JL London 2nd Floor United Kingdom | ||
SINGLEHURST HOLDINGS LIMITED | Dissoute | Secrétaire | Floor 40 Grosvenor Place SW1X 7AW London 3rd | ||
ROBERT KELLIE & SON LIMITED | Dissoute | Secrétaire | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London | ||
CHARLTON-LESLIE ENGINEERING OFFSHORE LIMITED | 14 févr. 1990 | Dissoute | Secrétaire | Floor 40 Grosvenor Place SW1X 7AW London 3rd Great Britain | |
SORBO TWELVE LIMITED | 14 févr. 1990 | Dissoute | Secrétaire | Floor 40 Grosvenor Place SW1X 7AW London 3rd | |
ETAP AUTOMATION LTD | 22 juin 2022 | 09 mai 2024 | Active | Secrétaire | Stafford Park 5 TF3 3BL Telford Schneider Electric England |
YAGEO TMSS UK LTD | 02 mars 2022 | 31 oct. 2023 | Active | Secrétaire | Stafford Park TF3 3BL Telford 5 Shropshire United Kingdom |
EUROTHERM LIMITED | 31 oct. 2000 | 31 oct. 2022 | Active | Secrétaire | Stafford Park 5 TF3 3BL Telford Schneider Electric England |
AVTRON LOADBANK WORLDWIDE CO., LTD | 01 déc. 2017 | 28 oct. 2022 | Active | Secrétaire | Stafford Park 5 TF3 3BL Telford Schneider Electric England |
N.J.FROMENT & CO.LIMITED | 01 déc. 2017 | 28 oct. 2022 | Active | Secrétaire | Stafford Park 5 TF3 3BL Telford Schneider Electric England |
IMSERV EUROPE LIMITED | 08 nov. 1999 | 07 sept. 2021 | Active | Secrétaire | Victoria Street 3rd Floor SW1E 5JL London 2nd Floor 80 United Kingdom |
RANCO CONTROLS LIMITED | 23 févr. 2000 | 18 déc. 2019 | Active | Secrétaire | 80 Victoria Street SW1E 5JL London 2nd Floor United Kingdom |
OLD COMPANY 21 LIMITED | 23 févr. 2000 | 18 déc. 2019 | Dissoute | Secrétaire | Victoria Street SW1E 5JL London 2nd Floor 80 United Kingdom |
AVEVA SOFTWARE GB LIMITED | 13 oct. 2012 | 26 oct. 2018 | Active | Secrétaire | Victoria Street SW1E 5JL London 2nd Floor, 80 England |
SIEMENS RAIL AUTOMATION LIMITED | 31 oct. 1993 | 02 mai 2013 | Active | Secrétaire | Grosvenor Place 3rd Floor SW1X 7AW London 40 |
SIEMENS MOBILITY LIMITED | 31 oct. 1993 | 02 mai 2013 | Active | Secrétaire | 40 Grosvenor Place SW1X 7AW London 3rd Floor |
DNA (HOUSEMARKS) LIMITED | 13 oct. 2009 | Active | Secrétaire | Portland House Bressenden Place SW1E 5BF London | |
SPX FLOW TECHNOLOGY LONDON LIMITED | 23 févr. 2000 | 31 déc. 2007 | Active | Secrétaire | Portland House Bressenden Place SW1E 5BF London |
APV OVERSEAS HOLDINGS LIMITED | 31 mars 1999 | 31 déc. 2007 | Active | Secrétaire | Portland House Bressenden Place SW1E 5BF London |
SOUTH EASTERN EUROPE SERVICES LIMITED | 31 mars 1999 | 31 déc. 2007 | Dissoute | Secrétaire | Portland House Bressenden Place SW1E 5BF London |
SPX FLOW TECHNOLOGY CRAWLEY LIMITED | 31 mars 1999 | 31 déc. 2007 | Dissoute | Secrétaire | Portland House Bressenden Place SW1E 5BF London |
TDK-LAMBDA UK LIMITED | 19 mai 2000 | 30 sept. 2005 | Active | Secrétaire | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London |
LAMBDA FAR EAST LIMITED | 24 mai 1999 | 30 sept. 2005 | Dissoute | Secrétaire | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London |
TAC PRODUCTS LIMITED | 23 févr. 2000 | 29 juil. 2005 | Active | Secrétaire | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London |
VAPOUR MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED | 31 mars 1999 | 31 mars 2005 | Dissoute | Secrétaire | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London |
HANSEN TRANSMISSIONS LIMITED | 30 juin 2004 | Dissoute | Secrétaire | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London | |
EATON POWER SYSTEMS LIMITED | 29 mars 2001 | 09 juin 2004 | Dissoute | Secrétaire | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London |
EATON POWER HOLDINGS LIMITED | 08 mars 2001 | 09 juin 2004 | Dissoute | Secrétaire | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London |
EATON POWER SOLUTIONS LIMITED | 14 déc. 2000 | 09 juin 2004 | Dissoute | Secrétaire | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London |
SOLA (UK) LIMITED | 30 déc. 1999 | 09 juin 2004 | Dissoute | Secrétaire | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London |
REGIS POWER LIMITED | 31 mars 1999 | 09 juin 2004 | Dissoute | Secrétaire | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London |
EATON POWER QUALITY LIMITED | 28 mai 1998 | 09 juin 2004 | Dissoute | Secrétaire | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London |
FISKARS ELECTRONICS LIMITED | 28 mai 1998 | 09 juin 2004 | Dissoute | Secrétaire | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0