Christopher John HORTON - Page 2
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Christopher |
Deuxième prénom | John |
Nom de famille | HORTON |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 3 |
Inactif | 1 |
Démissionné | 60 |
Total | 64 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBSON WASTE COMPANY LIMITED (THE) | 01 sept. 1994 | 31 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | Ashwood 37 Elliotts Lane Codsall WV8 1PG Wolverhampton | British | ||
C.H.PINCHES AND SONS LIMITED | 01 sept. 1994 | 31 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | Ashwood 37 Elliotts Lane Codsall WV8 1PG Wolverhampton | British | ||
SUMMERDOWN LIMITED | 01 sept. 1994 | 31 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | Ashwood 37 Elliotts Lane Codsall WV8 1PG Wolverhampton | British | ||
DERBY WASTE DISPOSAL COMPANY LIMITED | 01 sept. 1994 | 31 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | Ashwood 37 Elliotts Lane Codsall WV8 1PG Wolverhampton | British | ||
MAYBROOK TRANSPORT LIMITED | 01 sept. 1994 | 31 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | Ashwood 37 Elliotts Lane Codsall WV8 1PG Wolverhampton | British | ||
EFFLUENT DISPOSAL LIMITED | 01 sept. 1994 | 31 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | Ashwood 37 Elliotts Lane Codsall WV8 1PG Wolverhampton | British | ||
ACTION WASTE LIMITED | 01 sept. 1994 | 31 août 1998 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Ashwood 37 Elliotts Lane Codsall WV8 1PG Wolverhampton | British | |
LEIGH CHURCH LAWFORD LIMITED | 01 sept. 1994 | 31 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | Ashwood 37 Elliotts Lane Codsall WV8 1PG Wolverhampton | British | ||
BRIDE (CHURCH LAWFORD) LIMITED | 01 sept. 1994 | 31 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | Ashwood 37 Elliotts Lane Codsall WV8 1PG Wolverhampton | British | ||
CARTAWAYS LIMITED | 01 sept. 1994 | 31 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | Ashwood 37 Elliotts Lane Codsall WV8 1PG Wolverhampton | British | ||
EMPIRE BRICK AND TILE COMPANY,LIMITED(THE) | 01 sept. 1994 | 31 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | Ashwood 37 Elliotts Lane Codsall WV8 1PG Wolverhampton | British | ||
GERRARDS CROSS WASTE DISPOSAL LIMITED | 01 sept. 1994 | 31 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | Ashwood 37 Elliotts Lane Codsall WV8 1PG Wolverhampton | British | ||
VEOLIA SUPPORT SERVICES UK LIMITED | 01 sept. 1994 | 31 août 1998 | Liquidation | Secrétaire | Ashwood 37 Elliotts Lane Codsall WV8 1PG Wolverhampton | British | ||
ELLIS DAVIES & SONS LIMITED | 01 sept. 1994 | 31 août 1998 | Liquidation | Secrétaire | Ashwood 37 Elliotts Lane Codsall WV8 1PG Wolverhampton | British | ||
POLYMERIC TREATMENTS LIMITED | 01 sept. 1994 | 11 juil. 1996 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Ashwood 37 Elliotts Lane Codsall WV8 1PG Wolverhampton | British | |
ONYX HIGHMOOR LIMITED | 29 mars 1995 | 30 mars 1995 | Active | Cs | Administrateur | 72 Clumber Street Kirkby In Ashfield NG17 7NG Nottingham Nottinghamshire | British | |
VAILLANT HOLDINGS LIMITED | 01 juin 1994 | 31 août 1994 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 72 Clumber Street Kirkby In Ashfield NG17 7NG Nottingham Nottinghamshire | British | |
VAILLANT EUROPEAN HOLDINGS LIMITED | 01 juin 1994 | 31 août 1994 | Active | Secrétaire | 72 Clumber Street Kirkby In Ashfield NG17 7NG Nottingham Nottinghamshire | British | ||
HYTHE PARK (COLCHESTER) LIMITED | 21 déc. 1993 | 31 août 1994 | Active | Secrétaire | 22 Clumber Street Kirkby In Ashfield NG17 7NG Nottingham Nottinghamshire | British | ||
VAILLANT NETHERLANDS HOLDINGS LIMITED | 31 août 1994 | Active | Secrétaire | 72 Clumber Street Kirkby In Ashfield NG17 7NG Nottingham Nottinghamshire | British | |||
VAILLANT R & M LIMITED | 31 août 1994 | Active | Secrétaire | 72 Clumber Street Kirkby In Ashfield NG17 7NG Nottingham Nottinghamshire | British | |||
TAPTON PROPERTIES LTD | 31 août 1994 | Active | Secrétaire | 72 Clumber Street Kirkby In Ashfield NG17 7NG Nottingham Nottinghamshire | British | |||
VAILLANT GROUP SERVICES LIMITED | 01 juin 1994 | 31 août 1994 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 72 Clumber Street Kirkby In Ashfield NG17 7NG Nottingham Nottinghamshire | British | |
VAILLANT NOMINEE LIMITED | 01 juin 1994 | 31 août 1994 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 72 Clumber Street Kirkby In Ashfield NG17 7NG Nottingham Nottinghamshire | British | |
GENEFAX LIMITED | 01 juin 1994 | 31 août 1994 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 72 Clumber Street Kirkby In Ashfield NG17 7NG Nottingham Nottinghamshire | British | |
HSS HOLDINGS LIMITED | 31 août 1994 | Dissoute | Secrétaire | 72 Clumber Street Kirkby In Ashfield NG17 7NG Nottingham Nottinghamshire | British | |||
HEPWORTH ENGINEERING LIMITED | 31 août 1994 | Dissoute | Secrétaire | 72 Clumber Street Kirkby In Ashfield NG17 7NG Nottingham Nottinghamshire | British | |||
TILSLEY & LOVATT LIMITED | 31 août 1994 | Dissoute | Secrétaire | 72 Clumber Street Kirkby In Ashfield NG17 7NG Nottingham Nottinghamshire | British | |||
VAILLANT PRODUCTS LIMITED | 31 août 1994 | Dissoute | Secrétaire | 72 Clumber Street Kirkby In Ashfield NG17 7NG Nottingham Nottinghamshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0