Jeremy Andrew ARON
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Jeremy |
Deuxième prénom | Andrew |
Nom de famille | ARON |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 2 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 30 |
Total | 32 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAIN TUMOUR RESEARCH | 06 juin 2017 | Active | Solicitor | Administrateur | Moss Lane HA5 3AX Pinner 48 England | United Kingdom | British | |
ARON COMMERCIAL ENTERPRISES LIMITED | 14 janv. 2016 | Active | Solicitor | Administrateur | HA5 3AX Pinner 48 Moss Lane Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | |
DS SMITH PENSION TRUSTEES LIMITED | 03 sept. 2020 | 16 juin 2022 | Active | Solicitor | Administrateur | Euston Road NW1 3AX London 350 | United Kingdom | British |
THE LESS PACKAGING COMPANY LTD. | 20 nov. 2018 | 29 mai 2020 | Active | Solicitor | Administrateur | Moss Lane HA5 3AX Pinner 48 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British |
TMS GLOBAL UK LIMITED | 19 févr. 2018 | 29 mai 2020 | Active | Solicitor | Administrateur | Moss Lane HA5 3AX Pinner 48 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British |
TOTAL MARKETING SUPPORT LIMITED | 15 nov. 2017 | 29 mai 2020 | Active | Solicitor | Administrateur | Moss Lane HA5 3AX Pinner 48 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British |
TOTAL MARKETING SUPPORT GLOBAL LIMITED | 15 nov. 2017 | 29 mai 2020 | Active | Solicitor | Administrateur | Moss Lane HA5 3AX Pinner 48 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British |
THE BRAND COMPLIANCE COMPANY LIMITED | 20 nov. 2018 | 29 mai 2020 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Moss Lane HA5 3AX Pinner 48 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British |
HAWK-EYE INNOVATIONS LIMITED | 17 juil. 2001 | 01 juil. 2002 | Active | Solicitor | Secrétaire | 48 Moss Lane HA5 3AX Pinner Middlesex | British | |
SGCS SALES AND SERVICES LIMITED | 18 mars 2002 | 01 juil. 2002 | Liquidation | Solicitor | Administrateur | 48 Moss Lane HA5 3AX Pinner Middlesex | United Kingdom | British |
LANDIS + GYR (STOCKPORT) LIMITED | 01 févr. 2002 | 21 mai 2002 | Active | Solicitor | Administrateur | 48 Moss Lane HA5 3AX Pinner Middlesex | United Kingdom | British |
LANDIS + GYR (STOCKPORT) LIMITED | 28 sept. 2000 | 21 mai 2002 | Active | Secrétaire | 34 Wakehams Hill HA5 3BQ Pinner Middlesex | British | ||
SIEMENS ENERGY SERVICES LIMITED | 09 avr. 2001 | 22 mars 2002 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | 48 Moss Lane HA5 3AX Pinner Middlesex | United Kingdom | British |
FUJITSU (FTS) LIMITED | 06 sept. 1999 | 12 nov. 1999 | Active | Solicitor | Administrateur | 34 Wakehams Hill HA5 3BQ Pinner Middlesex | British | |
FUJITSU (FTS) LIMITED | 06 sept. 1999 | 12 nov. 1999 | Active | Solicitor | Secrétaire | 34 Wakehams Hill HA5 3BQ Pinner Middlesex | British | |
HUGHES TOOL COMPANY LIMITED | 24 sept. 1996 | 01 mars 1999 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | 48 Cuckoo Hill Drive HA5 3PJ Pinner Middlesex | British | |
BFCC LIMITED | 17 mars 1995 | 18 nov. 1998 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | 48 Cuckoo Hill Drive HA5 3PJ Pinner Middlesex | British | |
BAKER HUGHES UK PENSION TRUSTEES LIMITED | 05 janv. 1996 | 08 oct. 1998 | Active | Solicitor | Secrétaire | 48 Cuckoo Hill Drive HA5 3PJ Pinner Middlesex | British | |
BAKER PETROLITE LIMITED | 31 déc. 1997 | 20 août 1998 | Active | Lawyer | Secrétaire | 48 Cuckoo Hill Drive HA5 3PJ Pinner Middlesex | British | |
BAKER HUGHES LIMITED | 21 nov. 1994 | 20 août 1998 | Active | Secrétaire | 48 Cuckoo Hill Drive HA5 3PJ Pinner Middlesex | British | ||
BH 04 LIMITED | 27 janv. 1998 | 20 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | 48 Cuckoo Hill Drive HA5 3PJ Pinner Middlesex | British | ||
R & B FILTRATION SYSTEMS LIMITED | 17 déc. 1997 | 20 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | 48 Cuckoo Hill Drive HA5 3PJ Pinner Middlesex | British | ||
VORTOIL SEPARATION SYSTEMS LIMITED | 01 avr. 1996 | 20 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | 48 Cuckoo Hill Drive HA5 3PJ Pinner Middlesex | British | ||
NORTH SEA GEOPHYSICAL LIMITED | 06 juil. 1995 | 20 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | 48 Cuckoo Hill Drive HA5 3PJ Pinner Middlesex | British | ||
BFCC LIMITED | 17 mars 1995 | 20 août 1998 | Dissoute | Solicitor | Secrétaire | 48 Cuckoo Hill Drive HA5 3PJ Pinner Middlesex | British | |
HUGHES TOOL COMPANY LIMITED | 18 nov. 1994 | 20 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | 48 Cuckoo Hill Drive HA5 3PJ Pinner Middlesex | British | ||
BAKER SERVICE TOOLS LTD. | 18 nov. 1994 | 20 août 1998 | Dissoute | Company Director | Secrétaire | 48 Cuckoo Hill Drive HA5 3PJ Pinner Middlesex | British | |
BAKER PRODUCTION SERVICES (UK) LIMITED | 18 nov. 1994 | 20 août 1998 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 48 Cuckoo Hill Drive HA5 3PJ Pinner Middlesex | British | |
TRI-STATE OIL TOOL (U.K.) LIMITED | 18 nov. 1994 | 20 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | 48 Cuckoo Hill Drive HA5 3PJ Pinner Middlesex | British | ||
BAKER INTERNATIONAL LIMITED | 18 nov. 1994 | 20 août 1998 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 48 Cuckoo Hill Drive HA5 3PJ Pinner Middlesex | British | |
BAKER OIL TOOLS (UNITED KINGDOM) LIMITED | 18 nov. 1994 | 20 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | 48 Cuckoo Hill Drive HA5 3PJ Pinner Middlesex | British | ||
EIMCO PROCESS EQUIPMENT LIMITED | 18 nov. 1994 | 20 août 1998 | Dissoute | Secrétaire | 48 Cuckoo Hill Drive HA5 3PJ Pinner Middlesex | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0