BAKER HUGHES UK PENSION TRUSTEES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BAKER HUGHES UK PENSION TRUSTEES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC073307 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BAKER HUGHES UK PENSION TRUSTEES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Kirkhill Road Kirkhill Industrial Estate Dyce AB21 0GQ Aberdeen Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BAKER HUGHES UK PENSION TRUSTEES LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BAKER HUGHES UK PENSION TRUSTEES LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 30 sept. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 oct. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 30 sept. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour BAKER HUGHES UK PENSION TRUSTEES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2024 | 2 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Barry John Irvine en tant que directeur le 01 mai 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023 | 2 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr James Overton en tant qu'administrateur le 04 sept. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de James Richardson en tant que directeur le 31 août 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 2 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Matthew Gray en tant qu'administrateur le 21 sept. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 2 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Alasdair Murray Campbell Sloan en tant que directeur le 30 nov. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Chandler le 25 nov. 2021 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Lorraine Amanda Dunlop le 25 nov. 2021 | 1 pages | CH03 | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 2 pages | AA | ||
Modification des détails de Baker Hughes Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juil. 2021 | 2 pages | PSC05 | ||
Cessation de la nomination de Mark Freeman en tant que directeur le 31 déc. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 2 pages | AA | ||
Nomination de Mr Alasdair Murray Campbell Sloan en tant qu'administrateur le 01 janv. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Gary Philip Douglas en tant que directeur le 31 déc. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 2 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de BAKER HUGHES UK PENSION TRUSTEES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNLOP, Lorraine Amanda | Secrétaire | 245 Hammersmith Road W6 8PW London 10th Floor England | 244785130001 | |||||||||||
| CHANDLER, Timothy | Administrateur | 245 Hammersmith Road W6 8PW London 10th Floor England | England | British | 244786470001 | |||||||||
| DOBBY, Aaron | Administrateur | Kirkhill Industrial Estate Dyce AB21 0GQ Aberdeen Kirkhill Road Scotland | Scotland | British | 230668190001 | |||||||||
| GRAY, Matthew | Administrateur | Kirkhill Industrial Estate Dyce AB21 0GQ Aberdeen Kirkhill Road Scotland | England | British | 197178020001 | |||||||||
| HUTCHISON, Rhodella Jane | Administrateur | 30 Valentine Drive Danestone AB22 8YF Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 124915360001 | |||||||||
| LEONTIEFF, Andre | Administrateur | Kirkhill Industrial Estate Dyce AB21 0GQ Aberdeen Kirkhill Road Scotland | England | British | 230668960001 | |||||||||
| OVERTON, James | Administrateur | Kirkhill Industrial Estate Dyce AB21 0GQ Aberdeen Kirkhill Road Scotland | Scotland | British | 326947430001 | |||||||||
| THE LAW DEBENTURE PENSION TRUST CORPORATION P.L.C. | Administrateur | 100 Wood Street EC2V 7EX London Fifth Floor England |
| 146073480001 | ||||||||||
| ARON, Jeremy Andrew | Secrétaire | 48 Cuckoo Hill Drive HA5 3PJ Pinner Middlesex | British | 66089010001 | ||||||||||
| MAYS, Elaine Doris | Secrétaire | Chiswick Business Park 566 Chiswick High Road W4 5YF London Building 5 United Kingdom | British | 196074340001 | ||||||||||
| RASMUSON, Michael Allan | Secrétaire | Kirkhill Industrial Estate Dyce AB21 0GQ Aberdeen Kirkhill Road Scotland | 172785870001 | |||||||||||
| RASMUSON, Michael Alan | Secrétaire | 2,60 Canfield Gardens NW6 3EB London | Canadian | 98429360001 | ||||||||||
| SINCLAIR, Gavin | Secrétaire | Flat 1 75 Holland Park W11 3SL London | British | 60558790004 | ||||||||||
| SCOTTISH PENSION TRUSTEES LIMITED | Secrétaire | Noble Lowndes House 26 Blythswood Square G2 4BP Glasgow Lanarkshire | 296350001 | |||||||||||
| ASQUITH, Christopher | Administrateur | c/o Baker Hughes Floor Building 5 Chiswick Park 566 Chiswick High Road W4 5YF London 3rd England | England | British | 17673120004 | |||||||||
| BALLANTYNE, Ray Alexander | Administrateur | 48 Rubislaw Den South AB2 6AX Aberdeen Aberdeenshire | British | 62680260001 | ||||||||||
| BERGER, Ronald Joseph | Administrateur | Flat 4 27 Bolton Gardens SW5 0AQ London | American | 94015630001 | ||||||||||
| BLACKLIDGE, David | Administrateur | 11 Barrington Avenue NE30 3HG North Shields Tyne & Wear | English | 296380001 | ||||||||||
| CLARK, John Harvey | Administrateur | c/o Baker Hughes Floor Building 5 Chiswick Park 566 Chiswick High Road W4 5YF London 3rd United Kingdom | Scotland | British | 177745790001 | |||||||||
| COE, Michael | Administrateur | Sandford Cottage Wolverton Common Basingstoke Hampshire | British | 296390001 | ||||||||||
| CRABB, Stephen Leslie, Mr. | Administrateur | Baker Hughes Building Stoneywood Park North, Dyce AB21 7EA Aberdeen | Scotland | British | 202393290001 | |||||||||
| DICK, Matthew Gilmour | Administrateur | Kilvaxter Auchenblae AB30 1XQ Laurencekirk Kincardineshire | British | 40144390001 | ||||||||||
| DOUGLAS, Gary Philip | Administrateur | Stonefield Craigdam Tarves AB41 0NR Ellon Aberdeenshire | Scotland | British | 41651220002 | |||||||||
| ENSTON, Paul William | Administrateur | 31 Countesswells Terrace AB15 8LQ Aberdeen | Scotland | British | 82613700001 | |||||||||
| ENSTON, Paul William | Administrateur | 31 Countesswells Terrace AB15 8LQ Aberdeen | Scotland | British | 82613700001 | |||||||||
| FENTON, Stephen Edward | Administrateur | 26 Priory Road KT9 1EF Chessington Surrey | British | 121660730001 | ||||||||||
| FRANKLIN, Christopher Robert | Administrateur | Bridge End House Oyne AB52 6QT Insch Aberdeenshire | British | 82571550001 | ||||||||||
| FREEMAN, Mark | Administrateur | Kirkhill Industrial Estate Dyce AB21 0GQ Aberdeen Kirkhill Road Scotland | England | British | 189723690001 | |||||||||
| GARDEN, Alistair | Administrateur | 48 Baillieswells Drive Bieldside AB15 9AX Aberdeen | British | 495180002 | ||||||||||
| GREENE, Rosemary | Administrateur | Baker Hughes Building Stoneywood Park North, Dyce AB21 7EA Aberdeen | Northern Ireland | British | 18868090002 | |||||||||
| IRVINE, Barry John | Administrateur | Kirkhill Industrial Estate Dyce AB21 0GQ Aberdeen Kirkhill Road Scotland | Scotland | British | 57004210001 | |||||||||
| JENNISON, Alan Keith | Administrateur | 19 1/2 Norton Road Loddon NR14 6JN Norfolk | England | British | 257598340001 | |||||||||
| KNIGHT, Helen | Administrateur | 85 Fonthill Road AB11 6UP Aberdeen Aberdeenshire | British | 116834770001 | ||||||||||
| LICHTE, Rudiger | Administrateur | 8810 Horgen Seegartenstrasse 63 Switzerland | German | 129969630001 | ||||||||||
| MACLEAN, William David | Administrateur | 20 Lumsden Way AB23 8TS Belmedie Aberdeenshire | British | 296370004 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BAKER HUGHES UK PENSION TRUSTEES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker Hughes Limited | 06 avr. 2016 | 245 Hammersmith Road W6 8PW London 10th Floor England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0