Martin Trevor Digby PALMER
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Martin |
Deuxième prénom | Trevor Digby |
Nom de famille | PALMER |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 62 |
Total | 62 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOVIS HOMES PENSION SCHEME TRUSTEE LIMITED | 09 janv. 2017 | 03 févr. 2022 | Active | Chartered Secretary | Administrateur | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | Kent | British |
GIGG LANE LIMITED | 12 oct. 2007 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
ELITE HOMES (NORTH WEST) LIMITED | 12 oct. 2007 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
ELITE HOMES (YORKSHIRE) LIMITED | 12 oct. 2007 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
ELITE HOMES GROUP LIMITED | 12 oct. 2007 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
NETHER HALL PARK OPEN SPACE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 26 sept. 2006 | 25 juin 2021 | Active | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | ||
BOVIS HOMES FREEHOLDS LIMITED | 16 nov. 2004 | 25 juin 2021 | Active | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | ||
BOVIS HOMES BVC LTD. | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
BOVIS HOMES PROJECTS LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
BISHOPS PARK LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
BOVIS HOMES EASTERN LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
R.T.WARREN(BUILDERS,ST.ALBANS)LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
VISTRY DEVELOPMENTS LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
VISTRY LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
BOVIS HOMES (QUEST) COMPANY LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | ||
OXFORD LAND LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
PAGE-JOHNSON PROPERTIES LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
BOVIS HOMES WESSEX LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
UNITPAGE LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
BERKSHIRE LAND LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
BOVIS HOMES INSULATION LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
H.NEWBURY & SON(BUILDERS)LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
BOVIS HOMES MIDLANDS & NORTHERN LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
BOVIS HOMES SOUTH EAST LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
BOVIS HOMES CORNWALL LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
BOVIS HOMES LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
BOVIS HOMES SOUTHERN LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
BOVIS HOMES SCOTLAND LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 Tower View Kent England | British | |
BOVIS COUNTRY HOMES LIMITED | 03 janv. 2002 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
VISTRY HOMES LIMITED | 01 déc. 2001 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
VISTRY GROUP PLC | 01 déc. 2001 | 25 juin 2021 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | |
BOVIS HOMES PENSION SCHEME TRUSTEE LIMITED | 03 janv. 2002 | 09 janv. 2017 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | Hill House Crook Road Brenchley TN12 7BS Tonbridge Kent | British | |
LONDON FORFAITING INTERNATIONAL LIMITED | 12 sept. 1997 | 23 nov. 2001 | Active | Secrétaire | Hill House Crook Road Brenchley TN12 7BS Tonbridge Kent | British | ||
LONDON FORFAITING COMPANY LIMITED | 11 juil. 1997 | 23 nov. 2001 | Active | Secrétaire | Hill House Crook Road Brenchley TN12 7BS Tonbridge Kent | British | ||
SPITALFIELDS DEVELOPMENTS LIMITED | 31 mars 1994 | 16 mai 1997 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Hill House Crook Road Brenchley TN12 7BS Tonbridge Kent | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0