Martin Trevor Digby PALMER
  • Données
  • Grande-Bretagne
  • Entreprises
  • Rechercher des entreprises
  • Sanctions
  • Rechercher des sanctions
  • Martin Trevor Digby PALMER

    Personne physique

    TitreMr
    PrénomMartin
    Deuxième prénomTrevor Digby
    Nom de famillePALMER
    Date de naissance
    Est un dirigeant de sociétéNon
    Nominations
    Actif0
    Inactif0
    Démissionné62
    Total62

    Nominations

    Dirigeants nommés
    Nommé(e) àDate de nominationDate de démissionStatut de la sociétéProfessionRôleAdressePays de résidenceNationalité
    BOVIS HOMES PENSION SCHEME TRUSTEE LIMITED09 janv. 201703 févr. 2022ActiveChartered SecretaryAdministrateur
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    KentBritish
    GIGG LANE LIMITED12 oct. 200725 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    ELITE HOMES (NORTH WEST) LIMITED12 oct. 200725 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    ELITE HOMES (YORKSHIRE) LIMITED12 oct. 200725 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    ELITE HOMES GROUP LIMITED12 oct. 200725 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    NETHER HALL PARK OPEN SPACE MANAGEMENT COMPANY LIMITED26 sept. 200625 juin 2021ActiveSecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    BOVIS HOMES FREEHOLDS LIMITED16 nov. 200425 juin 2021ActiveSecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    BOVIS HOMES BVC LTD.03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    BOVIS HOMES PROJECTS LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    BISHOPS PARK LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    BOVIS HOMES EASTERN LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    R.T.WARREN(BUILDERS,ST.ALBANS)LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    VISTRY DEVELOPMENTS LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    VISTRY LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    BOVIS HOMES (QUEST) COMPANY LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveSecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    OXFORD LAND LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    PAGE-JOHNSON PROPERTIES LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    BOVIS HOMES WESSEX LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    UNITPAGE LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    BERKSHIRE LAND LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    BOVIS HOMES INSULATION LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    H.NEWBURY & SON(BUILDERS)LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    BOVIS HOMES MIDLANDS & NORTHERN LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    BOVIS HOMES SOUTH EAST LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    BOVIS HOMES CORNWALL LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    BOVIS HOMES LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    BOVIS HOMES SOUTHERN LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    BOVIS HOMES SCOTLAND LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11 Tower View
    Kent
    England
    British
    BOVIS COUNTRY HOMES LIMITED03 janv. 200225 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    VISTRY HOMES LIMITED01 déc. 200125 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    VISTRY GROUP PLC01 déc. 200125 juin 2021ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Tower View
    Kings Hill
    ME19 4UY West Malling
    11
    United Kingdom
    British
    BOVIS HOMES PENSION SCHEME TRUSTEE LIMITED03 janv. 200209 janv. 2017ActiveChartered SecretarySecrétaire
    Hill House
    Crook Road Brenchley
    TN12 7BS Tonbridge
    Kent
    British
    LONDON FORFAITING INTERNATIONAL LIMITED12 sept. 199723 nov. 2001ActiveSecrétaire
    Hill House
    Crook Road Brenchley
    TN12 7BS Tonbridge
    Kent
    British
    LONDON FORFAITING COMPANY LIMITED11 juil. 199723 nov. 2001ActiveSecrétaire
    Hill House
    Crook Road Brenchley
    TN12 7BS Tonbridge
    Kent
    British
    SPITALFIELDS DEVELOPMENTS LIMITED31 mars 199416 mai 1997ActiveCompany SecretarySecrétaire
    Hill House
    Crook Road Brenchley
    TN12 7BS Tonbridge
    Kent
    British

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0