BISHOPS PARK LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BISHOPS PARK LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02193080 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BISHOPS PARK LIMITED ?
| Adresse du siège social | 11 Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BISHOPS PARK LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BISHOPS PARK LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 05 juil. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 19 juil. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 05 juil. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour BISHOPS PARK LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2024 | 8 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Michael Andrew Lonnon en tant que directeur le 29 juil. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant qu'administrateur le 29 juil. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023 | 8 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Paul Anthony Moran en tant que directeur le 30 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Timothy Charles Lawlor en tant qu'administrateur le 16 sept. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Keith Bryan Carnegie en tant que directeur le 31 déc. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Keith Bryan Carnegie en tant qu'administrateur le 09 janv. 2017 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant que directeur le 30 sept. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 8 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 8 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 9 pages | AA | ||
Nomination de Vistry Secretary Limited en tant que secrétaire le 25 juin 2021 | 2 pages | AP04 | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Martin Trevor Digby Palmer en tant que secrétaire le 25 juin 2021 | 1 pages | TM02 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 5 pages | AA | ||
Nomination de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant qu'administrateur le 31 oct. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Colin Richard Clapham en tant que directeur le 31 oct. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des détails de Bovis Homes Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 janv. 2020 | 2 pages | PSC05 | ||
Cessation de la nomination de Anthony James Watson en tant que directeur le 06 déc. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de BISHOPS PARK LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTRY SECRETARY LIMITED | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 Kent United Kingdom |
| 284895390001 | ||||||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Taylor Wimpey Plc, Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 330353690001 | |||||||||
| LAWLOR, Timothy Charles | Administrateur | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | United Kingdom | British | 302161610001 | |||||||||
| EMERY, John Michael | Secrétaire | The Model Barn House The Jephsons, Shakers Lane CV47 9QB Long Itchington Southam Warwickshire | British | 67036060001 | ||||||||||
| MCGLASHAN, Alastair | Secrétaire | 12 Celandine Bank GL52 4HZ Woodmancote Cheltenham | British | 55102250001 | ||||||||||
| PALMER, Martin Trevor Digby | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | British | 79436600001 | ||||||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Administrateur | Chestnut Drive HP4 2JL Berkhamsted 11 Hertfordshire England | United Kingdom | British | 175715660001 | |||||||||
| CARNEGIE, Keith Bryan | Administrateur | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | England | British | 265822400001 | |||||||||
| CARNEGIE, Keith Bryan | Administrateur | Church Farm Cottages Harewell Lane WR8 9AT Besford 2, Worcs United Kingdom | United Kingdom | British | 317702340001 | |||||||||
| CARR, Peter Anthony | Administrateur | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | England | British | 130306120001 | |||||||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire England | United Kingdom | British | 9684390001 | |||||||||
| DUTTON, Andrew Leon | Administrateur | 100 High Street CM16 4AF Epping Essex | British | 42135320003 | ||||||||||
| ELLIS, Roy | Administrateur | 17 Lupin Ride RG45 6US Crowthorne Berkshire | England | British | 52288200001 | |||||||||
| FRESHNEY, Michael John | Administrateur | Apple Orchard 136 Brox Road Ottershaw KT16 0LG Chertsey Surrey | England | British | 45689190001 | |||||||||
| GUEST, Simon John | Administrateur | 36 Filmer Road SW6 7JL London | England | British | 88461330001 | |||||||||
| HASTIE, Nicola Amanda Eleanor | Administrateur | 97 Yew Tree Lane Tettenhall WV6 8UN Wolverhampton | British | 76844970003 | ||||||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Taylor Wimpey Plc, Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 257671040002 | |||||||||
| JOHNSON, Brian Michael | Administrateur | Ashmeade The Orchards Cock Lane Norton Juxta CV9 3PY Twycross Warwickshire | British | 28050410002 | ||||||||||
| JORDAN, James John | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British | 120602100002 | |||||||||
| LONNON, Michael Andrew | Administrateur | Long Drive HA4 0HP Ruislip 78 Middlesex England | England | British | 200177630001 | |||||||||
| MORAN, Paul Anthony | Administrateur | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | United Kingdom | British | 206313480001 | |||||||||
| PEARSON, David Nicholas | Administrateur | Newton Road ME13 8DZ Faversham 58 Kent United Kingdom | England | British | 80794120001 | |||||||||
| PHILLIPS, James | Administrateur | Stallworth 6 Wood Road Tettenhall WV6 8LS Wolverhampton West Midlands | British | 8364990001 | ||||||||||
| REDFERN, Peter Timothy | Administrateur | 5 Broadfield Road OX5 1UL Yarnton Oxfordshire | British | 74208670003 | ||||||||||
| RITCHIE, David James | Administrateur | Scuffits Elphicks Farm West Street ME15 0SB Hunton Kent | England | British | 83963760002 | |||||||||
| ROSIER, Stephen James | Administrateur | Roke House 42 Millway Road SP10 3EU Andover Hampshire | British | 27921120004 | ||||||||||
| SMITH, Paul Thomson | Administrateur | 22 Reynards Copse CO4 9UR Colchester Essex | England | British | 82453060001 | |||||||||
| STIRROP, Michael | Administrateur | Whitehouse Crescent B75 6ET Sutton Coldfield 87 West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 135390120001 | |||||||||
| SUNTER, Amanda Jane | Administrateur | 19 First Avenue CM12 9PT Billericay Essex | British | 44240520001 | ||||||||||
| SUTCLIFFE, Ian Calvert | Administrateur | Windlesham Lodge Westwood Road GU20 6LX Windlesham Surrey | United Kingdom | British | 112534590002 | |||||||||
| TRUSCOTT, Peter Martin | Administrateur | Twyford House 15 Hulse Road SO15 2PY Southampton 7 Southampton United Kingdom | United Kingdom | British | 47020200008 | |||||||||
| TULLAH, Neville | Administrateur | King Henry Vi Cottage Bedford Road MK43 0UT Husborne Crawley Bedfordshire | British | 72622070001 | ||||||||||
| WALFORD, Ronald Norman | Administrateur | 12 Gopshill Lane Gretton GL54 5ET Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | United Kingdom | 6867090001 | |||||||||
| WATSON, Anthony James | Administrateur | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | United Kingdom | British | 183688770001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BISHOPS PARK LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistry Homes Limited | 06 avr. 2016 | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mca East Limited | 06 avr. 2016 | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0