Joseph Tidboald COLES - Page 2
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Joseph |
| Deuxième prénom | Tidboald |
| Nom de famille | COLES |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 35 |
| Inactif | 10 |
| Démissionné | 11 |
| Total | 56 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRISKWORK LIMITED | 18 sept. 2006 | Dissoute | Director | Administrateur | 1 Westmead Road SM1 4LA Sutton Allen House Surrey | United Kingdom | British | |
| DUCTAIRE FABRICATIONS LIMITED | 19 juil. 2006 | Dissoute | Director | Administrateur | 41 Scotland Street S3 7BS Sheffield Kendal House | United Kingdom | British | |
| D & J FABRICATIONS (ATHERTON) LIMITED | 02 juin 2004 | Active | Company Director | Administrateur | Zeal House 8 Deer Park Road Merton SW19 3UU London | United Kingdom | British | |
| WHITEFRIARS GLASS LIMITED | 27 févr. 2004 | Active | Director | Administrateur | 8 Deer Park Road London SW19 3UU | United Kingdom | British | |
| GENESIS MEDICAL SPECIALIST SERVICES LIMITED | 09 sept. 2002 | Active | Company Director | Administrateur | 8 Deer Park Road London SW19 3UU | United Kingdom | British | |
| P.L.H. MEDICAL LIMITED | 19 juin 2002 | Active | Director | Administrateur | Deer Park Road SW19 3UU London 8 | United Kingdom | British | |
| COLES HOLDINGS LTD | 08 août 1996 | Active | Managing Director | Administrateur | 8 Deer Park Road London SW19 3UU | United Kingdom | British | |
| ZEAL CLEAN SUPPLIES LTD | 17 août 1995 | Active | Director | Administrateur | 8 Deer Park Road London SW19 3UU | United Kingdom | British | |
| ZEAL HOLDINGS LIMITED | 24 mai 1995 | Active | Company Director | Administrateur | 8 Deer Park Road Merton SW19 3UU London | United Kingdom | British | |
| G.H. ZEAL LIMITED | 24 mai 1995 | Active | Company Director | Administrateur | 8 Deer Park Road London SW19 3UU | United Kingdom | British | |
| LAWPACK ONLINE LIMITED | 27 nov. 2019 | 01 sept. 2023 | Active | Director | Administrateur | Deer Park Road SW19 3UU London 8 United Kingdom | United Kingdom | British |
| CHURCH COURT PROPERTIES LIMITED | 19 févr. 2002 | 03 nov. 2020 | Active | Company Director | Administrateur | Zeal House 8 Deer Park SW19 3UU Wimbledon London | United Kingdom | British |
| DIGBY & NELSON INVESTMENTS LIMITED | 10 mai 2002 | 01 nov. 2020 | Active | Director | Administrateur | Zeal House 8 Deer Park Road SW19 3UU London | United Kingdom | British |
| MANOR COURT PROPERTIES (UK) LIMITED | 31 juil. 2003 | 01 août 2018 | Active | Secrétaire | Coker Court East Coker BA22 9JW Somerset | British | ||
| PULSE CLEAN ENERGY LIMITED | 19 juil. 2010 | 10 févr. 2011 | Active | Director | Administrateur | 8 Deer Park Road SW19 3UU London Zeal House England | United Kingdom | British |
| CHURCH COURT PROPERTIES LIMITED | 19 févr. 2002 | 03 déc. 2009 | Active | Company Director | Secrétaire | Zeal House 8 Deer Park SW19 3UU Wimbledon London | British | |
| ZEAL DIAGNOSTICS LIMITED | 08 nov. 2001 | 03 déc. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 8 Deer Park Road London SW19 3UU | British | ||
| ZEAL CLEAN SUPPLIES LTD | 17 déc. 1997 | 03 déc. 2009 | Active | Director | Secrétaire | 8 Deer Park Road London SW19 3UU | British | |
| ZEAL HOLDINGS LIMITED | 31 oct. 1997 | 03 déc. 2009 | Active | Secrétaire | 8 Deer Park Road Merton SW19 3UU London | British | ||
| G.H. ZEAL LIMITED | 31 oct. 1997 | 03 déc. 2009 | Active | Secrétaire | 8 Deer Park Road London SW19 3UU | British | ||
| COLES HOLDINGS LTD | 31 oct. 1997 | 03 déc. 2009 | Active | Secrétaire | 8 Deer Park Road London SW19 3UU | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0