THE CITY PARTNERSHIP (UK) LIMITED
Dirigeant de société
Nom | THE CITY PARTNERSHIP (UK) LIMITED |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 15 |
Inactif | 11 |
Démissionné | 36 |
Total | 62 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
FUEL VENTURES VCT PLC | 08 déc. 2023 | Active | Secrétaire | Meltham Road HD4 7BH Huddersfield The Mending Rooms England | |
GUINNESS VCT PLC | 03 oct. 2022 | Active | Secrétaire | 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Orchard Brae House Suite 2, Ground Floor Scotland | |
HOLME FEN LIMITED | 28 juil. 2021 | Active | Secrétaire | c/o The City Partnership (Uk) Limited Suite 2, Ground Floor 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Orchard Brae House Scotland | |
ARTNOVA CAPITAL PLC | 30 oct. 2020 | Active | Secrétaire | Suite 2, Ground Floor, Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh C/O The City Partnership (Uk) Ltd Scotland | |
BLACKFINCH SPRING VCT PLC | 04 nov. 2019 | Active | Secrétaire | Suite 2, Ground Floor 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Orchard Brae House Scotland | |
HAB LAND FINANCE PLC | 08 avr. 2019 | Liquidation | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland | |
MAX MINDPOWER LTD | 02 avr. 2019 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland | |
HEALTHCARE FINANCE LIMITED | 15 nov. 2018 | Active | Secrétaire | c/o The City Partnership (Uk) Limited Suite2, Ground Floor 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Orchard Brae House Scotland | |
PAY LATER LTD | 08 mai 2018 | Active | Secrétaire | Suite 2, Ground Floor, Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh C/O The City Partnership (Uk) Limited Scotland | |
AMBERSIDE ALP LIMITED | 31 oct. 2017 | Active | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 United Kingdom | |
CHF HEROGLIFFIX LIMITED | 20 janv. 2017 | Active | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland | |
BRITISH SMALLER COMPANIES VCT2 PLC | 01 déc. 2014 | Active | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland | |
BRITISH SMALLER COMPANIES VCT PLC | 01 déc. 2014 | Active | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland | |
CITY PARTNERSHIP TRUSTEE LIMITED | 24 févr. 2014 | Active | Administrateur | c/o The City Partnership (Uk) Limited Suite 2, Ground Floor 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Orchard Brae House Scotland | |
PEMBROKE VCT PLC | 27 nov. 2012 | Active | Secrétaire | Suite 2, Ground Floor, Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh C/O The City Partnership (Uk) Limited Scotland | |
JAKERS! GLOBAL PLC | 16 juil. 2012 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland | |
CHF PIP! PLC | 26 juil. 2011 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland | |
INVESCO PERPETUAL AIM VCT LIMITED | 24 janv. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Thistle Street EH2 1DF Edinburgh Thistle House, 21 | |
MEAUJO (765) LIMITED | 13 janv. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 21 | |
MEAUJO (764) LIMITED | 13 janv. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 21 | |
NOBLE AIM VCT LIMITED | 27 mai 2010 | Dissoute | Secrétaire | 21 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh Thistle House | |
SINGER & FRIEDLANDER AIM 3 VCT LIMITED | 01 avr. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Thistle Street EH2 1DF Edinburgh Thistle House, 21 Scotland | |
VENTUS 2 VCT PLC | 01 févr. 2009 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland | |
VENTUS VCT PLC | 01 févr. 2009 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland | |
IBIS MEDIA VCT 2 PLC | 23 janv. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 21 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh Thistle House Midlothian United Kingdom | |
IBIS MEDIA VCT 1 PLC | 23 janv. 2006 | Liquidation | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland | |
E.G. THOMSON (HOLDINGS) LIMITED | 24 juin 2011 | 18 janv. 2023 | Active | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
BEN MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 24 juin 2011 | 18 janv. 2023 | Active | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
BEN LINE SHIPPING LIMITED | 24 juin 2011 | 18 janv. 2023 | Active | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
BEN LINE AGENCIES LIMITED | 24 juin 2011 | 18 janv. 2023 | Active | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
E. G. THOMSON (TRAVEL) LIMITED | 24 juin 2011 | 18 janv. 2023 | Active | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
BORDLANDS DEVELOPMENTS LIMITED | 24 juin 2011 | 18 janv. 2023 | Active | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
EGTH (TRAVEL) LIMITED | 24 juin 2011 | 18 janv. 2023 | Active | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
EDGE PERFORMANCE VCT PUBLIC LIMITED COMPANY | 05 avr. 2007 | 19 avr. 2022 | Liquidation | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
MAVEN RENOVAR VCT PLC | 01 avr. 2010 | 01 févr. 2022 | Active | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0