THE CITY PARTNERSHIP (UK) LIMITED - Page 2
Dirigeant de société
Nom | THE CITY PARTNERSHIP (UK) LIMITED |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 15 |
Inactif | 11 |
Démissionné | 36 |
Total | 62 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
SCOTTISH CONNECTIONS LIMITED | 24 juin 2011 | 18 janv. 2022 | Active | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
EVENTING FIRST PLC | 18 mai 2017 | 06 avr. 2020 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
TW COMPOSTING LIMITED | 01 févr. 2017 | 03 janv. 2020 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
SOCIAL IMPACT VCT PLC | 12 nov. 2012 | 31 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
SFC FENS LTD | 22 mars 2017 | 23 oct. 2019 | Active | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
GCN LIMITED | 22 mars 2017 | 23 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
PETIT JARDIN LIMITED | 22 mars 2017 | 23 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
LEAFELLA LIMITED | 22 mars 2017 | 23 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
SHINY WATER LIMITED | 22 mars 2017 | 23 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
REALE BASIL LIMITED | 22 mars 2017 | 23 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
ARDEN CULTURA LIMITED | 22 mars 2017 | 23 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
PELICAN WATER LIMITED | 22 mars 2017 | 23 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
TERRA ACETARIA LIMITED | 22 mars 2017 | 23 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
HERBEOS LTD | 22 mars 2017 | 23 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
AVERSELY LIMITED | 22 mars 2017 | 23 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
KREBS COMPOSTING LIMITED | 22 mars 2017 | 23 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
KINGFISHER WATER TREATMENT LIMITED | 22 mars 2017 | 23 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
BEECHWOOD RECYCLING LIMITED | 09 févr. 2017 | 23 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
ASTWOOD ENERGY LIMITED | 01 févr. 2017 | 23 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
H2O RESOURCES LTD | 22 mars 2017 | 23 oct. 2019 | Liquidation | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
BIO COMPOSTING LIMITED | 22 mars 2017 | 21 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
AMATI VCT PLC | 01 janv. 2010 | 04 juil. 2018 | Dissoute | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 Scotland |
OCEAN VCT PLC | 27 sept. 2017 | 19 janv. 2018 | Active | Secrétaire | George Street EH2 4LH Edinburgh 110 United Kingdom |
KENTLE WOOD HOUSE LIMITED | 06 mai 2011 | 30 juin 2016 | Dissoute | Secrétaire | Thistle Street EH2 1DF Edinburgh Thistle House, 21 United Kingdom |
POLYHEDRA GROUP LIMITED | 11 févr. 2014 | 01 avr. 2016 | Dissoute | Secrétaire | 21 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh Thistle House Scotland |
LONGBOW GROWTH AND INCOME VCT PLC | 29 oct. 2010 | 16 mars 2012 | Dissoute | Secrétaire | 21 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh Thistle House United Kingdom |
LISMORE PROPERTY LIMITED | 24 juin 2011 | 29 juil. 2011 | Active | Secrétaire | 21 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh Thistle House Scotland |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0