TRAFALGAR HOUSE STEAM-SHIP COMPANY LIMITED

TRAFALGAR HOUSE STEAM-SHIP COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRAFALGAR HOUSE STEAM-SHIP COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00012286
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRAFALGAR HOUSE STEAM-SHIP COMPANY LIMITED?

    • (7415) /
    • (7499) /

    Dove si trova TRAFALGAR HOUSE STEAM-SHIP COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Surrey House
    36-44 High Street
    RH1 1RH Redhill
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRAFALGAR HOUSE STEAM-SHIP COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE CUNARD STEAM-SHIP COMPANY LIMITED23 mag 187823 mag 1878

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRAFALGAR HOUSE STEAM-SHIP COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per TRAFALGAR HOUSE STEAM-SHIP COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dettagli del direttore cambiati per Rufus Laycock il 26 feb 2014

    3 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Baker Tilly 6Th Floor 25 Farringdon Street London EC4A 4AB* in data 20 nov 2013

    2 pagineAD01

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 31 gen 2012

    6 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 gen 2012

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 lug 2011

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 gen 2011

    6 pagine4.68

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:replacement of liquidator, D.P. hudson replacing P.J.R. souster 01/12/2010
    9 pagineLIQ MISC OC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da * 5 Old Bailey London EC4M 7AF* in data 29 nov 2010

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Surrey House 36-44 High Street Redhill Surrey RH1 1RH* in data 11 gen 2010

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Cessazione della carica di Rufus Laycock come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Marcelo Roque Pereira come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Runar Nilsen come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Rufus Laycock come amministratore

    3 pagineAP01

    Memorandum e Statuto

    8 pagineMEM/ARTS

    Chi sono gli amministratori di TRAFALGAR HOUSE STEAM-SHIP COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LAYCOCK, Rufus
    36-44 High Street
    RH1 1RH Redhill
    Surrey House
    Surrey
    Amministratore
    36-44 High Street
    RH1 1RH Redhill
    Surrey House
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Secretary7584610002
    ARNKVAERN, Anders
    5 Ernle Road
    SW20 0HH London
    Segretario
    5 Ernle Road
    SW20 0HH London
    Norwegian49759930002
    BARLOW, Brian Norman
    2 Old Hadlow Road
    TN10 4EZ Tonbridge
    Kent
    Segretario
    2 Old Hadlow Road
    TN10 4EZ Tonbridge
    Kent
    British453990001
    ERIKSRUD, Eystein
    Flat 14
    Pier House Cheyne Walk
    SW3 5HG London
    Segretario
    Flat 14
    Pier House Cheyne Walk
    SW3 5HG London
    British72707990001
    HAUGSTAD, Hans
    3 Lambourne Avenue
    SW19 7DW London
    Segretario
    3 Lambourne Avenue
    SW19 7DW London
    Norwegian62179360001
    LAYCOCK, Rufus
    Burghley Avenue
    KT3 4SW New Malden
    33
    Surrey
    Segretario
    Burghley Avenue
    KT3 4SW New Malden
    33
    Surrey
    British7584610001
    PEATE, Roland Duncan
    87 Bennetts Way
    Shirley
    CR0 8AG Croydon
    Surrey
    Segretario
    87 Bennetts Way
    Shirley
    CR0 8AG Croydon
    Surrey
    British7628800001
    ANSDELL, John Reginald Wardhaugh
    17 Randolph Avenue
    W9 1BH London
    Amministratore
    17 Randolph Avenue
    W9 1BH London
    BritishCompany Director5094500001
    COOKE, Anthony Roderick Chichester Bancroft
    Poland Court
    RG29 1JL Odiham
    Hampshire
    Amministratore
    Poland Court
    RG29 1JL Odiham
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director5503780001
    FINNE, Hans Petter
    32 Gloucester Walk
    W8 4HY London
    Amministratore
    32 Gloucester Walk
    W8 4HY London
    NorwegianCompany Director50130950001
    FLETCHER, John Wilfred Sword
    House B 36 Island Road
    Deepwater Bay
    Hong Kong Sar
    Pr China
    Amministratore
    House B 36 Island Road
    Deepwater Bay
    Hong Kong Sar
    Pr China
    BritishCivil Engineer69869500001
    FOWLER, Ian
    32 Newton Road
    W2 5LT London
    Amministratore
    32 Newton Road
    W2 5LT London
    BritishCompany Secretary41294100001
    GAWLER, David
    76 Park Road
    TW12 1HP Hampton Hill
    Middlesex
    Amministratore
    76 Park Road
    TW12 1HP Hampton Hill
    Middlesex
    United KingdomSouth AfricanFinance Director167282630001
    GORMLY, Allan Graham
    56 North Park
    SL9 8JR Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    56 North Park
    SL9 8JR Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant1308140001
    LAYCOCK, Rufus
    Burghley Avenue
    KT3 4SW New Malden
    33
    Surrey
    Amministratore
    Burghley Avenue
    KT3 4SW New Malden
    33
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Secretary7584610001
    MALE, Jan Arnstein
    Harald Haardfagres Gate 2
    FOREIGN N-0363 Oslo
    Norway
    Amministratore
    Harald Haardfagres Gate 2
    FOREIGN N-0363 Oslo
    Norway
    NorwegianCompany Director52345770002
    MCDERMOTT, Dermot St John
    8 Grange Road
    W4 4DA London
    Amministratore
    8 Grange Road
    W4 4DA London
    BritishFinancial Director35751350001
    NILSEN, Runar
    Apt 302
    Osloveien 29
    Drobak Panorama,
    1440 Drobak
    Norway
    Amministratore
    Apt 302
    Osloveien 29
    Drobak Panorama,
    1440 Drobak
    Norway
    NorwegianCeo And Cfo102391880002
    OLSEN, Hans Ebenedict
    65/69 Mount Kellet Road
    Town House M
    Hong Kong
    Amministratore
    65/69 Mount Kellet Road
    Town House M
    Hong Kong
    BritishBusiness Executive78045000002
    PANKAKOSKI, Antti
    Oaktrees
    Clare Hill
    KT10 9NA Esher
    Surrey
    Amministratore
    Oaktrees
    Clare Hill
    KT10 9NA Esher
    Surrey
    FinlandChairman54924130001
    PARKER, Eric Wilson, Sir
    Crimbourne House
    Crimbourne Lane Green Wisborough
    RH14 0HR Billingshurst
    West Sussex
    Amministratore
    Crimbourne House
    Crimbourne Lane Green Wisborough
    RH14 0HR Billingshurst
    West Sussex
    EnglandBritishCompany Director36208980001
    RICH, Nigel Mervyn Sutherland
    65 Chelsea Square
    SW3 6LE London
    Amministratore
    65 Chelsea Square
    SW3 6LE London
    United KingdomBritishDirector50875570003
    ROQUE PEREIRA, Marcelo
    273 Ladbroke Grove
    W10 6HF London
    Basement Flat
    Amministratore
    273 Ladbroke Grove
    W10 6HF London
    Basement Flat
    United KingdomPortugueseAccountant134678420003
    TONSETH, Erik
    Aldworth House Old Avenue
    St George's Hill
    KT13 0PZ Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Aldworth House Old Avenue
    St George's Hill
    KT13 0PZ Weybridge
    Surrey
    NorwegianCompany Director48350850002
    URSIN-SMITH, Kjell
    53 Iverna Court
    Iverna Gardens
    W8 6TS London
    Amministratore
    53 Iverna Court
    Iverna Gardens
    W8 6TS London
    NorwegianCompany Director49760180002
    WARD, Peter Terry
    21 Alexander Square
    SW3 2AU London
    Amministratore
    21 Alexander Square
    SW3 2AU London
    EnglandBritishExecutive Director55900930001
    WATKINS, James Arthur
    2 Montpelier Square
    SW7 1JT London
    Amministratore
    2 Montpelier Square
    SW7 1JT London
    BritishSolicitor53231400002
    WILLIAMS, Nigel Edward Oliver
    17 Holmes Road
    Strawberry Hill
    TW1 4RF Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    17 Holmes Road
    Strawberry Hill
    TW1 4RF Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritishSolicitor8325950001
    WITTUSEN, Dag Fasmer
    Risstubben 5
    FOREIGN Oslo
    0374
    Norway
    Amministratore
    Risstubben 5
    FOREIGN Oslo
    0374
    Norway
    NorwegianExecutive Vice Presidnet100360490001

    TRAFALGAR HOUSE STEAM-SHIP COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed
    Creato il 13 mar 1992
    Consegnato il 20 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    5,379,757 and all monies due or to become due from thecompany to the chargee under the second security documents (as defined)
    Brevi particolari
    M.V. atlantic conveyor and the owners insurances earnings and requisition compensation.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent for the Second Syndicate
    Transazioni
    • 20 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed
    Creato il 13 mar 1992
    Consegnato il 20 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £6,463,607 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the first security documents (as defined)
    Brevi particolari
    M.V. atlantic conveyor and the owners insurances earnings and requisition compensation.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent for the First Syndicate
    Transazioni
    • 20 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed
    Creato il 29 dic 1989
    Consegnato il 11 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £7,770,761 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financial agreement and deed of covenant dated 15/06/87 and this deed.
    Brevi particolari
    All monies payable under a time charter party dated 6/12/89 and all other rights and benefits. See form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barlcays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 18 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed
    Creato il 29 dic 1989
    Consegnato il 11 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £17,236,288 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financial agreement and dee d of covenant dated 14/1/85 and this deed
    Brevi particolari
    All monies payable under a time charter party dated 6/12/89 and all othe r rights and benefits see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 28 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Time charter party
    Creato il 14 set 1988
    Consegnato il 04 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All amounts due under the time charter
    Brevi particolari
    All cargoes and sub freights accruing to the company in respect of M.V. "gulf speed".
    Persone aventi diritto
    • Harmony Supplies Limited
    Transazioni
    • 04 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 28 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Time charter party
    Creato il 13 set 1988
    Consegnato il 04 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All amounts due under the time charter party
    Brevi particolari
    All cargoes and sub freights accruing to the company in respect of mv gulf spirit.
    Persone aventi diritto
    • Braithwaite Shipping Limited
    Transazioni
    • 04 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    Shipowners agreements
    Creato il 15 giu 1987
    Consegnato il 25 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    1) any moneys which may be payable to tthe company in accordance with a financial agreement dated 15/06/87 2) the companys vessel mv "atlantic conveyor" registered at the port of liverpool with official no 704464.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transazioni
    • 25 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    Delivery order
    Creato il 15 giu 1987
    Consegnato il 25 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financial agreement dated 15/06/87
    Brevi particolari
    All the company's rights, title & interest and benefits in and under:- a) the M.V. "atlantic conveyor" reg.d at the port of liverpool official no. 704464 and all related earnings.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 18 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Bond and assignation in security
    Creato il 15 giu 1987
    Consegnato il 25 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the charterer to the chargee under the terms of a financial agreement dated 15.06.87
    Brevi particolari
    All the companys rights interests and benefits (but not obligations) in respect of vessel mv "atlantic conveyor and all materials and components relating to her(see doc M395 for details.
    Persone aventi diritto
    • Barlcays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second priority statutory mortgage
    Creato il 15 giu 1987
    Consegnato il 25 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a financial agreement dated 15.06.87 and a deed of covenant dated 15/06/87
    Brevi particolari
    64/64TH shares of and in the mv atlantic conveyor reg d in the name of the company at the port of liverpool offical no 704464.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 18 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenant
    Creato il 15 giu 1987
    Consegnato il 25 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £11,158,528 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financial agreement dated 15/06/87
    Brevi particolari
    All the companys rights title and interest and benefits in and underyor official no 704484 (2) the earnings of the vessea) the mv atlantic converyor reg d at the port of liverpool official no 704464 and all related earnings.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee
    Creato il 13 ago 1986
    Consegnato il 18 ago 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the charterer to the chargee pursuant to two demise charterparties dated 13.8.86
    Brevi particolari
    The right of set off pursuant to clause 3.04 (") of the deed of guarnatee.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 28 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Financial agreement
    Creato il 14 gen 1985
    Consegnato il 21 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The maximum principal sum and all other moneys due or become eu from the company to barclays bank PLC as agent on behalf of itself and the other chargees together called th syndicate not exceeding £38,520,800 under the terms of the said financial agreement (as the same may from time to time be amended)
    Brevi particolari
    The companys right title and benefits under a building contract dated 21ST feb 83.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    Deed of covenant
    Creato il 14 gen 1985
    Consegnato il 21 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The maximum principal sum of £35,627,115 and all other moneys due or to become due from the company to barclays bank PLC as agents on behalf of itself and the other chargers together called the syndicate under the terms of a financial agreement dated 14TH jan 1985 and under the terms of the charge (as each of there documents may from time to time be amended)
    Brevi particolari
    The companys right title and benefits under (a) mv atlantic conveyors official no 704484 (2) the earnings of the vessel and any compensation payable.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 08 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 14 gen 1985
    Consegnato il 21 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee on any account current under the terms of a financial agreement and a deed of covenant both dated 14TH january, 1985 (as each of the documents may from time to time be amended
    Brevi particolari
    Mv atlantic conveyor official no 704464.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 08 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenant
    Creato il 18 nov 1980
    Consegnato il 19 nov 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing all monies due or to become due secured by a mortgage dated 12/11/80 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    64/64TH shares of mv "lumiere" registered as a british ship no 357413 and 64/64TH shares of mv "luminetta" registered as a british no 357414 and all insurances and requisition compensation of the said vessel.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank International Limited
    Transazioni
    • 19 nov 1980Registrazione di un'ipoteca
    Assignment of insurances
    Creato il 12 nov 1980
    Consegnato il 19 nov 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargfee under the terms the charge and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    The owners rights title and interest in and to all policies and contracts of insurance including the owners right under all entries in any protection and indemnity or war risks association which are taken out by the owner in respect of the vessel and all the benefits thereof.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank International Limited.
    Transazioni
    • 19 nov 1980Registrazione di un'ipoteca
    Assignment of insurances.
    Creato il 12 nov 1980
    Consegnato il 19 nov 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    The owners rights, title and interest in and to all policies and contracts of insurance including the owners right under all entries in any protection and indemnityu or war risks association which are taken out by the owner in respect of the vessel and all the benefits thereof.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank International Limited.
    Transazioni
    • 19 nov 1980Registrazione di un'ipoteca
    Statutory ship mortgage
    Creato il 12 nov 1980
    Consegnato il 19 nov 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a deed of covenant dated 12.11.80.
    Brevi particolari
    64/64TH shares of M.V. "lucinetta" registered as a british ship no: 357414.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank International Limited.
    Transazioni
    • 19 nov 1980Registrazione di un'ipoteca
    Statutory ship mortgage
    Creato il 12 nov 1980
    Consegnato il 19 nov 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account currant under the terms of a deed of covenant dated 12 / 11/ 80
    Brevi particolari
    64/64 shares of m/v luminetta registered as a british ship no 357414.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank International Limited
    Transazioni
    • 19 nov 1980Registrazione di un'ipoteca
    Deed of covenant
    Creato il 27 mar 1980
    Consegnato il 31 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee secured by another charge dated 27 mar 80 was registered pursuant to section 95 of the companies act 1948 on 31 mar 80.
    Brevi particolari
    The ship insurance, earnings requisition & compensation as defined in the deed of covenant for details see doc M733.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 27 mar 1980
    Consegnato il 31 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a deed of covenant dated 27 mar 80.
    Brevi particolari
    64/64 shares of m/v matanei of london no 280, 1961 and official no. 302814 (the shop).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    Deed of covenant
    Creato il 27 mar 1980
    Consegnato il 31 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee secured by another charge dated 27TH march 80 was registered pursuant to section 95 of the companies act 1948 on 31 march 80
    Brevi particolari
    The ship insurance, earnings requisition and compensation as defined in the deed of covenant for details see doc m/733.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Limited
    Transazioni
    • 31 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 27 mar 1980
    Consegnato il 31 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account curretn under the terms of a deed of covenant dated 17TH march 80
    Brevi particolari
    64/64TH shares of m/v matangi of london no 280, 1961 and official no 302814 (the ship).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 28 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First mortgages and transfers under the merchant shipping act 1894
    Creato il 19 feb 1930
    Consegnato il 25 feb 1930
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Mortgage for further securing debenture stock for £4,000,000
    Brevi particolari
    Various vessels;ports of call see doc 179 for details.
    Persone aventi diritto
    • Martins Bank Limited
    Transazioni
    • 25 feb 1930Registrazione di un'ipoteca

    TRAFALGAR HOUSE STEAM-SHIP COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 gen 2010Inizio della liquidazione
    09 mag 2012Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Bruce Alexander Mackay
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Praticante
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Peter John Robertson Souster
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Praticante
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    David Paul Hudson
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0