JAEGER HOLDINGS LIMITED

JAEGER HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJAEGER HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00019149
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JAEGER HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova JAEGER HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Ship Canal House 8th Floor
    98 King Street
    M2 4WB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di JAEGER HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al27 feb 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per JAEGER HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    32 pagineAM23

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Alixpartners the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB a Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB in data 16 mar 2020

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    28 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    29 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    9 pagineAM16

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    31 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    34 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    4 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    47 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    9 pagineAM02

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    4 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    72 pagineAM03

    Nomina di un amministratore

    4 pagineAM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 2nd Floor, the White Building, 11 Evesham Street London W11 4AJ United Kingdom a C/O Alixpartners the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB in data 28 apr 2017

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Simon Christopher Pilling come amministratore in data 30 mar 2017

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Mr Kenneth Charles Pratt come amministratore in data 21 set 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 27 feb 2016

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 giu 2016

    Stato del capitale al 16 giu 2016

    • Capitale: GBP 11,542,000.75
    SH01

    Cessazione della carica di Harminder Singh Atwal come amministratore in data 26 apr 2016

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 57 Broadwick Street London W1F 9QS a 2nd Floor, the White Building, 11 Evesham Street London W11 4AJ in data 15 apr 2016

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Christopher Richard Horobin come amministratore in data 25 feb 2016

    2 pagineAP01

    Iscrizione dell'ipoteca 000191490015, creata il 02 dic 2015

    12 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di JAEGER HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WARWICK-SAUNDERS, Richard Meirion
    98 King Street
    M2 4WB Manchester
    Ship Canal House 8th Floor
    Segretario
    98 King Street
    M2 4WB Manchester
    Ship Canal House 8th Floor
    173990650001
    HOROBIN, Christopher Richard
    98 King Street
    M2 4WB Manchester
    Ship Canal House 8th Floor
    Amministratore
    98 King Street
    M2 4WB Manchester
    Ship Canal House 8th Floor
    United KingdomBritish204157860001
    PRATT, Kenneth Charles
    98 King Street
    M2 4WB Manchester
    Ship Canal House 8th Floor
    Amministratore
    98 King Street
    M2 4WB Manchester
    Ship Canal House 8th Floor
    EnglandBritish72306460002
    ALDRIDGE, Gemma Jane Constance
    54 Crown Street
    HA2 0HR Harrow On The Hill
    Middlesex
    Segretario
    54 Crown Street
    HA2 0HR Harrow On The Hill
    Middlesex
    British144966000001
    ATKAR, Dilbina Manjit Kaur
    57 Broadwick Street
    London
    W1F 9QS
    Segretario
    57 Broadwick Street
    London
    W1F 9QS
    British93641970001
    GIFFORD, Derek William
    70 Manor Drive
    KT5 8NF Surbiton
    Surrey
    Segretario
    70 Manor Drive
    KT5 8NF Surbiton
    Surrey
    British951440001
    JENKINS, David Huw
    25 Wingfield Close
    The Common
    CF37 4AB Pontypridd
    Segretario
    25 Wingfield Close
    The Common
    CF37 4AB Pontypridd
    British76742540002
    LITTLE, Mark Richard
    57 Broadwick Street
    London
    W1F 9QS
    Segretario
    57 Broadwick Street
    London
    W1F 9QS
    British93642950001
    MCEWAN, Andrew Gilmour
    376 Wootton Road
    PE30 3EA Kings Lynn
    Norfolk
    Segretario
    376 Wootton Road
    PE30 3EA Kings Lynn
    Norfolk
    British2681910001
    OLIVER, Andrew Winship
    19 Mount Park Road
    Ealing
    W5 2RS London
    Segretario
    19 Mount Park Road
    Ealing
    W5 2RS London
    British35023000004
    ROSE, Belinda
    45 Reginald Road
    HA6 1EF Northwood
    Middlesex
    Segretario
    45 Reginald Road
    HA6 1EF Northwood
    Middlesex
    British90092080001
    STEPHENS, Julia
    Chapel Lodge
    Old Stockbridge Road Sutton Scotney
    SO21 3JW Winchester
    Hampshire
    Segretario
    Chapel Lodge
    Old Stockbridge Road Sutton Scotney
    SO21 3JW Winchester
    Hampshire
    British63984570001
    ALDRIDGE, Mark Nicholas Kennedy
    57 Broadwick Street
    London
    W1F 9QS
    Amministratore
    57 Broadwick Street
    London
    W1F 9QS
    EnglandBritish168411280001
    ALDRIDGE, Mark Nicholas Kennedy
    57 Broadwick Street
    London
    W1F 9QS
    Amministratore
    57 Broadwick Street
    London
    W1F 9QS
    EnglandBritish168411280001
    ASPLIN, Robert Alexander
    57 Broadwick Street
    London
    W1F 9QS
    Amministratore
    57 Broadwick Street
    London
    W1F 9QS
    United KingdomBritish149870270004
    ATWAL, Harminder Singh
    Evesham Street
    W11 4AJ London
    2nd Floor, The White Building, 11
    United Kingdom
    Amministratore
    Evesham Street
    W11 4AJ London
    2nd Floor, The White Building, 11
    United Kingdom
    United KingdomBritish167976490001
    BAIN, Neville Clifford, Dr
    High Trees
    Cavendish Road St Georges Hill
    KT13 0JX Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    High Trees
    Cavendish Road St Georges Hill
    KT13 0JX Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish48436050001
    BALL, John Adrian
    Watersmeet
    Mill Lane
    RG9 3LY Shiplake
    Oxfordshire
    Amministratore
    Watersmeet
    Mill Lane
    RG9 3LY Shiplake
    Oxfordshire
    British11182730003
    BILLING, Mark Pemberton
    Old Blackhorse Cottage
    Old Dinton Road Teffont
    SP3 5QX Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Old Blackhorse Cottage
    Old Dinton Road Teffont
    SP3 5QX Salisbury
    Wiltshire
    British54813590002
    BURNETT, Patricia Ann
    The Conifers
    Seabrook Road
    WD4 8NU Kings Langley
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Conifers
    Seabrook Road
    WD4 8NU Kings Langley
    Hertfordshire
    EnglandBritish70101270002
    CHRISTMAS, Joan Iris
    91 Napier Court
    Ranelagh Gardens
    SW6 3XA London
    Amministratore
    91 Napier Court
    Ranelagh Gardens
    SW6 3XA London
    United KingdomBritish108153250001
    COTTERELL, Rebecca Jane
    Pebworth Fields House
    Pebworth
    CV37 8XP Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Pebworth Fields House
    Pebworth
    CV37 8XP Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British56625580002
    CRANSTON, John Charles
    8 Nottingham Road
    NG25 0LF Southwell
    Nottinghamshire
    Amministratore
    8 Nottingham Road
    NG25 0LF Southwell
    Nottinghamshire
    EnglandBritish145205440001
    EARL, Belinda
    57 Broadwick Street
    W1F 9QS London
    Amministratore
    57 Broadwick Street
    W1F 9QS London
    United KingdomBritish97792020001
    EDGERTON, Graham John
    57 Broadwick Street
    London
    W1F 9QS
    Amministratore
    57 Broadwick Street
    London
    W1F 9QS
    United KingdomBritish87214070001
    GIBBS, Antony Wood
    Green Acre Buddon Lane
    Quorn
    LE12 8AA Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Green Acre Buddon Lane
    Quorn
    LE12 8AA Loughborough
    Leicestershire
    British13897740001
    HARRISON, Fiona Mary
    Yew Tree Cottage
    North Heath
    RG20 8UD Chieveley
    Newbury
    Amministratore
    Yew Tree Cottage
    North Heath
    RG20 8UD Chieveley
    Newbury
    British40555070001
    HENRY, Colin Glen
    57 Broadwick Street
    London
    W1F 9QS
    Amministratore
    57 Broadwick Street
    London
    W1F 9QS
    EnglandBritish185041040002
    HOLT, David Leslie Frank
    Stonelow Flat Farm
    S42 7DE Eastmoor
    Derbyshire
    Amministratore
    Stonelow Flat Farm
    S42 7DE Eastmoor
    Derbyshire
    British73659860001
    HOOPER, Mark
    20 Grovelands Avenue
    SN1 4ET Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    20 Grovelands Avenue
    SN1 4ET Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish74493130001
    JACKSON, Kenneth
    Flat 1 Hurlingham Court
    Ranelagh Gardens
    SW6 3SH London
    Amministratore
    Flat 1 Hurlingham Court
    Ranelagh Gardens
    SW6 3SH London
    British74203110001
    JOHHNSON, Rodney Norman Meredew
    10 Wilson Ridge
    FOREIGN E Darien
    Connecticut 06820
    Usa
    Amministratore
    10 Wilson Ridge
    FOREIGN E Darien
    Connecticut 06820
    Usa
    British29573610001
    KOZLOWSKI, Richard Leon
    57 Broadwick Street
    London
    W1F 9QS
    Amministratore
    57 Broadwick Street
    London
    W1F 9QS
    EnglandBritish124967710001
    LOMAX, Frank William
    Pipers 8 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Pipers 8 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British29573620001
    MACKENZIE, Andrew Macgregor
    57 Broadwick Street
    London
    W1F 9QS
    Amministratore
    57 Broadwick Street
    London
    W1F 9QS
    United KingdomBritish38695210004

    JAEGER HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 02 dic 2015
    Consegnato il 18 dic 2015
    In corso
    Breve descrizione
    L/H land at 2 livery street, leamington spa t/no WK471415 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • BECAP12 Gp Limited, as General Partner of BECAP12 Gp LP, as General Partner of BECAP12 Fund LP
    Transazioni
    • 18 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 14 ott 2015
    Consegnato il 16 ott 2015
    In corso
    Breve descrizione
    L/H 20-20A high street amersham bucks t/no BM306574 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • BECAP12 Gp Limited, as General Partner of BECAP12 Gp LP, as General Partner of BECAP12 Fund LP
    Transazioni
    • 16 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 26 mar 2014
    Consegnato il 01 apr 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • BECAP12 Gp Limited
    Transazioni
    • 01 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Security agreement
    Creato il 05 apr 2013
    Consegnato il 16 apr 2013
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the loan note parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • BECAP12 Gp Limited
    Transazioni
    • 16 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Security agreement
    Creato il 16 apr 2012
    Consegnato il 24 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Macsco 40 Limited (Now Known as Becap Jaeger (UK) Limited)
    Transazioni
    • 24 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Security agreement
    Creato il 16 apr 2012
    Consegnato il 24 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Macsco 40 Limited (Now Known as Becap Jaeger (UK) Limited)
    Transazioni
    • 24 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Security agreement
    Creato il 13 apr 2012
    Consegnato il 24 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • BECAP12 Spv 2 Limited
    Transazioni
    • 24 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 31 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 12 mag 2010
    Consegnato il 18 mag 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 12 mag 2010
    Consegnato il 18 mag 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 04 apr 2003
    Consegnato il 16 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 35 bicester village bicester cheshire oaks unit 48 unit 13 great western designer outlet village churchwood swindon * please refer to form 395 for further details of property charged *. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transazioni
    • 16 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 11 mar 2003
    Consegnato il 21 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Dow Peter Famulak
    Transazioni
    • 21 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 11 mar 2003
    Consegnato il 18 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transazioni
    • 18 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 feb 2003
    Consegnato il 25 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Amphitrite Limited
    Transazioni
    • 25 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 mag 1948
    Consegnato il 25 mag 1948
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Further security for a series of debentures aggregating £100,000 and a debenture for £130,000 dated 16 june 1921
    Brevi particolari
    Forest house and land adjoining fronting leicester road and sullington road shipshed,leicestershire together with plant machinery fixtures implements and utensils present and future title no.p 177837.
    Persone aventi diritto
    • Branch Nominees LTD
    Transazioni
    • 25 mag 1948Registrazione di un'ipoteca
    • 22 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 mag 1948
    Consegnato il 25 mag 1948
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Further security for a debenture dated 17 nov 1947
    Brevi particolari
    Forest house and land adjoining fronting leicester rd.and sullington road,shipshed leicestershire together with plant machinery fixtures implements and utensils present and future.t/no.p 177837.
    Persone aventi diritto
    • Branch Nominees LTD
    Transazioni
    • 25 mag 1948Registrazione di un'ipoteca
    • 23 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    JAEGER HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 apr 2017Inizio dell'amministrazione
    20 apr 2020Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ryan Kevin Grant
    Alix Partners Services Uk Llp
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    Praticante
    Alix Partners Services Uk Llp
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    Catherine Williamson
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praticante
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Peter Mark Saville
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Praticante
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0