COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY

COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOSALT PUBLIC LIMITED COMPANY
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 00019628
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Indirizzo della sede legale
    7 Savoy Court
    WC2R 0EX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Indirizzo della sede legale modificato da 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP a 7 Savoy Court London WC2R 0EX in data 07 gen 2023

    3 pagineAD01

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 12 feb 2015

    17 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 12 feb 2015

    17 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 12 feb 2015

    17 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 lug 2014

    15 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 lug 2014

    14 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 27 gen 2014

    15 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 14 ago 2013

    17 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    20 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    262 pagine2.16B

    Cessazione della carica di Denise Brenda Robinson come segretario in data 28 feb 2013

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da , Suite 9 the Innovation Centre, Innovation Way Europarc, Grimsby, South Humberside, DN37 9TT, United Kingdom in data 05 mar 2013

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Chi sono gli amministratori di COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROSS, David Peter John
    Savoy Court
    WC2R 0EX London
    7
    Amministratore
    Savoy Court
    WC2R 0EX London
    7
    EnglandBritish43841990004
    SANDS, Trevor Martin
    Savoy Court
    WC2R 0EX London
    7
    Amministratore
    Savoy Court
    WC2R 0EX London
    7
    United KingdomUnited Kingdom164235220001
    CARRICK, Neil Richard
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Segretario
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    British166312330001
    ROBINSON, Denise Brenda
    Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    33
    West Yorkshire
    Segretario
    Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    33
    West Yorkshire
    161118380001
    WOOD, Frederick William
    5 Westlands Avenue
    DN34 4SP Grimsby
    North East Lincolnshire
    Segretario
    5 Westlands Avenue
    DN34 4SP Grimsby
    North East Lincolnshire
    British3783250001
    BOLTON, David Martin
    11 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    Amministratore
    11 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish47618000001
    BRIAN, Edward Arthur
    The Red House Coppice Lane
    RH2 9JF Reigate
    Surrey
    Amministratore
    The Red House Coppice Lane
    RH2 9JF Reigate
    Surrey
    British1786140001
    CAMAMILE, Gerrard Hugh
    Brandon House
    23 Lee Road
    LN2 4BJ Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    Brandon House
    23 Lee Road
    LN2 4BJ Lincoln
    Lincolnshire
    British17499800001
    CARRICK, Neil Richard
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Amministratore
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    EnglandBritish166312330001
    DEAN, James Fitzroy
    East Mere House
    Bracebridge Heath
    LH4 2JB Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    East Mere House
    Bracebridge Heath
    LH4 2JB Lincoln
    Lincolnshire
    EnglandBritish83206610001
    DOVER, Densmore Ronald
    166 Furzehill Road
    WD6 2DS Borehamwood
    Hertfordshire
    Amministratore
    166 Furzehill Road
    WD6 2DS Borehamwood
    Hertfordshire
    British4248760001
    GILBERT, Simon George
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Amministratore
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    United KingdomBritish124680260001
    HOBDEY, David William
    Woodlands Barn
    Risplith
    HG4 3EW Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    Woodlands Barn
    Risplith
    HG4 3EW Ripon
    North Yorkshire
    British64819580003
    JONSSON, Per Anders
    263 Petersham Road
    TW10 7DA Richmond
    Surrey
    Amministratore
    263 Petersham Road
    TW10 7DA Richmond
    Surrey
    EnglandSwedish189569310001
    KELLY, John Anthony Brian
    Fish Dock Road
    Grimsby
    DN31 3NW N E Lincolnshire
    Amministratore
    Fish Dock Road
    Grimsby
    DN31 3NW N E Lincolnshire
    EnglandBritish135315330001
    LEJMAN, Mark Timothy
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Amministratore
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    United KingdomBritish153003320001
    LLOYD, Raoul Charles Francois
    Chilham 5 Park Drive
    DN32 0EE Grimsby
    South Humberside
    Amministratore
    Chilham 5 Park Drive
    DN32 0EE Grimsby
    South Humberside
    British3858760001
    MCCONNELL, John
    12 Orme Court
    W2 4RL London
    Amministratore
    12 Orme Court
    W2 4RL London
    EnglandBritish35560050002
    MELVILLE, Calum Gerrard
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Amministratore
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    ScotlandBritish77620530002
    MURRAY, John Kenneth
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Amministratore
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    ScotlandBritish135415610001
    NEVITT, Peter Thomas
    Carlbury Court Durham Lane
    Piercebridge
    DL2 3TW Darlington
    County Durham
    Amministratore
    Carlbury Court Durham Lane
    Piercebridge
    DL2 3TW Darlington
    County Durham
    United KingdomBritish61356370001
    OPHIR, Yarom
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Amministratore
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    SwitzerlandSwiss130890500001
    PEACOCK, Matthew Roy
    Villa Santa Maddalena
    Strada Santa Maddalena
    Amelia
    Tr 05022
    Italy
    Amministratore
    Villa Santa Maddalena
    Strada Santa Maddalena
    Amelia
    Tr 05022
    Italy
    ItalyBritish104718150001
    PHILLIPS, Evan Devonald Winston
    Highfield House
    Ings Lane
    LN11 0TX Fotherby
    Lincolnshire
    Amministratore
    Highfield House
    Ings Lane
    LN11 0TX Fotherby
    Lincolnshire
    EnglandBritish75342720006
    POWELL, Roderick Hugh Evelyn
    319 South Union Street
    VA 22314 Alexandria
    United States
    Amministratore
    319 South Union Street
    VA 22314 Alexandria
    United States
    American115964220001
    REYNOLDS, Michael Thomas
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Amministratore
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    United KingdomBritish4978610002
    THOMAS, Adrian Peter Harrison
    26 Hartley Road
    WA14 4AY Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    26 Hartley Road
    WA14 4AY Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish26500450003
    WHITE, Maurice Alistair
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Amministratore
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    United KingdomBritish41337310002
    WOOD, Frederick William
    Pleasant House
    Pleasant Place
    LN11 0NA Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    Pleasant House
    Pleasant Place
    LN11 0NA Louth
    Lincolnshire
    United KingdomBritish3783250004

    COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 15 ago 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the south east side of bell street fish quay northshields t/no TY308134,f/h land and buildings on the west side of brickyard lane melton t/no's HS262302 and YEA3057, 60 sixhills street land and buildings to the south sixhills street and land and buidlings at convamore road and heneage road grimsby t/no's HS36616,HS114302,HS19612,HS18994,HS58210 and HS332319 and associated rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Frederick William Wood,Ronald Briggs Heaton,Paul Arthur Bradbury,Alan Smith and Vincent Roger Whyte Mccracken (The "Pension Trustees")
    Transazioni
    • 15 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2013Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Legal charge
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 06 ago 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the south east side of bell street fish quay north shields t/no TY308134, f/h number 3 factory school road lowestoft and land lying on the west side of school lane lowestoft t/nos SK139594 and SK68171, f/h land and buildings on the west side of brickyard lane melton t/nos HS262302 and YEA3057 (for details of further properties charged please refer to the form 395); any buildings fixtures fixed plant and machinery situated thereon. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 06 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2013Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Standard security
    Creato il 08 apr 2009
    Consegnato il 19 mag 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a and forming 18 palmerston road aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited, as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 19 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security
    Creato il 08 apr 2009
    Consegnato il 12 mag 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    18 palmerston road, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • The Pension Trustees, Frederick William Wood, Ronald Briggs Heaton, Paul Arthur Bradbury, Alan Smith, Vincent Rodger Whyte Mccracken
    Transazioni
    • 12 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Share pledge
    Creato il 26 mar 2009
    Consegnato il 09 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title interest and benefit in and to the shares and/or other securities and all stocks shares and investments together with any dividends see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Cimpany (UK) Limited (the "Security Trustee")
    Transazioni
    • 09 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite debenture
    Creato il 26 mar 2009
    Consegnato il 09 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery (for details of the actual property charged please refer to the form 395). see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Frederick William Wood, Ronald Briggs Heaton, Paul Arthur Bradbury, Alan Smith and Vincent Rodger Whyte Mccracken as the Trustees of the Cosalt Retirement Plan
    Transazioni
    • 09 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2013Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Debenture
    Creato il 26 mar 2009
    Consegnato il 04 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and buildings on the west side of brickyard lane melton t/no’s (for further details of property charged please refer to form 395) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (the "Security Trustee")
    Transazioni
    • 04 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2013Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Legal charge over shares
    Creato il 26 mar 2009
    Consegnato il 04 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares and the distribution rights from time to time accruing to or on the shares see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 04 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge over shares
    Creato il 01 ago 2008
    Consegnato il 06 ago 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First legal mortgage, the shares and the distribution rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 19 apr 1996
    Consegnato il 23 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 15TH october 1990
    Brevi particolari
    Land fronting clive street, north shields, tyne and wear.
    Persone aventi diritto
    • Tyne and Wear Development Corporation
    Transazioni
    • 23 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 nov 1995
    Consegnato il 25 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a project finance agreement dated 15TH october 1990
    Brevi particolari
    Premises situate and fronting to liddell street and clive street, north shields, tyne & wear.
    Persone aventi diritto
    • Tyne and Wear Development Corporation
    Transazioni
    • 25 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 feb 1993
    Consegnato il 03 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 12/10/90
    Brevi particolari
    Land at bell street north shields tyne and wear.
    Persone aventi diritto
    • Tyne and Wear Development Corporation
    Transazioni
    • 03 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 giu 1992
    Consegnato il 19 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the project finance agreement dated 12/10/90
    Brevi particolari
    Land & buildings fronting on to liddell street north shields tyne and wear.
    Persone aventi diritto
    • Tyne and Wear Development Corporation
    Transazioni
    • 19 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of substitution and charge.
    Creato il 28 nov 1986
    Consegnato il 03 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 29/12/86 as varied by a deed of variation and charge dated 13/5/86
    Brevi particolari
    All that area of land containing 1,225 acres (5930 sq yds) or thereabouts together with the building known as number 3 factory and all other buildings and structures thereon situated at or near school road lowestoft. Suffolk.
    Persone aventi diritto
    • Royal Insurance PLC
    Transazioni
    • 03 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 12 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 26 set 1986
    Consegnato il 07 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 24/8/70.
    Brevi particolari
    A specific charge over the benefit of all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 22 lug 1986
    Consegnato il 25 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H premises scott lane, morley yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 25 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    Deed of verification and charge
    Creato il 13 mag 1986
    Consegnato il 13 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £184,134.55 and all other monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 29/12/66.
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Royal Insurance PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 12 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security registered at sasines on the 09/02/83
    Creato il 13 ott 1982
    Consegnato il 17 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £22,500
    Brevi particolari
    All and whole that area of fround in the parish of killirnie ayr extending to 1.692 acres together with the subjects k/a and forming stoney holm mill kilbirnie ayr.
    Persone aventi diritto
    • Barbow Campbell Threads Limited
    Transazioni
    • 17 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    Aircraft mortgage
    Creato il 23 dic 1980
    Consegnato il 13 mar 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £60,000
    Brevi particolari
    Aircraft - partenavia P6 8B reg mark g- bgxj (see doc M439 for details).
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central LTD
    Transazioni
    • 13 mar 1981Registrazione di un'ipoteca
    Aircraft mortgage
    Creato il 02 lug 1980
    Consegnato il 04 lug 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £60,000
    Brevi particolari
    Aircraft partenavia P68B g-bgbt victor.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central LTD
    Transazioni
    • 04 lug 1980Registrazione di un'ipoteca
    Deed of rectification and charge
    Creato il 30 dic 1974
    Consegnato il 16 gen 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee secured by a charge dated 29.12.1966 and other deeds referred to therein.
    Brevi particolari
    Land at grimsby containing 9,833 sq yds (approx).
    Persone aventi diritto
    • Royal Insurance Company Limited
    Transazioni
    • 16 gen 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 12 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 15 nov 1971
    Consegnato il 24 apr 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £42,835 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    1.45 acres at macanochie rd industrial estates, fraserburgh with all buildings erected thereon.
    Persone aventi diritto
    • The County Council of Aberdeen
    Transazioni
    • 24 apr 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 11 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of substitution and charge
    Creato il 11 nov 1971
    Consegnato il 15 nov 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 and all other monies secured by a charge dated 31.12.1966 and deeds supplemental of thereto
    Brevi particolari
    Property on the north west side of fish dock rd, grimsby.
    Persone aventi diritto
    • Royal Insurance Company Limited
    Transazioni
    • 15 nov 1971Registrazione di un'ipoteca
    • 12 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of confirmation and agreement
    Creato il 27 ott 1969
    Consegnato il 07 nov 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 secured by a charge dated 29.12.1966
    Brevi particolari
    Floating charge over the whole of the property which may from time to time be comprised in the property and undertaking of the company.
    Persone aventi diritto
    • Royal Insurance Company Limited
    Transazioni
    • 07 nov 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 12 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage by ex-facia absolute disposition
    Creato il 05 set 1968
    Consegnato il 16 set 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing £375,000 due from the company to the chargee secured by & charges dated 27.3.1953, 25.4.1960, and 29.12.1960 respectively.
    Brevi particolari
    3 pieces of land lying on the west side of market st and the north side o palmerston rd, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Royal Insurance Company Limited
    Transazioni
    • 16 set 1968Registrazione di un'ipoteca
    • 12 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    COSALT PUBLIC LIMITED COMPANY ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 feb 2015Fine dell'amministrazione
    15 feb 2013Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Ross
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    David James Kelly
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praticante
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0