ELECTRA INVESTMENTS LIMITED

ELECTRA INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàELECTRA INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00021895
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ELECTRA INVESTMENTS LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova ELECTRA INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    No 1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ELECTRA INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ELECTRA PRIVATE EQUITY LIMITED25 gen 202225 gen 2022
    ELECTRA INVESTMENTS LIMITED11 dic 188511 dic 1885

    Quali sono gli ultimi bilanci di ELECTRA INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per ELECTRA INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 mag 2023

    9 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    9 pagineLIQ10

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 17 Old Park Lane London W1K 1QT

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 17 Old Park Lane London W1K 1QT

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 17 Old Park Lane London W1K 1QT United Kingdom a No 1 Colmore Square Birmingham B4 6HQ in data 08 giu 2022

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 26 mag 2022

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed electra private equity LIMITED\certificate issued on 24/05/22
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name24 mag 2022

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 24 mag 2022

    RES15

    Cessazione della carica di Frostrow Capital Llp come segretario in data 16 mag 2022

    1 pagineTM02

    Stato del capitale al 31 gen 2022

    • Capitale: GBP 0.87
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 27/01/2022
    RES13

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2021 al 30 gen 2022

    1 pagineAA01

    Modifica dei dettagli di Electra Private Equity Plc come persona con controllo significativo il 21 gen 2022

    2 paginePSC05

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed electra investments LIMITED\certificate issued on 25/01/22
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name25 gen 2022

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 25 gen 2022

    RES15

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Paul Andrew Goodson come amministratore in data 29 nov 2021

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2020

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2019

    18 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ELECTRA INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GOODSON, Paul Andrew
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    Amministratore
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    United KingdomBritish290021750001
    JOHNSON, Neil Anthony
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    Amministratore
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    EnglandBritish246850890001
    MANSON, Gavin Maxwell
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    Amministratore
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    ScotlandBritish167197560001
    ABSALOM, Gerard
    25 Cotland Acres
    Pendleton Road
    RH1 6JZ Redhill
    Surrey
    Segretario
    25 Cotland Acres
    Pendleton Road
    RH1 6JZ Redhill
    Surrey
    British58383520001
    DYKE, Philip John
    Paternoster House
    65 St Paul's Churchyard
    EC4M 8AB London
    Segretario
    Paternoster House
    65 St Paul's Churchyard
    EC4M 8AB London
    British5946990002
    FROSTROW CAPITAL LLP
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    United Kingdom
    Segretario
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    United Kingdom
    Forma giuridicaLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Tipo di documento di identificazioneAltra persona giuridica o impresa
    Autorità legaleLIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2000
    Numero di registrazioneOC323835
    235460980001
    BRAMSON, Edward John Michael
    50 Grosvenor Hill
    W1K 3QT London
    First Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    50 Grosvenor Hill
    W1K 3QT London
    First Floor
    United Kingdom
    United StatesBritish202686310001
    BROWN, James Richard
    The Oast House
    Dale Hill Ticehurst
    TN5 7DG
    East Sussex
    Amministratore
    The Oast House
    Dale Hill Ticehurst
    TN5 7DG
    East Sussex
    British5691410001
    COOPER-EVANS, Alexander Christopher
    50 Grosvenor Hill
    W1K 3QT London
    First Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    50 Grosvenor Hill
    W1K 3QT London
    First Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish204978360001
    DYKE, Philip John
    Paternoster House
    65 St Paul's Churchyard
    EC4M 8AB London
    Amministratore
    Paternoster House
    65 St Paul's Churchyard
    EC4M 8AB London
    EnglandBritish5946990002
    GRIMDITCH, Andrew Richard
    50 Grosvenor Hill
    W1K 3QT London
    First Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    50 Grosvenor Hill
    W1K 3QT London
    First Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish244273730001
    HOLLAND MUMFORD, Hugh Anthony Lewis
    50 Grosvenor Hill
    W1K 3QT London
    First Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    50 Grosvenor Hill
    W1K 3QT London
    First Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish35559180001
    KNOTT, Julian David
    10 Elthiron Road
    SW6 4BN London
    Amministratore
    10 Elthiron Road
    SW6 4BN London
    EnglandBritish6017540001
    LEWIS, Robert John
    Fairstead Farmhouse
    Spexhall
    IP19 0RF Halesworth
    Suffolk
    Amministratore
    Fairstead Farmhouse
    Spexhall
    IP19 0RF Halesworth
    Suffolk
    EnglandBritish5948580003
    OZIN, Stephen Daryl
    50 Grosvenor Hill
    W1K 3QT London
    First Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    50 Grosvenor Hill
    W1K 3QT London
    First Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish49182070003
    ROBERT, Stephen
    730 Park Avenue
    10021 New York
    Usa
    Amministratore
    730 Park Avenue
    10021 New York
    Usa
    American63647700001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ELECTRA INVESTMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Unbound Group Plc
    Old Park Lane
    W1K 1QT London
    17
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Old Park Lane
    W1K 1QT London
    17
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPublic Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House Registry England And Wales
    Numero di registrazione00303062
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ELECTRA INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture (the "debenture") between the hemingway no.2 Limited partnership (the "chargor") and the bank. The company is a limited partner of the hemingway umbrella limited partnership which is the limited partner of the chargor
    Creato il 25 lug 2001
    Consegnato il 13 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the liabilities due or to become due from the chargor to the chargee under or in connection with the guarantee of even date together with the expenses (as defined)
    Brevi particolari
    F/H property k/a the citadel and 42 / 62 pinstone street sheffield t/no: SYK409372 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over accounts dated 19 may 2000 between hemingway castle limited, the partnership and the bank. The partnership consists of hemingway castle limited as general partner and hemingway umbrella limited partnership as limited partner; hemingway umbrella limited partnership consists of the company as general partner and others as limited partners.
    Creato il 19 mag 2000
    Consegnato il 20 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Chargee by hemingway castle limited (in its capacity as borrower under the hemingway castle loan agreement and/or as general partner in the partnership) and/or as general partner in the partnership to the chargee under pursuant to or in connection with the finance documents (including without limitation the charge) (the secured obligations)
    Brevi particolari
    All right title benefit and interest in the deposited monies together with any certificates of deposit, deposit receipts or other instruments or securities relating thereto.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Hyp Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg A.G.
    Transazioni
    • 20 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge between hemingway gp no.2 Limited and hemingway nominee no.2 Limited (the "chargors") and the bank, the "chargors" hold theproperty trust for the hemingway no.2 Limited partnership (the "borrower")
    Creato il 28 gen 2000
    Consegnato il 03 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the "borrower" to the chargee of any kind under or in connection with a facility agreement dated 8 june 1998 as amended or supplemented from time to time (as defined) all security documents and any related hedging or overdraft arrangements
    Brevi particolari
    The property known as 48-56 (even)queens road and 2-7 (inc) elmdale road bristol BS8 1RE title number BL58353.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge between hemingway gp no.2 Limited and hemingway nominee no.2 Limited (the "chargors") and the bank, the "chargors" hold the property on trust for the hemingway no.2 Limited partnership (the "borrower")
    Creato il 17 giu 1999
    Consegnato il 28 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the "borrower" to the chargee of any kind under or in connection with a facility agreement dated 8TH june 1998 as amended or supplemented from time to time (as defined) all security documents and any related hedging or overdraft arrangements
    Brevi particolari
    The salvation army and 42/62 pinstone st,city of sheffield and proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 giu 1999
    Consegnato il 15 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the hemingway no.2 Limited partnership ("the borrower") to the chargee of any kind under or in connection with a facility agreement dated 8 june 1998 as amended or supplemented from time to time all security documents granted to the chargee as security for the obligations of "the borrower" under the facility agreement and any related hedging or overdraft arrangements
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all legal interests and otherwise by way of fixed charge the property at lewis house 3-4 manvers street bath-AV79740 (to the full extent of their interest in the property or its proceeds of sale).
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 giu 1999
    Consegnato il 15 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All liabilities of the hemingway no.2 Limited partnership (the "borrower") of any kind under or in connection with a facility agreement dated 8 june 1998, all security documents and any related hedging or overdraft arrangements between the borrower and the chargee
    Brevi particolari
    The property k/a 104-109 queens road brighton t/n SX133715 and the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 giu 1999
    Consegnato il 15 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All liabilities of the hemingway no.2 Limited partnership (the "borrower") of any kind under or in connection with a facility agreement dated 8 june 1998, all security documents and any related hedging or overdraft arrangements between the borrower and the chargee
    Brevi particolari
    The property k/a 12 cock lane london t/n 218763 and the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge between hemingway gp no.2 Limited and hemingway nominee no.2 Limited (the chargors) and the bank, the chargors hold the property on trust for the hemingway no.2 Limited partnership (the borrower) and the company is a limited partner of the hemingway umbrella limited partnership which is the limited partner of the borrower
    Creato il 16 dic 1998
    Consegnato il 29 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the hemingway no.2 Limited partnership ("the borrower") to the chargee of any kind under or in connection with a facility agreement dated 8 june 1998 as amended or supplemented from time to time all security documents granted to the chargee as security for the obligations of "the borrower" under the facility agreement and any related hedging or overdraft arrangements
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all legal interests and otherwise by way of fixed charge the property at 73/75 high street and 18/32 the mall, bromley t/n's SGL587654 and SGL235868 or its proceeds of sale.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge (the legal charge) between hemingway gp no.2 Limited and hemingway nominee no.2 Limited (the chargors) (1) and the bank (2) the chargors hold the property on trust for the hemingway no.2 Limited partnership (the borrower) and the company is a limited partner of the hemingway umbrella limited partnership which is the limited partner of (the borrower)
    Creato il 03 lug 1998
    Consegnato il 09 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the liabilities of the hemingway no.2 Limited partnership (the borrower) to the chargee under or in connection with a facility agreement dated 8TH june 1998 as amended or supplemented from time to time (the facility agreement) all security documents granted to the chargee as security for the obligations of the (borrower) under the facility agreement and any related hedging or overdraft arrangements between the (borrower) and the chargee together with all expenses
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the property at 190/192 high street and 1 manor place sutton t/no's SY266848 and SY226427.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture (between the hemingway no.2 Limited partnership (the "borrower") hemingway gp no.2 Limited and hemingway nominee no.2 Limited (the "chargors") and the bank, the company is a limited partner of the hemingway umbrella limited partnership which is the limited partner of the "borrower")
    Creato il 03 lug 1998
    Consegnato il 09 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the hemingway no.2 Limited partnership (the "borrower") to the chargee of any kind under or in connection with a facility agreement dated 8 june 1998 as amended or supplemented from time to time (as defined) all security documents and any related hedging or overdraft arrangements
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all the f/h and l/h property and its proceeds of sale at the creation date vested in or charged to the chargors or the borrower including the property at 190/192 high street and 1 manor place sutton t/n's SY266848 and SY226427, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fittings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over accounts
    Creato il 19 mar 1998
    Consegnato il 04 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities whether actual or contingent now or at any time hereafter due owing or incurred to deutsche hypothekenbank frankfurt A.G. by hemingway castle limited (in its capacity as borrower under the hemingway castle loan agreement and/or as general partner in the partnership) and/or the partnership in whatever style name or form and whether as principal or surety under pursuant to or in connection with the finance documents (including the charge)
    Brevi particolari
    All right title and interest in the deposit monies please refer to form 395 for full details of charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Hypothekenbank Frankfurt A.G.
    Transazioni
    • 04 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture document (the "partnership debenture")
    Creato il 19 mar 1998
    Consegnato il 04 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    A) all monies,obligations and liabilities whether actual or contingent now or at any time hereafter due.owing or incurred to deutsche hypothekenbank frankfurt ag by the partnership and/or the general partner in whatever name style or form and whether as principal or surety under,pursuant to, or in connection with, the finance documents (as defined) including without limitation the partnership debenture b)in resepct only of the security created under clause 3.2 of the partnership agreement,the indebtedness (as defined in the consent agreement) which the partnership agreed to BEC0ME liable for pursuant to the terms of the consent agreement
    Brevi particolari
    Properties at 10 and 11 castle hill windsor t/n's BK119914 and BK152175 and property at 13 high street windsor t/n BK114983 and other properties. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Hypothekenbank Frankfurt Ag
    Transazioni
    • 04 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture document (the "partnership debenture")
    Creato il 16 mar 1998
    Consegnato il 03 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities whether actual or contingent now or at any time hereafter due,owing or incurred by hemingway castle limited,partnership and/or the general partner in whatever name style or form to deutsche hypothekenbank frankfurt ag under pursuant to or in connection with the finance documents,the consent agreement and,including without limitation the partnership debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Hypothekenbank Frankfurt Ag
    Transazioni
    • 03 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ELECTRA INVESTMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 dic 2023Data prevista di scioglimento
    26 mag 2022Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Derek Hyslop
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Praticante
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Colin Peter Dempster
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Praticante
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Philip Heddell
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0