ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00023788 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED?
- Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Loudwater Mill Station Road HP10 9TY High Wycombe Buckinghamshire United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS LIMITED | 18 gen 1887 | 18 gen 1887 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2018 con aggiornamenti | 11 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 30 giu 2017 | 38 pagine | AA | ||||||||||
Stato del capitale al 07 dic 2017
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Notifica di Newsquest Media Group Limited come persona con controllo significativo il 12 lug 2017 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Amander Bradbeer come persona con controllo significativo il 12 lug 2017 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Nomina di Mr Neil Edward Carpenter come segretario in data 12 lug 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Alton Westrop come segretario in data 12 lug 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Henry Kennedy Faure Walker come amministratore in data 12 lug 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di un amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di un amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robin Nigel Freeman come amministratore in data 12 lug 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Paul Anthony Hunter come amministratore in data 12 lug 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Felix Richard Hetherington come amministratore in data 12 lug 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Amanda Jane Bradbeer come amministratore in data 12 lug 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Loudwater Mill Station Road High Wycombe HP10 9TY United Kingdom a Loudwater Mill Station Road High Wycombe Buckinghamshire HP10 9TY in data 14 lug 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lesley Susan Yates come segretario in data 12 lug 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lesley Susan Yates come segretario in data 12 lug 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Brannon House 123 Pyle Street Newport Isle of Wight PO30 1st a Loudwater Mill Station Road High Wycombe HP10 9TY in data 14 lug 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Felix Richard Hetherington come amministratore in data 12 lug 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anthony Peter Holmes come amministratore in data 12 lug 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARPENTER, Neil Edward | Segretario | The Quadrant, Brighton Road SM2 5AS Sutton Floors 9 & 10 Quadrant House England | 235539620001 | |||||||
| WESTROP, Simon Alton | Segretario | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | 235537740001 | |||||||
| FAURE WALKER, Henry Kennedy | Amministratore | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 235506580001 | |||||
| HUNTER, Paul Anthony | Amministratore | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | English | 69320190004 | |||||
| HARLOW, George Thomas | Segretario | Roof Tree St Albans Road PO38 1DE Ventnor Isle Of Wight | British | 1916550001 | ||||||
| YATES, Lesley Susan | Segretario | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill United Kingdom | 172726530001 | |||||||
| BRADBEER, Amanda Jane | Amministratore | Tintmarre 21 Gurnard Heights PO31 8EF Gurnard Isle Of Wight | England | British | 20171510002 | |||||
| BRADBEER, Richard Linthorn | Amministratore | Brannon House 123 Pyle Street PO30 1ST Newport Isle Of Wight | England | British | 1916560002 | |||||
| CHEVERTON, David Brian Barrie | Amministratore | 35 Osborne Court The Parade PO31 7QS Cowes Isle Of Wight | England | British | 35575280003 | |||||
| FREEMAN, Robin Nigel, Mr. (Managing Director) | Amministratore | Brannon House 123 Pyle Street PO30 1ST Newport Isle Of Wight | England | British | 18624590002 | |||||
| HAMMER, Mark Richard | Amministratore | Brannon House 123 Pyle Street PO30 1ST Newport Isle Of Wight | England | British | 22662210002 | |||||
| HETHERINGTON, Felix Richard | Amministratore | 8 Nelsons Quay Latimer Road PO33 1TA St Helens Isle Of Wight | England | British | 84823260001 | |||||
| HOLMES, Anthony Peter | Amministratore | Manor Farm Wellow Top Road, Wellow PO41 0TB Yarmouth Isle Of Wight | England | British | 50520720001 | |||||
| LAWSON, Marilyn Irene Celia | Amministratore | Devonshire House 5 Castle Road PO30 1DT Newport Isle Of Wight | New Zealander | 2089840001 | ||||||
| MONGER, Edwin George, Mr. | Amministratore | 49 West End Sherborne St John RG24 9LE Basingstoke Hampshire | England | British | 33396710001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newsquest Media Group Limited | 12 lug 2017 | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Miss Amander Bradbeer | 01 lug 2016 | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | Sì | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 27 nov 2015 Consegnato il 28 nov 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Plot 335 bluebell meadows newport isle of wight to be known as 12 saxon close bluebell meadows newport isle of wight. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share mortgage | Creato il 31 mar 1992 Consegnato il 02 apr 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a sale agreement dated 31/03/92 | |
Brevi particolari All tha shares in crossprint limited and any substituted securities and all dividends or interest paid or payable see form 395 for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share mortgage | Creato il 04 ott 1990 Consegnato il 22 ott 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a share sale agreement dated 4-10-90 | |
Brevi particolari All the sharer and any substituted securities in the company and all dividends or interest paid or payable after the date of the share mortgage and all shares (and the dividends or interests thereon). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 29 gen 1985 Consegnato il 01 feb 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 28 ott 1980 Consegnato il 31 ott 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 29 high street, 121 ryle street, newport, isle of wight. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0