ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED

ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00023788
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Loudwater Mill
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS LIMITED18 gen 188718 gen 1887

    Quali sono gli ultimi bilanci di ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2018 con aggiornamenti

    11 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 30 giu 2017

    38 pagineAA

    Stato del capitale al 07 dic 2017

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Notifica di Newsquest Media Group Limited come persona con controllo significativo il 12 lug 2017

    2 paginePSC02

    Cessazione di Amander Bradbeer come persona con controllo significativo il 12 lug 2017

    1 paginePSC07

    Nomina di Mr Neil Edward Carpenter come segretario in data 12 lug 2017

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Simon Alton Westrop come segretario in data 12 lug 2017

    2 pagineAP03

    Nomina di Henry Kennedy Faure Walker come amministratore in data 12 lug 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di un amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di un amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robin Nigel Freeman come amministratore in data 12 lug 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Paul Anthony Hunter come amministratore in data 12 lug 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Felix Richard Hetherington come amministratore in data 12 lug 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Amanda Jane Bradbeer come amministratore in data 12 lug 2017

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Loudwater Mill Station Road High Wycombe HP10 9TY United Kingdom a Loudwater Mill Station Road High Wycombe Buckinghamshire HP10 9TY in data 14 lug 2017

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Lesley Susan Yates come segretario in data 12 lug 2017

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Lesley Susan Yates come segretario in data 12 lug 2017

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Brannon House 123 Pyle Street Newport Isle of Wight PO30 1st a Loudwater Mill Station Road High Wycombe HP10 9TY in data 14 lug 2017

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Felix Richard Hetherington come amministratore in data 12 lug 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Anthony Peter Holmes come amministratore in data 12 lug 2017

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CARPENTER, Neil Edward
    The Quadrant, Brighton Road
    SM2 5AS Sutton
    Floors 9 & 10 Quadrant House
    England
    Segretario
    The Quadrant, Brighton Road
    SM2 5AS Sutton
    Floors 9 & 10 Quadrant House
    England
    235539620001
    WESTROP, Simon Alton
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    235537740001
    FAURE WALKER, Henry Kennedy
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish235506580001
    HUNTER, Paul Anthony
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandEnglish69320190004
    HARLOW, George Thomas
    Roof Tree
    St Albans Road
    PO38 1DE Ventnor
    Isle Of Wight
    Segretario
    Roof Tree
    St Albans Road
    PO38 1DE Ventnor
    Isle Of Wight
    British1916550001
    YATES, Lesley Susan
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    United Kingdom
    172726530001
    BRADBEER, Amanda Jane
    Tintmarre
    21 Gurnard Heights
    PO31 8EF Gurnard
    Isle Of Wight
    Amministratore
    Tintmarre
    21 Gurnard Heights
    PO31 8EF Gurnard
    Isle Of Wight
    EnglandBritish20171510002
    BRADBEER, Richard Linthorn
    Brannon House
    123 Pyle Street
    PO30 1ST Newport
    Isle Of Wight
    Amministratore
    Brannon House
    123 Pyle Street
    PO30 1ST Newport
    Isle Of Wight
    EnglandBritish1916560002
    CHEVERTON, David Brian Barrie
    35 Osborne Court
    The Parade
    PO31 7QS Cowes
    Isle Of Wight
    Amministratore
    35 Osborne Court
    The Parade
    PO31 7QS Cowes
    Isle Of Wight
    EnglandBritish35575280003
    FREEMAN, Robin Nigel, Mr. (Managing Director)
    Brannon House
    123 Pyle Street
    PO30 1ST Newport
    Isle Of Wight
    Amministratore
    Brannon House
    123 Pyle Street
    PO30 1ST Newport
    Isle Of Wight
    EnglandBritish18624590002
    HAMMER, Mark Richard
    Brannon House
    123 Pyle Street
    PO30 1ST Newport
    Isle Of Wight
    Amministratore
    Brannon House
    123 Pyle Street
    PO30 1ST Newport
    Isle Of Wight
    EnglandBritish22662210002
    HETHERINGTON, Felix Richard
    8 Nelsons Quay
    Latimer Road
    PO33 1TA St Helens
    Isle Of Wight
    Amministratore
    8 Nelsons Quay
    Latimer Road
    PO33 1TA St Helens
    Isle Of Wight
    EnglandBritish84823260001
    HOLMES, Anthony Peter
    Manor Farm
    Wellow Top Road, Wellow
    PO41 0TB Yarmouth
    Isle Of Wight
    Amministratore
    Manor Farm
    Wellow Top Road, Wellow
    PO41 0TB Yarmouth
    Isle Of Wight
    EnglandBritish50520720001
    LAWSON, Marilyn Irene Celia
    Devonshire House 5 Castle Road
    PO30 1DT Newport
    Isle Of Wight
    Amministratore
    Devonshire House 5 Castle Road
    PO30 1DT Newport
    Isle Of Wight
    New Zealander2089840001
    MONGER, Edwin George, Mr.
    49 West End
    Sherborne St John
    RG24 9LE Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    49 West End
    Sherborne St John
    RG24 9LE Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish33396710001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    England
    12 lug 2017
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01676637
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Miss Amander Bradbeer
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    01 lug 2016
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.

    ISLE OF WIGHT COUNTY PRESS GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 nov 2015
    Consegnato il 28 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Plot 335 bluebell meadows newport isle of wight to be known as 12 saxon close bluebell meadows newport isle of wight.
    Persone aventi diritto
    • Christopher Alexander Prew
    • Anthony Nicholas Bradshaw
    • Anthony Peter Holmes
    Transazioni
    • 28 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share mortgage
    Creato il 31 mar 1992
    Consegnato il 02 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a sale agreement dated 31/03/92
    Brevi particolari
    All tha shares in crossprint limited and any substituted securities and all dividends or interest paid or payable see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Peter Thomas Cross
    Transazioni
    • 02 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share mortgage
    Creato il 04 ott 1990
    Consegnato il 22 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a share sale agreement dated 4-10-90
    Brevi particolari
    All the sharer and any substituted securities in the company and all dividends or interest paid or payable after the date of the share mortgage and all shares (and the dividends or interests thereon).
    Persone aventi diritto
    • Peter Thomas Cross
    Transazioni
    • 22 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 22 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 29 gen 1985
    Consegnato il 01 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 feb 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 28 ott 1980
    Consegnato il 31 ott 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 29 high street, 121 ryle street, newport, isle of wight. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank LTD
    Transazioni
    • 31 ott 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 14 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0