NCNA PROPERTIES LIMITED

NCNA PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNCNA PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00023800
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NCNA PROPERTIES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova NCNA PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2nd Floor The Atrium
    31 Church Road
    TW15 2UD Ashford
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NCNA PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CNC PROPERTIES LIMITED25 lug 199625 lug 1996
    CLARKE NICKOLLS & COOMBS PUBLIC LIMITED COMPANY02 lug 199602 lug 1996
    CLARKE NICKOLLS & COOMBS PUBLIC LIMITED COMPANY19 gen 188719 gen 1887

    Quali sono gli ultimi bilanci di NCNA PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per NCNA PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 mar 2016

    20 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    18 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 mar 2015

    14 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 mar 2014

    14 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * 2Nd Floor, the Atrium 31 Church Road, Ashford Middlesex TW15 2UD* in data 20 mar 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    5 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 mag 2012

    Stato del capitale al 16 mag 2012

    • Capitale: GBP 24,930,000
    SH01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed cnc properties LIMITED\certificate issued on 10/05/12
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name10 mag 2012

    Risoluzione di cambio di nome della società il 08 mag 2012

    RES15
    change-of-name10 mag 2012

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2010

    30 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2009

    31 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Marie Annick Avis il 30 apr 2010

    2 pagineCH03

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2008

    31 pagineAA

    legacy

    12 pagine395

    legacy

    2 pagine403b

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2007

    32 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di NCNA PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AVIS, Marie Annick
    Brook Hill
    Farley Green
    GU5 9DN Albury
    Barn Cottage
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Brook Hill
    Farley Green
    GU5 9DN Albury
    Barn Cottage
    Surrey
    United Kingdom
    British91430630002
    LEVER, Gary Thomas
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    Amministratore
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    United KingdomBritish83224530001
    LOCKER, Robert John
    Beukenhof
    Tite Hill
    TW20 0NJ Englefield Green
    Surrey
    Amministratore
    Beukenhof
    Tite Hill
    TW20 0NJ Englefield Green
    Surrey
    EnglandBritish155603490001
    BLACKETT, Kathleen
    Sanderling Cottage
    8 Llanvair Close
    SL5 9HX South Ascot
    Berkshire
    Segretario
    Sanderling Cottage
    8 Llanvair Close
    SL5 9HX South Ascot
    Berkshire
    British1501820001
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    British2667400002
    WESTON, Carole Linda
    44 Stratford Road
    WD17 4NZ Watford
    Segretario
    44 Stratford Road
    WD17 4NZ Watford
    British62673550003
    ALCOCK, Roger Edward
    Palm Lodge Le Clos Des Goddards
    La Rue Des Goddards, Castel
    GY5 7JD Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    Palm Lodge Le Clos Des Goddards
    La Rue Des Goddards, Castel
    GY5 7JD Guernsey
    Channel Islands
    British71283060003
    CAPLAN, Steven Michael
    Lissadell
    High Street Church Eaton
    ST20 0AG Stafford
    Amministratore
    Lissadell
    High Street Church Eaton
    ST20 0AG Stafford
    United KingdomBritish80262910001
    CHUDNOFF, Andre
    Flat 5
    43 Lowndes Square
    SW1X 9JL London
    Amministratore
    Flat 5
    43 Lowndes Square
    SW1X 9JL London
    Liechtenstein100700001
    DUQUEMIN, Andrew Mark
    Albecq De Bas
    GY5 7HR Rue D'Albecq
    Castel
    Guernsey
    Amministratore
    Albecq De Bas
    GY5 7HR Rue D'Albecq
    Castel
    Guernsey
    British122812710001
    EAST, David John
    Dielament Manor Beaulieu Mews
    La Rue De Dielament Trinity
    JE3 5HX Jersey
    Channel Islands
    Amministratore
    Dielament Manor Beaulieu Mews
    La Rue De Dielament Trinity
    JE3 5HX Jersey
    Channel Islands
    British52936930001
    LEVER, Gary Thomas
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    Amministratore
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    United KingdomBritish83224530001
    LYALL, Eric
    Riders Grove
    Old Hall Green
    SG11 1DN Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    Riders Grove
    Old Hall Green
    SG11 1DN Ware
    Hertfordshire
    United KingdomBritish4704090001
    MAIS, Richard Jeremy Ian
    79 Seal Hollow Road
    TN13 3RY Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    79 Seal Hollow Road
    TN13 3RY Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish1464610001
    MATHIESON, George
    83 Blackheath Park
    SE3 0EU London
    Amministratore
    83 Blackheath Park
    SE3 0EU London
    British28292120001
    MATHIESON, Robert Alexander
    La Genevoise 7 Knighton Grange Road
    LE2 2LF Leicester
    Amministratore
    La Genevoise 7 Knighton Grange Road
    LE2 2LF Leicester
    British10741520002
    NEDHAM, Andrew James
    8 Furzedown Close
    TW20 9PY Egham
    Surrey
    Amministratore
    8 Furzedown Close
    TW20 9PY Egham
    Surrey
    British66426700001
    PROSSER, Richard John Stobart
    L'Amont De La Ville Bagot
    St. Ouen
    JE3 2DF Jersey
    Maison De La Ville Bagot
    Channel Isles
    Amministratore
    L'Amont De La Ville Bagot
    St. Ouen
    JE3 2DF Jersey
    Maison De La Ville Bagot
    Channel Isles
    British55233590001
    REED, Gavin Barras
    Whitehill
    KY3 0RW Aberdour
    Fife
    Amministratore
    Whitehill
    KY3 0RW Aberdour
    Fife
    British7790001
    SAMUEL, William
    Shambala 14 Cloch Road
    PA19 1AB Gourock
    Renfrewshire
    Amministratore
    Shambala 14 Cloch Road
    PA19 1AB Gourock
    Renfrewshire
    British266600001
    SPICER, Quentin Kenneth Frederick
    5 George Road
    St. Peter Port
    GY1 1BD Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    5 George Road
    St. Peter Port
    GY1 1BD Guernsey
    Channel Islands
    GuernseyEnglish71283100003
    UPTON, Richard
    Le Grouet
    La Rue Du Grouet
    JE3 8HL St Brelade
    Jersey
    Channel Islands
    Amministratore
    Le Grouet
    La Rue Du Grouet
    JE3 8HL St Brelade
    Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritish46440870005
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritish2667400002

    NCNA PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 26 ago 2009
    Consegnato il 01 set 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    Transazioni
    • 01 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating security document
    Creato il 16 dic 2004
    Consegnato il 22 dic 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Share charge
    Creato il 13 feb 2004
    Consegnato il 26 feb 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower and the chargor to the chargee (and/or the hedging counterparty and/or any associated company) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The investments including all rights of enforcement of the same.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transazioni
    • 26 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Charge on shares
    Creato il 04 apr 2003
    Consegnato il 17 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the investments being 150 b ordinary shares each of £1 and 1,672,000 redeemable preference shares of £1 each and all other stocks shares and securities of the borower and all dividends interest and other money payable to the company in respect of the investments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of subordination
    Creato il 15 ago 2001
    Consegnato il 22 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from nelson property holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All present and future liabilities of the borrower to the company whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 22 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 lug 2000
    Consegnato il 26 lug 2000
    In corso
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due to the secured parties by each charging company and each of the other obligors under the senior finance documents (or any of them) (as therein defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 26 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge
    Creato il 24 dic 1998
    Consegnato il 04 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the sum of £1,370,000 credited to account no 01000279 together with all other sums credited to the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 04 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Account charge deed
    Creato il 04 dic 1997
    Consegnato il 13 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement dated 4TH december 1997 and the security documents (as defined in the loan agreement) and any of them and all monies due under the account charge deed
    Brevi particolari
    All monies from time to time credited to and for the time being standing to the credit of the charged account together with all interest accrued and all other assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 13 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Account charge deed
    Creato il 04 dic 1997
    Consegnato il 13 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from cnc properties PLC to the chargee under a loan agreement dated 4TH december 1997 and all monies due from the cnc properties PLC and the second chargors being:- the valley centre limited, cnc estates limited, beacontree estates limited and shelfco (no 1381) limited under the security documents and any of them and all monies due from cnc properties PLC and the second chargors under the account charge deed
    Brevi particolari
    All monies from time to time credited to and for the time being standing to the credit of the charged account together with all interest accrued and all other assets of the company and the second chargors. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 13 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of securities
    Creato il 26 giu 1997
    Consegnato il 03 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any stocks shares or bonds warrants or other securities from time to time (1) named in any schedule supplied by or on behalf of the company to the bank by reference to the charge of securities in cluding all and any of the shares or securities in the capital of regis & regis limited beneficially held by the company or (2) in respect of which title or the relative account entries is/are held in the name of the bank or its nominee or (3) in respect of which the relative certificates or othere title documents are deposited with or held to the order of the bank or its nominee. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of securities
    Creato il 04 apr 1997
    Consegnato il 16 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All stocks shares bonds and other securities including all or any of the shares or securities in the capital of the milburn estates limited. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of cash deposit
    Creato il 04 apr 1997
    Consegnato il 16 apr 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit of £2,295,000 credited to the account number designation 20875839 and any addition to that deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of subordination
    Creato il 30 ott 1995
    Consegnato il 15 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All present and future liabilities of beacontree estates limited (the borrower) to the company pursuant to an agreement dated 30 october 1995. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 15 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 30 ott 1995
    Consegnato il 10 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the agreement dated 24TH october 1995
    Brevi particolari
    All rights title & interest in & to all present & future debts pursuant to the agreement dated 30/10/95 in respect of the provision of the loan facility of up to £5,300,000. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 10 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge and set-off over cash
    Creato il 30 ott 1995
    Consegnato il 10 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the agreement dated 24TH october 1995
    Brevi particolari
    Rights title & interest in & to all monies from time to time standing to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 10 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of charge
    Creato il 28 set 1994
    Consegnato il 10 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all stocks shares and other securities for which the certificates and other documents have been or are about to be deposited by the depositor with the bank or its nominees; for which the certificates and other documents are now held by the bank or its nominees for the account of the depositor; and represented by any certificates or other documents from time to time hereafter deposited by the depositor with the bank or its nominees belonging to the depositor and received by the bank or its nominees after the execution hereof. By way of first fixed charge all dividends and all rights and benefits in respect of any of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Bank Limited
    Transazioni
    • 10 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 20 set 1994
    Consegnato il 10 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage over properties k/a 91-96 st martins lane 26-37 st martins court,1-25 and 27 cecil court,burleigh mansions,charing cross mansions and corridors at 20 and 26 charing cross road london WC2 and by way of assignment all rental income and by way of specific charge all deeds and documents relating to the property and all moveable plant machinery implements utensils building materials furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hambros Bank Limited
    Transazioni
    • 10 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment by way of contract
    Creato il 20 set 1994
    Consegnato il 10 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents (as defined) and/or in connection with the loan facility or other financial accommodation under the terms of the assignment
    Brevi particolari
    All rights title and interest in and to an interest rate cap agreement starting 6TH october 1994 allc monetary debts and claims. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hambros Bank Limited
    Transazioni
    • 10 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 dic 1993
    Consegnato il 05 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    80 and 80A fenchurch street london EC3. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse
    Transazioni
    • 05 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 dic 1993
    Consegnato il 05 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h property situate in the london borough of city of westminster and k/a cecil court charing cross road london WC2. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse
    Transazioni
    • 05 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over deposit
    Creato il 17 ago 1988
    Consegnato il 18 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest present and future to and in and arising out of or in respect of all monies from time to time 'held in' the deignated account held at the bank in the name of the company.
    Persone aventi diritto
    • First Interstate Bank of California
    Transazioni
    • 18 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 24 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memo of deposit
    Creato il 13 gen 1972
    Consegnato il 24 gen 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Premises in carpenter road bow and premises in waterden rd, hackney.
    Persone aventi diritto
    • Guiness Mahon & Co LTD
    Transazioni
    • 24 gen 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    NCNA PROPERTIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 mar 2013Inizio della liquidazione
    20 ott 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Julie Ann Swan
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Praticante
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Mark Richard Phillips
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Praticante
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0