MARSTON'S ACQUISITIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MARSTON'S ACQUISITIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00024795 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MARSTON'S ACQUISITIONS LIMITED?
- Produzione di birra (11050) / Industrie manifatturiere
- Commercio all'ingrosso di vino, birra, liquori e altre bevande alcoliche (46342) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
- Commercio al dettaglio di bevande in negozi specializzati (47250) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova MARSTON'S ACQUISITIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | St Johns House St Johns Square WV2 4BH Wolverhampton United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MARSTON'S ACQUISITIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| JENNINGS BROTHERS LIMITED | 20 ott 2005 | 20 ott 2005 |
| JENNINGS BROTHERS PUBLIC LIMITED COMPANY | 20 lug 1887 | 20 lug 1887 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MARSTON'S ACQUISITIONS LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 01 ott 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 01 lug 2027 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 27 set 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per MARSTON'S ACQUISITIONS LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 27 giu 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 11 lug 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 27 giu 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per MARSTON'S ACQUISITIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilancio redatto al 27 set 2025 | pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Stephen Robert Hopson come amministratore in data 01 dic 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Hayleigh Lupino come amministratore in data 27 set 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 08 set 2025
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale al 09 set 2025
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 28 set 2024 | 18 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 000247950302, creata il 13 mag 2024 | 8 pagine | MR01 | ||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 000247950303, creata il 13 mag 2024 | 8 pagine | MR01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 83 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 247 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 299 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 300 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 301 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 105 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2023 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Justin Mark Platt come amministratore in data 12 gen 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Andonis Andrea come amministratore in data 17 nov 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 01 ott 2022 | 22 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di MARSTON'S ACQUISITIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAYBOULD, Bethan | Segretario | St Johns Square WV2 4BH Wolverhampton St Johns House United Kingdom | 288159270001 | |||||||
| HANCOCK, Edward John | Amministratore | St Johns Square WV2 4BH Wolverhampton St Johns House United Kingdom | United Kingdom | British | 288133210002 | |||||
| HOPSON, Stephen Robert | Amministratore | St Johns Square WV2 4BH Wolverhampton St Johns House United Kingdom | United Kingdom | British | 293724950001 | |||||
| LEACH, Robert Anthony | Amministratore | St Johns Square WV2 4BH Wolverhampton St Johns House United Kingdom | United Kingdom | British | 194085550001 | |||||
| PLATT, Justin Mark | Amministratore | St Johns Square WV2 4BH Wolverhampton St Johns House United Kingdom | United Kingdom | British | 318284520001 | |||||
| BRENNAN, Anne Marie | Segretario | Marston's House WV1 4JT Wolverhampton West Midlands | British | 109935620001 | ||||||
| COPSON, Richard Charles | Segretario | Dyke Nook Bassenthwaite CA12 4QG Keswick Cumbria | British | 6030770001 | ||||||
| COULSON, William Andrew | Segretario | 40 Holly Avenue Jesmond NE2 2PY Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 36723860001 | ||||||
| FADIL, Susan Carol | Segretario nominato | Shemer Ash Road Hawley DA2 7SB Dartford Kent | British | 900006600001 | ||||||
| HODGSON, Mark Ian | Segretario | Breeze Hill Portinscale CA12 5RW Keswick Cumbria | British | 70939880001 | ||||||
| SWANSTON, Andrew John | Segretario | 12 Croft Road CA3 9AQ Carlisle Cumbria | British | 145364760001 | ||||||
| ANDREA, Andrew Andonis | Amministratore | St Johns Square WV2 4BH Wolverhampton St Johns House United Kingdom | England | British | 137383120011 | |||||
| ANDREW, Derek | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | British | 39071260003 | ||||||
| ATKINSON, Keith Andrew | Amministratore | 20 The Firs Salter Road NE3 4PH Newcastle Upon Tyne | British | 36184740001 | ||||||
| BARTON, Robin Brendan | Amministratore | Chestnut House 14 The Rydings, Langho BB6 8BQ Blackburn Lancashire | British | 71463790001 | ||||||
| BUSHBY, Thomas Albert | Amministratore | Knockrobin Rookery Way RH16 4RE Haywards Heath Sussex | British | 2203230001 | ||||||
| CATTO, Ralph Fergus | Amministratore | 19 Queens Road GL50 2LR Cheltenham Gloucestershire | England | British | 87065920001 | |||||
| CLAYTON, Michael Derek | Amministratore | Great Kettle Barn Great Asby CA16 6EX Appleby In Westmorland Cumbria | England | British | 68299460001 | |||||
| COPSON, Richard Charles | Amministratore | Dyke Nook Bassenthwaite CA12 4QG Keswick Cumbria | British | 6030770001 | ||||||
| COULSON, William Andrew | Amministratore | 40 Holly Avenue Jesmond NE2 2PY Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 36723860001 | |||||
| DARBY, Alistair William | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | British | 87846880002 | ||||||
| FINDLAY, Ralph Graham | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marstons House West Midlands | England | British | 129897400001 | |||||
| GALLAGHER, Desmond | Amministratore | Bundoran 6 Rook Farm Tallentire CA13 0PH Cockermouth Cumbria | British | 89258540002 | ||||||
| GREEN, Trevor Irwin | Amministratore | Orchard House Applethwaite CA12 4PN Keswick Cumbria | British | 60757230001 | ||||||
| HOUGHTON, John | Amministratore | 8 Rubbybanks Road CA13 9RG Cockermouth Cumbria | British | 73576380002 | ||||||
| INGLETT, Paul | Amministratore | Marston's House WV1 4JT Wolverhampton West Midlands | British | 81617110002 | ||||||
| JACKSON, Iain Kenneth | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | United Kingdom | British | 152090970001 | |||||
| JACKSON, Iain Kenneth | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | United Kingdom | British | 153542130002 | |||||
| LANGFORD, Jonathan Robert | Amministratore | Stoneleigh Court Hyde Lea ST18 9QJ Stafford 1 West Midlands | United Kingdom | British | 135408140001 | |||||
| LEE, Philip George | Amministratore | 2 Deer Orchard Close CA13 9JH Cockermouth Cumbria | British | 6082550001 | ||||||
| LUPINO, Hayleigh | Amministratore | St Johns Square WV2 4BH Wolverhampton St Johns House United Kingdom | United Kingdom | British | 207826950002 | |||||
| MARSHALL, Donald | Amministratore | Childwall House Park Lane CW5 7QX Hatherton Cheshire | British | 42797700003 | ||||||
| OLIVER, Stephen John | Amministratore | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | British | 66123690003 | ||||||
| RUDGARD, John Kennish | Amministratore | Low Mill Eamont Bridge CA10 2BE Penrith Cumbria | British | 17349320002 | ||||||
| SANDS, John Robert | Amministratore | 6 Wellington Drive Wynyard TS22 5QJ Billingham Cleveland | United Kingdom | British | 97975820002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MARSTON'S ACQUISITIONS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marston's Corporate Holdings Limited | 03 ago 2018 | St Johns Square WV2 4BH Wolverhampton St Johns House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Marston's Plc | 06 apr 2016 | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0