TEMPORE 12B LIMITED

TEMPORE 12B LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTEMPORE 12B LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00027884
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TEMPORE 12B LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TEMPORE 12B LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8 Springfield Close
    Ovington
    NE42 6WZ Prudhoe
    Northumberland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TEMPORE 12B LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    W.E.BAXTER LIMITED18 dic 188818 dic 1888

    Quali sono gli ultimi bilanci di TEMPORE 12B LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TEMPORE 12B LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TEMPORE 12B LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Cox & Wyman House Cardiff Road Reading RG1 8EX* in data 13 mar 2014

    1 pagineAD01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 07 mar 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 20 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Francois Golicheff come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    17 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed W.E.baxter LIMITED\certificate issued on 29/06/12
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name29 giu 2012

    Risoluzione di cambio di nome della società il 29 giu 2012

    RES15
    change-of-name29 giu 2012

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Bilancio annuale redatto al 20 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    17 pagineAA

    Nomina di Mr Matthew William Robson come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Williams come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    17 pagineAA

    Nomina di Mr Michael Owen Williams come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Derek Harris come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Derek Harris come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Michael Austin come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Pierre Catte come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di TEMPORE 12B LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROBSON, Matthew William
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    Segretario
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    British93423100001
    ROBSON, Matthew William
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Reivers
    Northumberland
    England
    Amministratore
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Reivers
    Northumberland
    England
    EnglandBritish93423100001
    CASSELDEN, Jack
    6 Warleigh Road
    BN1 4NT Brighton
    East Sussex
    Segretario
    6 Warleigh Road
    BN1 4NT Brighton
    East Sussex
    British3098650001
    HARRIS, Derek John
    35 Furze Lane
    CR8 3EJ Purley
    Surrey
    Segretario
    35 Furze Lane
    CR8 3EJ Purley
    Surrey
    British14483180001
    POWNEY, Stephen Graham
    49 Prince Edward Road
    CM11 2HB Billericay
    Essex
    Segretario
    49 Prince Edward Road
    CM11 2HB Billericay
    Essex
    British6517760004
    ROYLE, Sandie
    47 Westbourne Villas
    BN3 4GG Hove
    East Sussex
    Segretario
    47 Westbourne Villas
    BN3 4GG Hove
    East Sussex
    British39654450001
    ARNOLD, Russell Edward
    34 Charlwood Road
    RH15 0RJ Burgess Hill
    West Sussex
    Amministratore
    34 Charlwood Road
    RH15 0RJ Burgess Hill
    West Sussex
    British42828950002
    AUSTIN, Michael Anthony
    5 Old Oak Avenue
    CR5 3PG Chipstead
    Surrey
    Amministratore
    5 Old Oak Avenue
    CR5 3PG Chipstead
    Surrey
    EnglandBritish46324150001
    BAKER, Simon Achilles
    Honeypot Cottage
    RH17 6PE Balcombe
    Sussex
    Amministratore
    Honeypot Cottage
    RH17 6PE Balcombe
    Sussex
    British43071930002
    BENNETT, Stewart
    9 Monckton Way
    Kingston
    BN7 3LD Lewes
    East Sussex
    Amministratore
    9 Monckton Way
    Kingston
    BN7 3LD Lewes
    East Sussex
    British42827930002
    BOVARD, Timothy Landon
    7 Boulevard Anatole France
    FOREIGN Boulogne
    92100
    France
    Amministratore
    7 Boulevard Anatole France
    FOREIGN Boulogne
    92100
    France
    British101457350001
    CASSELDEN, Jack
    6 Warleigh Road
    BN1 4NT Brighton
    East Sussex
    Amministratore
    6 Warleigh Road
    BN1 4NT Brighton
    East Sussex
    British3098650001
    CATTE, Pierre Francois
    Bis Rue De La Tour
    75016 Paris
    62
    France
    Amministratore
    Bis Rue De La Tour
    75016 Paris
    62
    France
    FranceFrench165234830001
    COOK, David Ross
    High Banks
    Keymer Road
    RH15 0AH Burgess Hill
    West Sussex
    Amministratore
    High Banks
    Keymer Road
    RH15 0AH Burgess Hill
    West Sussex
    British3098660001
    COTTRELL, Peter David
    43 Oaklands
    Westham
    BN24 5AW Pevensey
    East Sussex
    Amministratore
    43 Oaklands
    Westham
    BN24 5AW Pevensey
    East Sussex
    British3098670001
    GOLICHEFF, Francois Jacques Pierre
    Cardiff Road
    RG1 8EX Reading
    Cox & Wyman House
    Berkshire
    Amministratore
    Cardiff Road
    RG1 8EX Reading
    Cox & Wyman House
    Berkshire
    FranceFrench146651780001
    GUILLIER TUAL, Natalie
    43 Bis Rue Henri Cloppet
    Le Vesinet
    78100
    France
    Amministratore
    43 Bis Rue Henri Cloppet
    Le Vesinet
    78100
    France
    French103508190001
    HARRIS, Derek John
    35 Furze Lane
    CR8 3EJ Purley
    Surrey
    Amministratore
    35 Furze Lane
    CR8 3EJ Purley
    Surrey
    United KingdomBritish14483180001
    ROBSON, Matthew William
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    Amministratore
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    EnglandBritish93423100001
    RODDY, John Keith
    Toftbury
    Ridgway Pyrford
    GU22 8PN Woking
    Surrey
    Amministratore
    Toftbury
    Ridgway Pyrford
    GU22 8PN Woking
    Surrey
    British108846290001
    ROYLE, David Ronald
    Chelwood Farmhouse
    Chelwood Farm
    TN22 3HH Nutley Uckfield East
    Sussex
    Amministratore
    Chelwood Farmhouse
    Chelwood Farm
    TN22 3HH Nutley Uckfield East
    Sussex
    British2540240001
    ROYLE, Peter Richard
    Tutts Farm
    South Chailey
    BN8 4RS Lewes
    East Sussex
    Amministratore
    Tutts Farm
    South Chailey
    BN8 4RS Lewes
    East Sussex
    British2470810001
    SIMMONS, Barry Dennis
    97 Green Ridge
    West Dene
    BN1 5LU Brighton
    East Sussex
    Amministratore
    97 Green Ridge
    West Dene
    BN1 5LU Brighton
    East Sussex
    British42828900001
    TAYLOR, Michael Edward
    Forest Hall Springwood Park
    TN11 9LZ Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Forest Hall Springwood Park
    TN11 9LZ Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish10315310003
    WICKHAM, Ralph William George
    11 Delaware Road
    BN7 1LD Lewes
    East Sussex
    Amministratore
    11 Delaware Road
    BN7 1LD Lewes
    East Sussex
    British3098690001
    WILLIAMS, Michael Owen
    Fisher Green
    Binfield
    RG42 4EQ Bracknell
    1
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Fisher Green
    Binfield
    RG42 4EQ Bracknell
    1
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish198947630001

    TEMPORE 12B LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 29 mag 1996
    Consegnato il 31 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement for the purchase of debts dated 28TH may 1996 or otherwise
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge (I) all debts or other obligations to the company of agreed customers under contracts of sale ("debts"), the subject of an agreement for the purchase of debts between the company and the security holder, which fail to vest absolutely in the security holder and remain vested in the company, (see ch microfiche for full details).
    Persone aventi diritto
    • Griffin Factors Limited
    Transazioni
    • 31 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 21 nov 1995
    Consegnato il 25 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Heidelberg 72SP (6 colour) serial no 526605, 72 vp (4 colour) serial no 523333, mozp-h (2 colour mo) serial no 607866, 72 zp (2 colour) serial no 530307.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 29 apr 1993
    Consegnato il 12 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Heidelberg mox p-h 2 colour press serial no: 607866.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 29 apr 1993
    Consegnato il 12 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Heidelberg speedmaster 72VP4 colour press serial no: 523333.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 29 apr 1993
    Consegnato il 12 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Heidelberg speedmaster 72SP colour press serial no: 526605.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 apr 1993
    Consegnato il 06 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 35 high street lewes east sussex. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 apr 1993
    Consegnato il 06 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 34 high street lewes east sussex. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 20 gen 1987
    Consegnato il 22 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the chattels plant machinery & terms described in the schedule hereto one new muller martin model 1509 minuteman saddle stitching line serial nos:- 1509, KA99, 13917 1528 ka 9913180 225 ka 9913561.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 22 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 18 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 31 ott 1983
    Consegnato il 04 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts & other debts due, owing or incurred to the company present & future.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 11 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 20 ago 1979
    Consegnato il 04 set 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over (see doc M124 for details).. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 29 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0