J.A. DEVENISH LIMITED
Panoramica
| Nome della società | J.A. DEVENISH LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00030065 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di J.A. DEVENISH LIMITED?
- Pub e bar (56302) / Attività di alloggio e di ristorazione
Dove si trova J.A. DEVENISH LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 33 Cavendish Square W1G 0PW London London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di J.A. DEVENISH LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per J.A. DEVENISH LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per J.A. DEVENISH LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Hill House 1 Little New Street London London EC4A 3TR | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Sunita Kaushal come segretario in data 29 lug 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 feb 2014 | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 33 Cavendish Square London London W1B 0PW England* in data 27 ago 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Caldecott come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 17 Portland Place London London W1B 1PU England* in data 01 lug 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Colin Elliot come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 feb 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Gareth Caldecott il 18 dic 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Gareth Caldecott il 05 nov 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 17 Portland Place London London W1B 1PU England* in data 05 set 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 feb 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Maxwell Coppel il 05 dic 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Sunita Kaushal il 05 dic 2011 | 2 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 1 West Garden Place Kendal Street London W2 2AQ England* in data 05 dic 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di J.A. DEVENISH LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPEL, Andrew Maxwell | Amministratore | Portland Place W1B 1PU London 17 London United Kingdom | England | British | 163106000001 | |||||
| ELLIOT, Colin David | Amministratore | Portland Place W1B 1PU London 17 London England | United Kingdom | British | 178756480001 | |||||
| DAWES, Peter Graham | Segretario | Queen's Acre 4 Spencer Road Canford Cliffs BH13 7EU Poole Dorset | British | 105703820001 | ||||||
| EDWARDS, David Charles | Segretario | Greenbanks Close Milford On Sea SO41 0SQ Lymington 7 Hampshire | British | 123440090026 | ||||||
| FARQUHARSON, John Alan | Segretario | Oak Lodge Windmill Lane Appleton WA4 5JN Warrington Cheshire | British | 15541980001 | ||||||
| KAUSHAL, Sunita | Segretario | Portland Place W1B 1PU London 17 London England | 158956440001 | |||||||
| FILEX SERVICES LIMITED | Segretario | 179 Great Portland Street W1W 5LS London | 3620420001 | |||||||
| ASHDOWN, Paul Edwin | Amministratore | 85 High Street Wick BS15 5QQ Bristol Avon | British | 25006750002 | ||||||
| BALFOUR-LYNN, Richard Gary | Amministratore | Connaught Square W2 2HG London 6 | United Kingdom | British | 34251500001 | |||||
| BIBRING, Michael Albert | Amministratore | Conifers Hive Road WD23 1JG Bushey Heath Hertfordshire | England | British | 9320160002 | |||||
| BLACE, William Graham | Amministratore | Little Sefton Eridge Road TN6 2SY Crowborough East Sussex | British | 34120620001 | ||||||
| BRIGHT, John William | Amministratore | Lower Mill Cuddington Lane Cuddington CW8 2SQ Northwich Cheshire | British | 76489540001 | ||||||
| BUTTON, Anthony Horace | Amministratore | 3 Orchard Rise TW10 5BX Richmond Surrey | British | 5208590001 | ||||||
| CALDECOTT, David Gareth | Amministratore | Portland Place W1B 1PU London 17 London England | United Kingdom | British | 73603940003 | |||||
| CANNON, Michael Robin | Amministratore | 16 Courtfield Road South Kensington SW7 4DA London | British | 36545510001 | ||||||
| CANNON, Sally Ann Tiverton | Amministratore | 16 Courtfield Road South Kensington SW7 4DA London | British | 25054170001 | ||||||
| CAVE, Ian Bruce | Amministratore | 392 Woodstock Road OX2 8AF Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 102741680001 | |||||
| CLARK, John Webb | Amministratore | Orchard Priors Battledown Close GL52 6RD Cheltenham Gloucestershire | British | 5691050001 | ||||||
| DARESBURY, Peter Gilbert, Lord | Amministratore | Hall Lane Farm Daresbury WA4 4AF Warrington | England | British | 5404190003 | |||||
| DILLON, Nicholas Brian | Amministratore | The Mill House Mill Lane Hasketon IP13 6HQ Woodbridge Suffolk | England | British | 58418700001 | |||||
| EDWARDS, David Charles | Amministratore | Greenbanks Close Milford On Sea SO41 0SQ Lymington 7 Hampshire | United Kingdom | British | 123440090026 | |||||
| FARQUHARSON, John Alan | Amministratore | Oak Lodge Windmill Lane Appleton WA4 5JN Warrington Cheshire | England | British | 15541980001 | |||||
| FEARN, Matthew Robin Cyprian | Amministratore | Brook House Brook Road CW6 9HH Tarporley Cheshire | United Kingdom | British | 109155280002 | |||||
| HARDY, David William, Sir | Amministratore | 17 Cranmer Court Whiteheads Grove SW3 3HN London | England | British | 603570001 | |||||
| KOWALSKI, Timothy John | Amministratore | Dunaway 29 Alton Road SK9 5DY Wilmslow Cheshire | British | 64229200002 | ||||||
| LONGDEN, John David | Amministratore | Vicarage House Nidd HG3 3BN Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 40890250001 | |||||
| MARTLAND, David James | Amministratore | 73 Hall Lane Aspull WN2 2SF Wigan Greater Manchester | British | 35477380001 | ||||||
| SINGH, Jagtar | Amministratore | West Garden Place W2 2AQ London 1 England | United Kingdom | British | 121710890001 | |||||
| SNOOK, David Philip | Amministratore | Old Dairy House Puddledock Cottage Puddledock Lane Sutton Poyntz DT3 6LZ Weymouth Dorset | British | 48538780001 | ||||||
| STOREY, Martin John | Amministratore | Ysgubor Newydd Nannerch CH7 5RD Mold Clwyd | British | 35968160001 | ||||||
| STUBBS, Roger Gordon | Amministratore | Beech House 36 Parkgate Road, Neston CF64 6QG South Wirral Merseyside | United Kingdom | British | 4795660002 | |||||
| THOMAS, Andrew Gerald | Amministratore | Greenlands Forest Road, Little Budworth CW6 9ES Tarporley Cheshire | British | 2024880001 | ||||||
| YOUNG, Roger Allen | Amministratore | Hempgill Carriage Drive WA6 6DR Frodsham Cheshire | British | 35968110001 |
J.A. DEVENISH LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental trust deed | Creato il 11 set 1995 Consegnato il 26 set 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The guarantee by the company to the trustee of the payment by the greenalls group PLC of all sums on account of the principal of or interest on the £30,000,000 10 1/2 per cent. (Formerly 10 1/4 per cent.) Debenture stock 2017 and all other monies due to the chargee under the trust deed and the supplemental trust deed (as defined in this deed) | |
Brevi particolari Floating charge over the undertaking and all property and assets including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Second supplemental trust deed | Creato il 11 set 1995 Consegnato il 21 set 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Any sum on account of the principal and interest on the £99,650,450 11 1/2 per cent. Debenture stock 2014 from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the trust deed dated 5TH june 1991 and supplemented trust deed dated 5TH july 1991 or of any other moneys intended to be secured by these presents | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 03 ago 1992 Consegnato il 06 ago 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 1 june 1992 | |
Brevi particolari The dick turpin public house southend arterial road north benfleet essex. T/n-EX205134 the cocked hat public house privett road alverstoke gosport hampshire. The priory chiltern road dunstable. T/n-BD41114. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 23 giu 1992 Consegnato il 01 lug 1992 Data dello strumento di garanzia 23 giu 1992 | Soddisfatta integralmente | ||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Memo of deposit | Creato il 31 mar 1922 Consegnato il 20 apr 1922 | In corso | Importo garantito All moneys etc | |
Brevi particolari Chequers inn, dorchester, dorset 3 king alfred's place, swanage dorset. Royal oak inn kinston dorset. 3 cottages in ditto. Royal victoria lodge hotel portland dorset. Victoria inn chiswick dorset 2 cottages in ditto. Royal oak dorchester rd, weymouth dorset. Kings head, weymouth. 1A grosvenor place weymouth. 9 & 10 maiden st weymouth. 14 core st, weymouth. 5 st leonards rd weymouth. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0