J.A. DEVENISH LIMITED

J.A. DEVENISH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJ.A. DEVENISH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00030065
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di J.A. DEVENISH LIMITED?

    • Pub e bar (56302) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova J.A. DEVENISH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    33 Cavendish Square
    W1G 0PW London
    London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di J.A. DEVENISH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per J.A. DEVENISH LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per J.A. DEVENISH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 27 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 feb 2015

    Stato del capitale al 27 feb 2015

    • Capitale: GBP 487,919
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Hill House 1 Little New Street London London EC4A 3TR

    2 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    15 pagineAA

    Cessazione della carica di Sunita Kaushal come segretario in data 29 lug 2014

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 27 feb 2014

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mar 2014

    Stato del capitale al 03 mar 2014

    • Capitale: GBP 487,919
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    11 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 33 Cavendish Square London London W1B 0PW England* in data 27 ago 2013

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di David Caldecott come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 17 Portland Place London London W1B 1PU England* in data 01 lug 2013

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Colin Elliot come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 27 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Gareth Caldecott il 18 dic 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gareth Caldecott il 05 nov 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    13 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 17 Portland Place London London W1B 1PU England* in data 05 set 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 27 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Maxwell Coppel il 05 dic 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sunita Kaushal il 05 dic 2011

    2 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da * 1 West Garden Place Kendal Street London W2 2AQ England* in data 05 dic 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di J.A. DEVENISH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COPPEL, Andrew Maxwell
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish163106000001
    ELLIOT, Colin David
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    Amministratore
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    United KingdomBritish178756480001
    DAWES, Peter Graham
    Queen's Acre
    4 Spencer Road Canford Cliffs
    BH13 7EU Poole
    Dorset
    Segretario
    Queen's Acre
    4 Spencer Road Canford Cliffs
    BH13 7EU Poole
    Dorset
    British105703820001
    EDWARDS, David Charles
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    Segretario
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    British123440090026
    FARQUHARSON, John Alan
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    Segretario
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    British15541980001
    KAUSHAL, Sunita
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    Segretario
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    158956440001
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Segretario
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    ASHDOWN, Paul Edwin
    85 High Street
    Wick
    BS15 5QQ Bristol
    Avon
    Amministratore
    85 High Street
    Wick
    BS15 5QQ Bristol
    Avon
    British25006750002
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Amministratore
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    BLACE, William Graham
    Little Sefton
    Eridge Road
    TN6 2SY Crowborough
    East Sussex
    Amministratore
    Little Sefton
    Eridge Road
    TN6 2SY Crowborough
    East Sussex
    British34120620001
    BRIGHT, John William
    Lower Mill
    Cuddington Lane Cuddington
    CW8 2SQ Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    Lower Mill
    Cuddington Lane Cuddington
    CW8 2SQ Northwich
    Cheshire
    British76489540001
    BUTTON, Anthony Horace
    3 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    Amministratore
    3 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    British5208590001
    CALDECOTT, David Gareth
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    Amministratore
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    United KingdomBritish73603940003
    CANNON, Michael Robin
    16 Courtfield Road
    South Kensington
    SW7 4DA London
    Amministratore
    16 Courtfield Road
    South Kensington
    SW7 4DA London
    British36545510001
    CANNON, Sally Ann Tiverton
    16 Courtfield Road
    South Kensington
    SW7 4DA London
    Amministratore
    16 Courtfield Road
    South Kensington
    SW7 4DA London
    British25054170001
    CAVE, Ian Bruce
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish102741680001
    CLARK, John Webb
    Orchard Priors
    Battledown Close
    GL52 6RD Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Orchard Priors
    Battledown Close
    GL52 6RD Cheltenham
    Gloucestershire
    British5691050001
    DARESBURY, Peter Gilbert, Lord
    Hall Lane Farm
    Daresbury
    WA4 4AF Warrington
    Amministratore
    Hall Lane Farm
    Daresbury
    WA4 4AF Warrington
    EnglandBritish5404190003
    DILLON, Nicholas Brian
    The Mill House Mill Lane
    Hasketon
    IP13 6HQ Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    The Mill House Mill Lane
    Hasketon
    IP13 6HQ Woodbridge
    Suffolk
    EnglandBritish58418700001
    EDWARDS, David Charles
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    Amministratore
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    United KingdomBritish123440090026
    FARQUHARSON, John Alan
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish15541980001
    FEARN, Matthew Robin Cyprian
    Brook House
    Brook Road
    CW6 9HH Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Brook House
    Brook Road
    CW6 9HH Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish109155280002
    HARDY, David William, Sir
    17 Cranmer Court
    Whiteheads Grove
    SW3 3HN London
    Amministratore
    17 Cranmer Court
    Whiteheads Grove
    SW3 3HN London
    EnglandBritish603570001
    KOWALSKI, Timothy John
    Dunaway 29 Alton Road
    SK9 5DY Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Dunaway 29 Alton Road
    SK9 5DY Wilmslow
    Cheshire
    British64229200002
    LONGDEN, John David
    Vicarage House
    Nidd
    HG3 3BN Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Vicarage House
    Nidd
    HG3 3BN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish40890250001
    MARTLAND, David James
    73 Hall Lane
    Aspull
    WN2 2SF Wigan
    Greater Manchester
    Amministratore
    73 Hall Lane
    Aspull
    WN2 2SF Wigan
    Greater Manchester
    British35477380001
    SINGH, Jagtar
    West Garden Place
    W2 2AQ London
    1
    England
    Amministratore
    West Garden Place
    W2 2AQ London
    1
    England
    United KingdomBritish121710890001
    SNOOK, David Philip
    Old Dairy House Puddledock Cottage
    Puddledock Lane Sutton Poyntz
    DT3 6LZ Weymouth
    Dorset
    Amministratore
    Old Dairy House Puddledock Cottage
    Puddledock Lane Sutton Poyntz
    DT3 6LZ Weymouth
    Dorset
    British48538780001
    STOREY, Martin John
    Ysgubor Newydd
    Nannerch
    CH7 5RD Mold
    Clwyd
    Amministratore
    Ysgubor Newydd
    Nannerch
    CH7 5RD Mold
    Clwyd
    British35968160001
    STUBBS, Roger Gordon
    Beech House
    36 Parkgate Road, Neston
    CF64 6QG South Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    Beech House
    36 Parkgate Road, Neston
    CF64 6QG South Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish4795660002
    THOMAS, Andrew Gerald
    Greenlands
    Forest Road, Little Budworth
    CW6 9ES Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Greenlands
    Forest Road, Little Budworth
    CW6 9ES Tarporley
    Cheshire
    British2024880001
    YOUNG, Roger Allen
    Hempgill
    Carriage Drive
    WA6 6DR Frodsham
    Cheshire
    Amministratore
    Hempgill
    Carriage Drive
    WA6 6DR Frodsham
    Cheshire
    British35968110001

    J.A. DEVENISH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental trust deed
    Creato il 11 set 1995
    Consegnato il 26 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The guarantee by the company to the trustee of the payment by the greenalls group PLC of all sums on account of the principal of or interest on the £30,000,000 10 1/2 per cent. (Formerly 10 1/4 per cent.) Debenture stock 2017 and all other monies due to the chargee under the trust deed and the supplemental trust deed (as defined in this deed)
    Brevi particolari
    Floating charge over the undertaking and all property and assets including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.(The "Trustee")
    Transazioni
    • 26 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second supplemental trust deed
    Creato il 11 set 1995
    Consegnato il 21 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Any sum on account of the principal and interest on the £99,650,450 11 1/2 per cent. Debenture stock 2014 from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the trust deed dated 5TH june 1991 and supplemented trust deed dated 5TH july 1991 or of any other moneys intended to be secured by these presents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transazioni
    • 21 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 ago 1992
    Consegnato il 06 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 1 june 1992
    Brevi particolari
    The dick turpin public house southend arterial road north benfleet essex. T/n-EX205134 the cocked hat public house privett road alverstoke gosport hampshire. The priory chiltern road dunstable. T/n-BD41114.
    Persone aventi diritto
    • Chiswell Properties Limited
    Transazioni
    • 06 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 23 giu 1992
    Consegnato il 01 lug 1992
    Data dello strumento di garanzia 23 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 01 lug 1992Registrazione di un onere per garantire una serie di obbligazioni (397)
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memo of deposit
    Creato il 31 mar 1922
    Consegnato il 20 apr 1922
    In corso
    Importo garantito
    All moneys etc
    Brevi particolari
    Chequers inn, dorchester, dorset 3 king alfred's place, swanage dorset. Royal oak inn kinston dorset. 3 cottages in ditto. Royal victoria lodge hotel portland dorset. Victoria inn chiswick dorset 2 cottages in ditto. Royal oak dorchester rd, weymouth dorset. Kings head, weymouth. 1A grosvenor place weymouth. 9 & 10 maiden st weymouth. 14 core st, weymouth. 5 st leonards rd weymouth.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 apr 1922Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0