CEARNS & BROWN LIMITED

CEARNS & BROWN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCEARNS & BROWN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00042760
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CEARNS & BROWN LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CEARNS & BROWN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Enterprise House
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Kent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CEARNS & BROWN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per CEARNS & BROWN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 ott 2016 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2015 al 30 giu 2016

    1 pagineAA01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    1 pagineDS02

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 14 lug 2016

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 10 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 nov 2015

    Stato del capitale al 05 nov 2015

    • Capitale: GBP 447,216
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Adrian John Whitehead come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Sarah Leanne Whibley come amministratore in data 01 apr 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Sarah Leanne Whibley come segretario in data 01 apr 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Adrian John Whitehead come segretario in data 31 mar 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 10 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 nov 2014

    Stato del capitale al 11 nov 2014

    • Capitale: GBP 447,216
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 nov 2013

    Stato del capitale al 22 nov 2013

    • Capitale: GBP 447,216
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    22 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    22 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di CEARNS & BROWN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WHIBLEY, Sarah Leanne
    Enterprise House
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Kent
    Segretario
    Enterprise House
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Kent
    197289150001
    LODGE, David Robert
    Eureka Science Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    Amministratore
    Eureka Science Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    United KingdomBritish164083200001
    WHIBLEY, Sarah Leanne
    Enterprise House
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Kent
    Amministratore
    Enterprise House
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Kent
    EnglandBritish197579800001
    ANDREWS, Ian William
    308 Upton Lane
    WA8 9AG Widnes
    Cheshire
    Segretario
    308 Upton Lane
    WA8 9AG Widnes
    Cheshire
    British85146510001
    PURVIS, Martin Terence Alan
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    Segretario
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    British7901050001
    WHITEHEAD, Adrian John, Mr,
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    Segretario
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    British83031020003
    ANDREWS, Ian William
    308 Upton Lane
    WA8 9AG Widnes
    Cheshire
    Amministratore
    308 Upton Lane
    WA8 9AG Widnes
    Cheshire
    British85146510001
    BULLIVANT, Timothy Wild
    State House Dale Street
    L2 4TR Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    State House Dale Street
    L2 4TR Liverpool
    Merseyside
    British18702360002
    COOK, Bernard
    Ferndale Cottage Ascott Road
    Whichford
    CV36 5PE Shipston On Stour
    Warwickshire
    Amministratore
    Ferndale Cottage Ascott Road
    Whichford
    CV36 5PE Shipston On Stour
    Warwickshire
    EnglandBritish12836850003
    FEARN, Matthew Robin Cyprian
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    Amministratore
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    United KingdomBritish109155280002
    FORD, John Richard
    34 The Ridings
    CT5 3QE Chestfield
    Kent
    Amministratore
    34 The Ridings
    CT5 3QE Chestfield
    Kent
    British64091120001
    GARLICK, Helen
    6 Lambly Hill
    GU25 4BF Virginia Water
    Amministratore
    6 Lambly Hill
    GU25 4BF Virginia Water
    British88752280001
    GRAHAM, Martin
    Sherrington Bridge Lodge
    Sherrington
    MK16 9JA Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Sherrington Bridge Lodge
    Sherrington
    MK16 9JA Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    British112304040001
    GRINDLAY, Gary
    9 Lupin Drive
    Huntington
    CH3 6SD Chester
    Cheshire
    Amministratore
    9 Lupin Drive
    Huntington
    CH3 6SD Chester
    Cheshire
    British64956030001
    HARTE, Damian
    29 East Avenue
    Talbot Wood
    BH3 7BS Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    29 East Avenue
    Talbot Wood
    BH3 7BS Bournemouth
    Dorset
    Irish95779320001
    HUGHES, Leonard
    50 St Margarets Street
    ME1 1TU Rochester
    Kent
    Amministratore
    50 St Margarets Street
    ME1 1TU Rochester
    Kent
    British52234370002
    MCCRUDDEN, Colin William
    1 The Pinfold
    Tiddington
    CV37 Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    1 The Pinfold
    Tiddington
    CV37 Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British18702370001
    PINDER, John Richard
    Castle Holt
    Follifoot Lane, Spofforth
    HG3 1AR Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Castle Holt
    Follifoot Lane, Spofforth
    HG3 1AR Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish90188730001
    PLAYER, Michael Ian
    Whitelea
    Shootersway Lane
    HP4 3NP Berkamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Whitelea
    Shootersway Lane
    HP4 3NP Berkamsted
    Hertfordshire
    British11860001
    POWER, Ian Derek
    13 Turketel Road
    CT20 2PA Folkestone
    Kent
    Amministratore
    13 Turketel Road
    CT20 2PA Folkestone
    Kent
    United KingdomBritish107471150001
    ROBERTS, Idris Keith
    13 Fairways
    WA6 Frodsham
    Cheshire
    Amministratore
    13 Fairways
    WA6 Frodsham
    Cheshire
    British35614810001
    STODDART, Alastair Maxwell
    The Old Rectory
    High Street
    CW6 0AG Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    High Street
    CW6 0AG Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritish27183890002
    STODDART, Carol Louise
    Mill Hill
    Poulton Royde Drive Spital
    Wirral
    Amministratore
    Mill Hill
    Poulton Royde Drive Spital
    Wirral
    British18702340001
    STODDART, Elaine Sally
    The Old Rectory
    CW6 Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    CW6 Tarporley
    Cheshire
    British18702380001
    STODDART, Gordon Douglas
    Hatfield Rocky Lane
    Heswell
    L60 0BZ Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    Hatfield Rocky Lane
    Heswell
    L60 0BZ Wirral
    Merseyside
    British61033020001
    STODDART, Wilfrid Hamish
    New Street
    OX15 0SP Deddington
    The Leadenporch House
    Oxfordshire
    Amministratore
    New Street
    OX15 0SP Deddington
    The Leadenporch House
    Oxfordshire
    United KingdomBritish160151500002
    STODDART, Wilfrid Bowring
    Mill Hill
    Poulton Royd Drive
    L63 4LD Spital
    Wirral
    Amministratore
    Mill Hill
    Poulton Royd Drive
    L63 4LD Spital
    Wirral
    British15396980001
    TURNER, Eileen Mary
    Chorlton House
    Chorlton By Backford
    Chester
    Cheshire
    Amministratore
    Chorlton House
    Chorlton By Backford
    Chester
    Cheshire
    British18702320001
    VENABLES, Paul
    37 Ancastle Green
    RG9 1TS Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    37 Ancastle Green
    RG9 1TS Henley On Thames
    Oxfordshire
    British103911420001
    WHITEHEAD, Adrian John, Mr,
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    Amministratore
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    EnglandBritish83031020003
    WOOD, Rachel Eileen
    C/O Bullivant & Co
    State House 22 Dark Street
    Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    C/O Bullivant & Co
    State House 22 Dark Street
    Liverpool
    Merseyside
    British18702330001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CEARNS & BROWN LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Brake Bros Limited
    Nicholas Road, Eureka Science Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    England
    06 apr 2016
    Nicholas Road, Eureka Science Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneRegister Of Companies
    Numero di registrazione02035315
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CEARNS & BROWN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge
    Creato il 04 nov 1998
    Consegnato il 05 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Specific charge: all uncalled capital and present and future f/h and l/h property, all present and future book debts together with benefit of all contracts and engagements, floating charge all the goodwill and. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 05 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 25 nov 1993
    Consegnato il 15 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or cearns & brown (southern) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 28 gen 1982
    Consegnato il 15 feb 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 feb 1982Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 02 ott 1980
    Consegnato il 09 ott 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts and other debts now & from time to time hereafter due owing or incurred to the co.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ott 1980Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental legal charge
    Creato il 31 dic 1979
    Consegnato il 14 gen 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property at whitehouse industrial estate runcorn cheshire.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commerical Finance Corporation Limited.
    Transazioni
    • 14 gen 1980Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 06 set 1972
    Consegnato il 07 set 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £150,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Land situate on the whitehouse industrial estate runcorn, cheshire, 3.62 acres (approx) with buildings erected thereon, comprised in a lease dated 14.7.72.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transazioni
    • 07 set 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 22 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0