IND COOPE (LONDON) LIMITED
Panoramica
Nome della società | IND COOPE (LONDON) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00043104 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di IND COOPE (LONDON) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova IND COOPE (LONDON) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di IND COOPE (LONDON) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per IND COOPE (LONDON) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 94 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 30 mar 2021
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 86 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 2 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Forde come amministratore in data 31 lug 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 79 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Sean Michael Paterson come amministratore in data 24 apr 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David James Tannahill come amministratore in data 24 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 24 ago 2018 al 31 dic 2018 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di IND COOPE (LONDON) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOORE, Christopher John | Amministratore | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 136853310001 | ||||
MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge | Amministratore | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | England | British | Director | 112375050001 | ||||
PATERSON, Sean Michael | Amministratore | South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Broadway Park Scotland | Scotland | British | Finance Director | 257892140001 | ||||
APPLEBY, Francesca | Segretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 191627860001 | |||||||
BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Segretario | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
HARRIS, Claire Louise | Segretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 175488220001 | |||||||
RUDD, Susan Clare | Segretario | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
STEWART, Claire Susan | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | British | 117216940001 | ||||||
TYRRELL, Helen | Segretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 161624380001 | |||||||
BASHFORTH, Edward Michael | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 131551840002 | ||||
BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Amministratore | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | Secretary | 637110001 | |||||
CONSTANTINE, Peter Anthony | Amministratore | 83 South Rise CF14 0RG Cardiff South Glamorgan | Wales | British | Chartered Surveyor Estates Dir | 114160540001 | ||||
DANDO, Stephen Peter | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 152083750001 | ||||
DUTTON, Philip | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 141395280001 | ||||
FORDE, David | Amministratore | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | Irish | Director | 180590780001 | ||||
JONES, Bruce Abbott | Amministratore | 1 Hall Drive DE13 8TF Hanbury Staffordshire | British | Company Director | 29595900002 | |||||
KEMP, Deborah Jane | Amministratore | 6 Station Road Hampton In Arden B92 0BJ Solihull | United Kingdom | British | Director | 79388130005 | ||||
MCDONALD, Robert James | Amministratore | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | Director | 42019620001 | |||||
PRESTON, Neil David | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 63043630002 | ||||
TANNAHILL, David James | Amministratore | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | Scotland | British | Director | 237381690001 | ||||
WHITEHEAD, Gordon William George | Amministratore | Rosedale 24 Jacks Lane ST14 8LW Marchington Staffordshire | British | Accountant | 13507460001 | |||||
WILFORD, Nicholas James | Amministratore | The Virgate Church Street Swepstone Coalville LE6 7SA Leicester Leicestershire | British | Chartered Surveyor | 33328990001 | |||||
WILKINSON, Anthony Eric | Amministratore | Bupton Grange Longford Lane Longford DE6 3DT Ashbourne Derbyshire | British | Company Director | 4656080002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di IND COOPE (LONDON) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Uk Limited | 29 ago 2017 | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Punch Taverns (Rh) Limited | 06 apr 2016 | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley Court United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
IND COOPE (LONDON) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 08 ott 2014 Consegnato il 15 ott 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Third supplemental deed of charge | Creato il 03 nov 2003 Consegnato il 20 nov 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other punch taverns secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage all right, title, interest and benefit, present and future (if any), in, to and under: the f/h or l/h property comprising the further punch taverns mortgaged properties; and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures. By way of fixed security the whole right, title, interest and benefit in and to the whole of the scottish trust property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 22 apr 2002 Consegnato il 08 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other spirit secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title and interest in to and under the f/h or l/h property comprising in the spirit mortgaged properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge; and all estates or interests in such property and allbuildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery from time to time on such f/h or l/h property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 22 apr 2002 Consegnato il 08 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other pr secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of assignment all of the company's right, title, interest and benefit, present and future in, to and under the master amendment deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 28 giu 2000 Consegnato il 15 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company, or any other charging company and/or guarantor to the chargee whether for its own account or as trustee for the pr secured parties or any of the other pr secured parties under or in respect of the issuer/borrower facility agreement, the charge and/or any other transaction documents to which it is a party (all as defined therein) | |
Brevi particolari All right title and interest and benefit, in, to and under the f/h and l/h properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge, and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures, fiall right title interest and benefit, in, to and under the f/h xed plant and machinery a floating charge over the undertaking of all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security agreement | Creato il 05 ott 1999 Consegnato il 21 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the obligors (as defined) to any transaction party under each transaction document (as defined) except for any obligation which, if it were so included, would result in the security agreement contravening section 151 of the companies act 1985 | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage the property defined as abbots way south drive sothway plymouth devon, alsager arms 4 sandbach rd south alsager stoke-on-trent staffs, anchor high st little paxton st neots huntingdon cambs (for full list of all property charged see schedule to form 395) together with fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental trust deed | Creato il 13 set 1989 Consegnato il 18 set 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £200,000,000 93/4% debenture stock 2019 of allied-lyons PLC created under this deed and all other monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as secured by this deed and deed supplemental thereto. | |
Brevi particolari By way of collateral security a first floating charge over both present and future including any uncalled capital. Undertaking and all property and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Sixteenth supplemental trust deed | Creato il 16 feb 1989 Consegnato il 17 feb 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £150,000,000 9 3/4% debenture stock 2019 of allied-lyons PLC constituted by this deed and all other moneys intended to be secured by this deed and various deeds (as defined) to which it is supplemental | |
Brevi particolari Floating charge over present & future including uncalled capital. Undertaking and all property and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental trust deed | Creato il 23 nov 1983 Consegnato il 25 nov 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £75,000,000 11 3/4 % debenture stock of allied-lyons PLC | |
Brevi particolari Undertaking and all assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Equitable charge without instrument | Creato il 22 giu 1983 Consegnato il 13 lug 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £75,000,000 debenture stock of allied lyons PLC | |
Brevi particolari Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed | Creato il 15 mar 1978 Consegnato il 30 mar 1978 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,352,930 created under the terms of a trust deed dated 6/6/62 and deeds supplemental thereto. | |
Brevi particolari Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed | Creato il 04 apr 1972 Consegnato il 17 apr 1972 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £100,000 debenture stock of allied breweries limited | |
Brevi particolari Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed | Creato il 11 mar 1968 Consegnato il 25 mar 1968 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £12,000,000 debenture stock of allied breweries limited | |
Brevi particolari Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed | Creato il 25 ago 1965 Consegnato il 07 set 1965 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,000,000 debenture stock of allied breweries limited | |
Brevi particolari Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed | Creato il 16 giu 1965 Consegnato il 17 giu 1965 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £2,000,000 debenture stock of allied breweries limited | |
Brevi particolari Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed | Creato il 14 ago 1964 Consegnato il 18 ago 1964 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £10,000,000 debenture stock of allied breweries limited | |
Brevi particolari Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed | Creato il 14 ago 1964 Consegnato il 18 ago 1964 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £2,623,369 debenture stock of allied breweries limited | |
Brevi particolari Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed | Creato il 19 feb 1964 Consegnato il 21 feb 1964 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £10,342,599 debenture stock of allied breweries limited | |
Brevi particolari Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed | Creato il 18 gen 1963 Consegnato il 24 gen 1963 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Further securing debenture stock amounting to £5,000,000 of ind coope tetley ansell limited | |
Brevi particolari Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed | Creato il 29 ago 1962 Consegnato il 03 set 1962 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Further securing £840,035 debenture stock of ind coope tetley ansell limited | |
Brevi particolari Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed | Creato il 29 ago 1962 Consegnato il 03 set 1962 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Further securing £7,854,882 debenture stock of ind coope tetley ansell limited | |
Brevi particolari Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed | Creato il 06 giu 1962 Consegnato il 07 giu 1962 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Further securing £15,347,651 debenture stock of ind coope tetley ansell limited | |
Brevi particolari Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 12 nov 1954 Acquisito il 31 dic 1962 Consegnato il 01 gen 1963 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £4,800 | |
Brevi particolari "The railway tavern" sydenham, london & land with all the goodwill of the business, the benefit of the licenses held in connection therewith & full right to receive all compensation payable on account of the non renewal of the said licenses. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 08 ott 1949 Acquisito il 20 mag 1961 Consegnato il 25 mag 1961 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,500 | |
Brevi particolari Yatton, 4, anslow gardens wallington, surrey. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 16 ott 1944 Acquisito il 05 apr 1963 Consegnato il 08 apr 1963 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £5,500 | |
Brevi particolari "The glanfield hotel", situate at east grinstead sussex & land, fixtures & fittings about the premises, the goodwill of the business, the benefit of magistrates certificate & excise license & full right to uncover all compensation payable on account of the non renewal of any of the said licenses. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0