RAB 100 LIMITED
Panoramica
Nome della società | RAB 100 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00043117 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RAB 100 LIMITED?
- (2513) /
Dove si trova RAB 100 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Victoria Works Thrumpton Lane DN22 6HH Retford Nottinghamshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di RAB 100 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ICON WARNE LIMITED | 05 ott 2000 | 05 ott 2000 |
WILLIAM WARNE LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
WILLIAM WARNE AND COMPANY,LIMITED | 23 gen 1895 | 23 gen 1895 |
Quali sono gli ultimi bilanci di RAB 100 LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 30 set 2011 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 giu 2012 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2010 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per RAB 100 LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 01 giu 2017 |
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 15 giu 2017 |
Scaduto | Sì |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per RAB 100 LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per RAB 100 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessazione della carica di Shaun Raymond Finn come segretario in data 09 ott 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Denzil Pryce come amministratore in data 09 ott 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Shaun Raymond Finn come amministratore in data 09 ott 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Ripristino per ordine del tribunale | 3 pagine | AC92 | ||||||||||||||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed icon warne LIMITED\certificate issued on 23/02/12 | 2 pagine | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 07 feb 2012
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Denzil Pryce il 24 ago 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2010 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Denzil Pryce il 31 mag 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 287 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 190 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 353 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di RAB 100 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINN, Shaun Raymond | Segretario | 11 Nottingham Road Lowdham NG14 7AL Nottingham | British | Finance Director | 112482850001 | |||||
HARRIS, Mark Smeeth | Segretario | 21 Oakdene Sunningdale SL5 0BU Ascot Berkshire | British | Accountant | 104260670001 | |||||
RUFFLE, Anthony John Howard | Segretario | 8 Hurstwood Drive BR1 2JF Bromley Kent | British | 10489270001 | ||||||
SUNTER, Amanda Jane | Segretario | 664 Rayleigh Road Hutton CM13 1SJ Brentwood Essex | British | 44240520002 | ||||||
ASHFORD, Leslie Ernest Thomas | Amministratore | 27 Beckenham Road BR4 0QR West Wickham Kent | England | British | Chief Executive | 398670001 | ||||
ASHURST, Norman | Amministratore | 5 De Narde Road NR19 2HQ Dereham Norfolk | British | Director | 70931510001 | |||||
BARNES, Raymond | Amministratore | 27 Chestwood Close CM12 0PB Billericay Essex | British | Company Director | 10489290001 | |||||
CALLAN, Maurice Simon | Amministratore | Ayres Cottage 71 Bicester Road Long Crendon HP18 9EE Aylesbury Buckinghamshire | British | Operations Director | 72172980001 | |||||
DORRELL, Michael John | Amministratore | 29 Onslow Gardens CM5 9BG Ongar Essex | British | Company Director | 10489280001 | |||||
FINN, Shaun Raymond | Amministratore | 11 Nottingham Road Lowdham NG14 7AL Nottingham | England | British | Finance Director | 112482850001 | ||||
GOGERTY, Richard Howard | Amministratore | Marriner Crescent LN2 1BB Lincoln 2 Lincolnshire | England | British | Managing Director | 83926860003 | ||||
HARPER, Peter Joseph | Amministratore | Mayhall Lodge Oakway HP6 5PQ Amersham Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 133340001 | ||||
HARRIS, Mark Smeeth | Amministratore | 21 Oakdene Sunningdale SL5 0BU Ascot Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 104260670001 | ||||
HOOPER, Harry | Amministratore | 33 Leicester Close NN16 8EZ Kettering Northamptonshire | British | Director | 72172830001 | |||||
MURRAY, Keith Alexander | Amministratore | 4 Copperfield Orchard Kemsing TN15 6QH Sevenoaks Kent | British | Company Director | 10489300001 | |||||
PRYCE, Timothy Denzil | Amministratore | Thrumpton Lane DN22 6HH Retford Victoria Works Nottinghamshire | United Kingdom | British | Director | 139882140005 | ||||
RUFFLE, Anthony John Howard | Amministratore | 8 Hurstwood Drive BR1 2JF Bromley Kent | British | Company Director | 10489270001 | |||||
SLADE, Peter Andrew | Amministratore | Mavis Cottage Forest Road, Binfield RG42 4DU Bracknell Berkshire | England | British | Director | 66030400002 | ||||
STEVENSON, Anthony Robert | Amministratore | 1 Glamis Gardens Longthorpe PE3 9PQ Peterborough Cambridgeshire | British | Company Director | 39591520001 | |||||
SUNTER, Amanda Jane | Amministratore | 664 Rayleigh Road Hutton CM13 1SJ Brentwood Essex | British | G Fin Director | 44240520002 | |||||
THOMAS, Christopher John | Amministratore | Whateley House 9 Wheatley Green Four Oaks B74 2RL Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | Chief Executive | 37235920002 | ||||
WILKINSON, Neil Freeman | Amministratore | Larkswood Jordans Way Jordans HP9 2SP Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 638810003 |
RAB 100 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
An omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 24 dic 2004 Consegnato il 12 gen 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 24 dic 2004 Consegnato il 07 gen 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Omnibus letter of set-off | Creato il 12 dic 2002 Consegnato il 19 dic 2002 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum standing to the credit of an account,as defined,whether in sterling or any other currency and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum and "credit balances"; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 dic 2002 Consegnato il 19 dic 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 dic 2002 Consegnato il 19 dic 2002 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture deed | Creato il 11 set 2001 Consegnato il 19 set 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All money and liabilites whether actual or contingent which then were or at any time thereafter may be due owing or incurred by the company to the chargee and/or any new loan note holder pursuant to the new guarantee (all terms as defined) | |
Brevi particolari The property being land and buildings lying to the west of gascoigne road barking essex title number EGL320163. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture deed | Creato il 20 giu 2000 Consegnato il 06 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture deed | Creato il 20 giu 2000 Consegnato il 06 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 28 set 1999 Consegnato il 05 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 24 dic 1993 Consegnato il 14 gen 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to the intercreditor agreement (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 14 giu 1963 Consegnato il 25 giu 1963 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0