RAB 100 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRAB 100 LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00043117
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RAB 100 LIMITED?

    • (2513) /

    Dove si trova RAB 100 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Victoria Works
    Thrumpton Lane
    DN22 6HH Retford
    Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RAB 100 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ICON WARNE LIMITED05 ott 200005 ott 2000
    WILLIAM WARNE LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    WILLIAM WARNE AND COMPANY,LIMITED23 gen 189523 gen 1895

    Quali sono gli ultimi bilanci di RAB 100 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 set 2011
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2012
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per RAB 100 LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al01 giu 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma15 giu 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per RAB 100 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per RAB 100 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di Shaun Raymond Finn come segretario in data 09 ott 2012

    1 pagineTM02
    X73R9G7V

    Cessazione della carica di Timothy Denzil Pryce come amministratore in data 09 ott 2012

    1 pagineTM01
    X73R9DXN

    Cessazione della carica di Shaun Raymond Finn come amministratore in data 09 ott 2012

    1 pagineTM01
    X73R9D0B

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92
    Q615AH2G

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A1AXNTG0

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed icon warne LIMITED\certificate issued on 23/02/12
    2 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name23 feb 2012

    Risoluzione di cambio di nome della società il 13 feb 2012

    RES15
    A135OBYY

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT
    A135OBYQ

    legacy

    1 pagineCAP-SS
    A127TTEG

    legacy

    1 pagineSH20
    A127TTH4

    Stato del capitale al 07 feb 2012

    • Capitale: GBP 0.104060
    4 pagineSH19
    A127TTCP

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium cancelled 06/02/2012
    RES13

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Denzil Pryce il 24 ago 2011

    2 pagineCH01
    XL1L4X05

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    XTJRKUR5

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2010

    5 pagineAA
    AHWKRTVM

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    XSPB6KP4

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Denzil Pryce il 31 mag 2010

    2 pagineCH01
    XSPB5KP3

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009

    7 pagineAA
    AYOTSJYY

    legacy

    2 pagine288a
    PA0BUBYD

    legacy

    1 pagine288b
    PA0C0BYK

    legacy

    4 pagine363a
    XJMV8AKZ

    legacy

    1 pagine287
    XJMV5AKW

    legacy

    1 pagine190
    XJMV7AKY

    legacy

    1 pagine353
    XJMV6AKX

    Chi sono gli amministratori di RAB 100 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FINN, Shaun Raymond
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    Segretario
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    BritishFinance Director112482850001
    HARRIS, Mark Smeeth
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    Segretario
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    BritishAccountant104260670001
    RUFFLE, Anthony John Howard
    8 Hurstwood Drive
    BR1 2JF Bromley
    Kent
    Segretario
    8 Hurstwood Drive
    BR1 2JF Bromley
    Kent
    British10489270001
    SUNTER, Amanda Jane
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    Segretario
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    British44240520002
    ASHFORD, Leslie Ernest Thomas
    27 Beckenham Road
    BR4 0QR West Wickham
    Kent
    Amministratore
    27 Beckenham Road
    BR4 0QR West Wickham
    Kent
    EnglandBritishChief Executive398670001
    ASHURST, Norman
    5 De Narde Road
    NR19 2HQ Dereham
    Norfolk
    Amministratore
    5 De Narde Road
    NR19 2HQ Dereham
    Norfolk
    BritishDirector70931510001
    BARNES, Raymond
    27 Chestwood Close
    CM12 0PB Billericay
    Essex
    Amministratore
    27 Chestwood Close
    CM12 0PB Billericay
    Essex
    BritishCompany Director10489290001
    CALLAN, Maurice Simon
    Ayres Cottage
    71 Bicester Road Long Crendon
    HP18 9EE Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Ayres Cottage
    71 Bicester Road Long Crendon
    HP18 9EE Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishOperations Director72172980001
    DORRELL, Michael John
    29 Onslow Gardens
    CM5 9BG Ongar
    Essex
    Amministratore
    29 Onslow Gardens
    CM5 9BG Ongar
    Essex
    BritishCompany Director10489280001
    FINN, Shaun Raymond
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    Amministratore
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    EnglandBritishFinance Director112482850001
    GOGERTY, Richard Howard
    Marriner Crescent
    LN2 1BB Lincoln
    2
    Lincolnshire
    Amministratore
    Marriner Crescent
    LN2 1BB Lincoln
    2
    Lincolnshire
    EnglandBritishManaging Director83926860003
    HARPER, Peter Joseph
    Mayhall Lodge
    Oakway
    HP6 5PQ Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Mayhall Lodge
    Oakway
    HP6 5PQ Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director133340001
    HARRIS, Mark Smeeth
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant104260670001
    HOOPER, Harry
    33 Leicester Close
    NN16 8EZ Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    33 Leicester Close
    NN16 8EZ Kettering
    Northamptonshire
    BritishDirector72172830001
    MURRAY, Keith Alexander
    4 Copperfield Orchard
    Kemsing
    TN15 6QH Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    4 Copperfield Orchard
    Kemsing
    TN15 6QH Sevenoaks
    Kent
    BritishCompany Director10489300001
    PRYCE, Timothy Denzil
    Thrumpton Lane
    DN22 6HH Retford
    Victoria Works
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Thrumpton Lane
    DN22 6HH Retford
    Victoria Works
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector139882140005
    RUFFLE, Anthony John Howard
    8 Hurstwood Drive
    BR1 2JF Bromley
    Kent
    Amministratore
    8 Hurstwood Drive
    BR1 2JF Bromley
    Kent
    BritishCompany Director10489270001
    SLADE, Peter Andrew
    Mavis Cottage
    Forest Road, Binfield
    RG42 4DU Bracknell
    Berkshire
    Amministratore
    Mavis Cottage
    Forest Road, Binfield
    RG42 4DU Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritishDirector66030400002
    STEVENSON, Anthony Robert
    1 Glamis Gardens
    Longthorpe
    PE3 9PQ Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    1 Glamis Gardens
    Longthorpe
    PE3 9PQ Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director39591520001
    SUNTER, Amanda Jane
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    Amministratore
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    BritishG Fin Director44240520002
    THOMAS, Christopher John
    Whateley House
    9 Wheatley Green Four Oaks
    B74 2RL Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    Whateley House
    9 Wheatley Green Four Oaks
    B74 2RL Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishChief Executive37235920002
    WILKINSON, Neil Freeman
    Larkswood Jordans Way
    Jordans
    HP9 2SP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Larkswood Jordans Way
    Jordans
    HP9 2SP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant638810003

    RAB 100 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 24 dic 2004
    Consegnato il 12 gen 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 24 dic 2004
    Consegnato il 07 gen 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transazioni
    • 07 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Omnibus letter of set-off
    Creato il 12 dic 2002
    Consegnato il 19 dic 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of an account,as defined,whether in sterling or any other currency and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum and "credit balances"; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 12 dic 2002
    Consegnato il 19 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (The Trustee)
    Transazioni
    • 19 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 dic 2002
    Consegnato il 19 dic 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture deed
    Creato il 11 set 2001
    Consegnato il 19 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilites whether actual or contingent which then were or at any time thereafter may be due owing or incurred by the company to the chargee and/or any new loan note holder pursuant to the new guarantee (all terms as defined)
    Brevi particolari
    The property being land and buildings lying to the west of gascoigne road barking essex title number EGL320163. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (The "Trustee")
    Transazioni
    • 19 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 05 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 20 giu 2000
    Consegnato il 06 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transazioni
    • 06 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 05 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 20 giu 2000
    Consegnato il 06 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 06 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 23 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 set 1999
    Consegnato il 05 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 24 dic 1993
    Consegnato il 14 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to the intercreditor agreement (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Trustee for the Securedbeneficiaries(As Defined)
    Transazioni
    • 14 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 14 giu 1963
    Consegnato il 25 giu 1963
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Schroder Executor & Trustee Compny Limited
    Transazioni
    • 25 giu 1963Registrazione di un'ipoteca
    • 10 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0