GREEN (T.P.) LIMITED

GREEN (T.P.) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGREEN (T.P.) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00049157
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GREEN (T.P.) LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova GREEN (T.P.) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    KPMG
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Merseyside
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GREEN (T.P.) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRAFFORD PARK ESTATES LIMITED17 ago 189617 ago 1896

    Quali sono gli ultimi bilanci di GREEN (T.P.) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per GREEN (T.P.) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 giu 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 dic 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 giu 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 dic 2009

    5 pagine4.68

    legacy

    1 pagine287

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution insolvency:ordinary resolution "books,records.etc"
    2 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution insolvency:extraordinary resolution "in specie"
    2 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 18 dic 2008

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 30 set 2006

    17 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    pagine363(288)

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 30 set 2005

    20 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di GREEN (T.P.) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MUNRO, Mark
    14 Longford Terrace
    Monkstown
    Co Dublin
    Ireland
    Segretario
    14 Longford Terrace
    Monkstown
    Co Dublin
    Ireland
    Irish88709730004
    CULHANE, Paul
    Ballyorney Road
    Enniskerry
    Killough House
    Wicklow
    Ireland
    Amministratore
    Ballyorney Road
    Enniskerry
    Killough House
    Wicklow
    Ireland
    IrelandIrish49388470004
    MCKENNA, James
    3 Kilteragh Road Foxrock
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    Amministratore
    3 Kilteragh Road Foxrock
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrish84380760001
    MUNRO, Mark
    14 Longford Terrace
    Monkstown
    Co Dublin
    Ireland
    Amministratore
    14 Longford Terrace
    Monkstown
    Co Dublin
    Ireland
    IrelandIrish88709730004
    VERNON, Stephen
    7 Winton Road
    Ranelagh
    Dublin 6
    Ireland
    Amministratore
    7 Winton Road
    Ranelagh
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandBritish6399990006
    BRIGGS, Richard Jonathan
    8 Greenway
    SK9 1LU Wilmslow
    Cheshire
    Segretario
    8 Greenway
    SK9 1LU Wilmslow
    Cheshire
    British9000960002
    MCDOWELL, David
    The Bungalow
    Silchester
    IRISH Glenageary
    Co Dublin
    Ireland
    Segretario
    The Bungalow
    Silchester
    IRISH Glenageary
    Co Dublin
    Ireland
    Irish85557670001
    WALKER, Andrew James
    240 Padgbury Lane
    CW12 4HU Congleton
    Cheshire
    Segretario
    240 Padgbury Lane
    CW12 4HU Congleton
    Cheshire
    British36424560001
    BRIGGS, Richard Jonathan
    8 Greenway
    SK9 1LU Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    8 Greenway
    SK9 1LU Wilmslow
    Cheshire
    British9000960002
    CHERRY, Mark Edward
    Glebe House
    Chequers Lane Preston
    SG4 7TY Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    Glebe House
    Chequers Lane Preston
    SG4 7TY Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritish141619810001
    DAVIS, James Wilson
    The Stables, Smithy Fold
    Watling Street, Affetside
    BL8 3QS Bury
    Lancashire
    Amministratore
    The Stables, Smithy Fold
    Watling Street, Affetside
    BL8 3QS Bury
    Lancashire
    EnglandBritish67445010001
    GERRARD, Raymond Ormesher
    12 Woodlea Walkden Road
    Worsley
    M28 2QJ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    12 Woodlea Walkden Road
    Worsley
    M28 2QJ Manchester
    Lancashire
    British63565710001
    HARRIS, Alan Joseph
    Brendon
    Catlins Lane Eastcote
    HA5 2EZ Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    Brendon
    Catlins Lane Eastcote
    HA5 2EZ Pinner
    Middlesex
    Irish141619800001
    HOWE, Robert Philip Graham
    60 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DS London
    Amministratore
    60 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DS London
    British59138110008
    HUNT, Michelle Marie
    62 First Avenue
    CM1 1RU Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    62 First Avenue
    CM1 1RU Chelmsford
    Essex
    British68329820002
    KITCHEN, Daniel John
    5 Torquay Wood
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    Amministratore
    5 Torquay Wood
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    United KingdomBritish153028260001
    LEADER, Thomas David
    Silvers
    Ridgway Pyrford
    GU22 8PN Surrey
    Amministratore
    Silvers
    Ridgway Pyrford
    GU22 8PN Surrey
    United KingdomBritish115424450002
    SIMPKIN, Andrew Gordon
    Chapel Lane House
    Chapel Lane, Mere
    WA16 6PP Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Chapel Lane House
    Chapel Lane, Mere
    WA16 6PP Knutsford
    Cheshire
    British71318160001
    SMITH, Ian Fredric
    56 Sandown Crescent
    Cuddington
    CW8 2QW Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    56 Sandown Crescent
    Cuddington
    CW8 2QW Northwich
    Cheshire
    British18178840001
    TAPP, Michael Stuart
    132 Wymering Mansions
    Wymering Road
    W9 2NF London
    Amministratore
    132 Wymering Mansions
    Wymering Road
    W9 2NF London
    British68137250003
    WESTBROOK, Fraser Gowanloch
    23 Lingfield Road
    SW19 4QD London
    Amministratore
    23 Lingfield Road
    SW19 4QD London
    British22092430001
    WESTBROOK, Neil Gowanloch, Sir
    White Gables Castle Hill
    SK10 4AR Prestbury
    Cheshire
    Amministratore
    White Gables Castle Hill
    SK10 4AR Prestbury
    Cheshire
    British19592890001

    GREEN (T.P.) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 07 nov 2003
    Consegnato il 25 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the finance parties (or any of them)
    Brevi particolari
    The mortgage property being the parkway shopping centre newham way coulby newham middlesborough t/n CE89343, 56 oxford street manchester t/n LA276480, 90 great bridgewater street & part of 56 oxford street manchester LA37145. For details of further properties charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Mortgage Bank Europe PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security deed
    Creato il 29 ott 2002
    Consegnato il 18 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In relation to each irish obligor (other than the company and green) prior to the whitewash completion date all present and future obligations and liabilities due or to become due from green and each other obligor (other than the company) to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the chargeand the company, gpm finance and each obligor incorporated in the U.K. or jersey; and from the whitewash completion date; each irish obligor other than green,all present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 18 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 ago 1993
    Consegnato il 11 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property being or k/a the westbrook road industrial estate trafford park manchester.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Series of debentures
    Creato il 19 set 1983
    Consegnato il 19 set 1983
    In corso
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation PLC
    Transazioni
    • 19 set 1983Registrazione di un'ipoteca
    Equitable charges
    Creato il 03 mag 1983
    Consegnato il 23 mag 1983
    In corso
    Importo garantito
    £6,250,000 first mortgage debenture stock of trafford park estates PLC inclusive of £3,250,000 stock secured by a trust deed dated 13 oct 11965 and deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    Floating charge on fixed charges on chief rents and f/hold properties as mentioned in the schedules attached to doc M289.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation PLC.
    Transazioni
    • 23 mag 1983Registrazione di un'ipoteca
    Sixth supplemental trust deed.
    Creato il 12 dic 1980
    Consegnato il 15 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing 1,250,000 7 1/4 percent fixed mortgage debenture stock 1990/95 of the company & £2,000,000 9 percent first mortgage debenture stock 1991/96 of the company & other monies intended to the secured by the principal deed dated 13 october 1965 and the first supplemental trust deed dated 25 august 1969.
    Brevi particolari
    1.95 acres of land with building thereon known as laing national building situate between trafford park road and trafford wharf road, trafford park, manchester. Title no:- la 345299 with fixed plant & machinery & other fixtures, all buildings erections, structures & things constructed or in the course of construction thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation Limited
    Transazioni
    • 15 dic 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 27 mag 1980
    Consegnato il 29 mag 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Debenture stock of the company £3,250,000 and all other moneys secured by a principal deed dated 13TH october, 1965, and the first supplemental trust deed dated 25TH august, 1969
    Brevi particolari
    F/Hold, laing national building between trafford park road and trafford wharf road, trafford park, manchester.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation Limited.
    Transazioni
    • 29 mag 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Series of debentures
    Creato il 25 ago 1969
    Consegnato il 26 ago 1969
    Soddisfatta integralmente
    Brevi particolari
    See doc. 250 & attached schedules.
    Persone aventi diritto
    • Baring Brothers & Co., Limited
    Transazioni
    • 26 ago 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 04 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Series of debentures
    Creato il 13 ott 1965
    Consegnato il 13 ott 1965
    Soddisfatta integralmente
    Brevi particolari
    See rider attached to doc. 236.
    Persone aventi diritto
    • Baring Brothers & Co., Limited
    Transazioni
    • 13 ott 1965Registrazione di un'ipoteca
    • 19 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 04 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GREEN (T.P.) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 dic 2011Data di scioglimento
    18 dic 2008Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Hansen
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    Praticante
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0