DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED

DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00052182
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive, Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DAVENPORT VERNON & COMPANY LIMITED15 apr 189715 apr 1897

    Quali sono gli ultimi bilanci di DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 14 lug 2017

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 29/06/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come amministratore in data 01 gen 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come segretario in data 01 gen 2017

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Richard James Maloney come segretario in data 01 gen 2017

    2 pagineAP03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 gen 2016

    Stato del capitale al 19 gen 2016

    • Capitale: GBP 14,793
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Timothy Paul Holden il 26 ott 2015

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 gen 2015

    Stato del capitale al 21 gen 2015

    • Capitale: GBP 14,793
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 gen 2014

    Stato del capitale al 22 gen 2014

    • Capitale: GBP 14,793
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 17 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MALONEY, Richard James
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive, Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive, Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    222149230001
    HOLDEN, Timothy Paul
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive, Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive, Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish148034310003
    EVANS HALSHAW MOTORS LIMITED
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2304195
    38967740005
    JAMES, Clive Michael
    19 Lime Avenue
    MK18 7JJ Buckingham
    Buckinghamshire
    Segretario
    19 Lime Avenue
    MK18 7JJ Buckingham
    Buckinghamshire
    British58586570001
    LACEY, Pamela Anne
    Orchard Cottage Green Lane
    Prestwood
    HP16 0QA Great Missenden
    Buckinghamshire
    Segretario
    Orchard Cottage Green Lane
    Prestwood
    HP16 0QA Great Missenden
    Buckinghamshire
    British3665020001
    PITT, Andrew Joseph
    45 Westholme Road
    Bidford On Avon
    B50 4AL Alcester
    Warwickshire
    Segretario
    45 Westholme Road
    Bidford On Avon
    B50 4AL Alcester
    Warwickshire
    British10739800001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive, Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive, Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    British41559790001
    ADAMS, Anthony Grant
    71 Townsend Lane
    AL5 2RE Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    71 Townsend Lane
    AL5 2RE Harpenden
    Hertfordshire
    British24182780001
    ARCHER, Anthony Bernard
    The Moat Barn
    Glasshouse Lane
    B94 6PU Lapworth
    Warwickshire
    Amministratore
    The Moat Barn
    Glasshouse Lane
    B94 6PU Lapworth
    Warwickshire
    British46351440001
    BAKER, Donald John
    Kings Ash Farm
    Kings Ash
    HP16 9NP Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Kings Ash Farm
    Kings Ash
    HP16 9NP Great Missenden
    Buckinghamshire
    British11327670002
    BENNETT, Michael Ronald
    2 Kentmere Road
    HP21 7HZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    2 Kentmere Road
    HP21 7HZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish75618940001
    CAMERON, Charles Donald Ewen
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish113187140001
    DALE, Arthur Geoffrey
    Kimberley
    Poolhead Lane
    B94 5ED Tanworth In Arden Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Kimberley
    Poolhead Lane
    B94 5ED Tanworth In Arden Solihull
    West Midlands
    British10739820001
    DENNE, David Ralph
    Bucks Barn
    Highmoor
    RG9 5PE Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Bucks Barn
    Highmoor
    RG9 5PE Henley On Thames
    Oxfordshire
    British35524210001
    MURPHY, Patrick Francis
    32 Aldrich Drive
    Willen
    MK15 9LU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    32 Aldrich Drive
    Willen
    MK15 9LU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British30408640002
    STYLES, William
    Hyfirs
    Downley Road Naphill
    HP14 4QY High Wycombe
    Bucks
    Amministratore
    Hyfirs
    Downley Road Naphill
    HP14 4QY High Wycombe
    Bucks
    British24499510001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive, Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive, Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish41559790001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Evans Halshaw Motor Holdings Limited
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    06 apr 2016
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione1212182
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    DAVENPORT VERNON HIGH WYCOMBE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security agreement
    Creato il 13 mag 2009
    Consegnato il 21 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Override Agent)
    Transazioni
    • 21 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 17 ago 1988
    Consegnato il 26 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or 7 other companies named on the schedule to elf oil(ge) limited, under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    F/H petrol filling station & premises fronting london rd high wycombe, buckinghamshire. Described in the 1ST schedule of a deed of exchange on 17/09/65 land situate at london rd, high wycombe comprised in a conveyance - 28/03/74 f/h property in high wycombe comprised in a conveyance- 2/8/66 f/h land situate in high wycombe comprised in a conveyance - 30/11/65 (please see form M39-304C- for further details).
    Persone aventi diritto
    • Elf Oil (GB) Limited
    Transazioni
    • 26 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 27 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 12 nov 1986
    Consegnato il 13 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over all stocks or new and used mechanically propelled vehicles owned by the company and intended or adapted for use upon roads &/or the proceeds of sale of any such vehicles. (See doc M531/14NOV/cr for full details).
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 13 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 26 feb 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 lug 1980
    Consegnato il 11 ago 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land & premises at london road, high wycombe. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0