TI MEDIA LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTI MEDIA LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00053626
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TI MEDIA LIMITED?

    • Edizione di riviste per il grande pubblico e per le imprese (58142) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova TI MEDIA LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Quay House
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TI MEDIA LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TIME INC. (UK) LTD03 set 201403 set 2014
    IPC MEDIA LIMITED08 giu 200008 giu 2000
    I.P.C. MAGAZINES LIMITED05 ago 189705 ago 1897

    Quali sono gli ultimi bilanci di TI MEDIA LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per TI MEDIA LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Nomina di Mr Andrew John Thomas come amministratore in data 01 mar 2024

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Penelope Anne Ladkin-Brand come amministratore in data 01 mar 2024

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Oliver James Foster come amministratore in data 01 mar 2024

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Oliver James Foster come amministratore in data 30 mag 2023

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr David John Bateson come segretario in data 31 mar 2023

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr David John Bateson come amministratore in data 31 mar 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Zillah Ellen Byng-Thorne come amministratore in data 31 mar 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Robert William Tompkins come amministratore in data 18 dic 2022

    2 pagineAP01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 set 2021

    18 pagineAA

    legacy

    182 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Penelope Anne Ladkin-Brand il 20 apr 2022

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Zillah Ellen Byng-Thorne il 17 feb 2022

    2 pagineCH01

    Nomina di Penelope Anne Ladkin-Brand come amministratore in data 01 nov 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Rachel Bernadette Addison come amministratore in data 31 ott 2021

    1 pagineTM01

    Modifica dei dettagli di Sapphire Bidco Limited come persona con controllo significativo il 18 ago 2020

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 set 2020

    27 pagineAA

    legacy

    172 paginePARENT_ACC

    Chi sono gli amministratori di TI MEDIA LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BATESON, David John
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    Segretario
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    307920790001
    BATESON, David John
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    Amministratore
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    United KingdomBritish259939150001
    THOMAS, Andrew John
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    Amministratore
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    EnglandBritish137715700001
    TOMPKINS, Robert William
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    Amministratore
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    EnglandBritish303888570001
    GORE, John Francis
    14 Chantry Hurst
    Woodcote Green
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    Segretario
    14 Chantry Hurst
    Woodcote Green
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    British352680001
    KLEIN, Lauren Ezrol
    Liberty Street
    10281 New York City
    225
    New York
    Usa
    Segretario
    Liberty Street
    10281 New York City
    225
    New York
    Usa
    British127397780001
    MCCARTHY, Robert
    3 Woods Lane
    Chatham
    New Jersey 07928
    Usa
    Segretario
    3 Woods Lane
    Chatham
    New Jersey 07928
    Usa
    British78644500001
    REDPATH, John
    331 East 83rd Street
    New York
    New York 10028
    Usa
    Segretario
    331 East 83rd Street
    New York
    New York 10028
    Usa
    British88622150001
    WILLIAMS, Sally Jane
    13 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    Segretario
    13 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    British3660830002
    ADDISON, Rachel Bernadette
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    Amministratore
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    United KingdomBritish250816460001
    ALEY, William Robert
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    Amministratore
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    British25440920002
    ANDERSON, Alun, Dr
    2 Park Avenue South
    N8 8LT London
    Amministratore
    2 Park Avenue South
    N8 8LT London
    EnglandBritish54339140001
    ARCULUS, Thomas David Guy
    Flat 193 County Hall North Block
    1a Belvedere Road
    SE1 7GH London
    Amministratore
    Flat 193 County Hall North Block
    1a Belvedere Road
    SE1 7GH London
    British80344070001
    ATKINSON, Richard Gordon
    100 Grace Church Street
    Rye
    New York
    10580
    Usa
    Amministratore
    100 Grace Church Street
    Rye
    New York
    10580
    Usa
    British78644420001
    AUTON, Sylvia Jean
    Fernholme House, 54 Camlet Way
    Hadley Wood
    EN4 0NS Barnet
    Hertfordshire
    Amministratore
    Fernholme House, 54 Camlet Way
    Hadley Wood
    EN4 0NS Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish59045280002
    AVERILL, Howard
    20 Church Tavern Road
    South Salem
    New York
    10590
    Usa
    Amministratore
    20 Church Tavern Road
    South Salem
    New York
    10590
    Usa
    UsaUsa127283350001
    BAILEY, Sylvia
    5 Blyths Wharf
    Narrow Street
    E14 8DQ London
    Amministratore
    5 Blyths Wharf
    Narrow Street
    E14 8DQ London
    British67232740001
    BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr.
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Amministratore
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    UsaAmerican181954550002
    BOREHAM, Edward Charles
    19 The Meads
    Cranham
    RM14 3YP Upminster
    Essex
    Amministratore
    19 The Meads
    Cranham
    RM14 3YP Upminster
    Essex
    British18237280001
    BOYD, Christopher James
    The Old Farmhouse
    Biddenden Road
    TN17 2BE Frittenden
    Kent
    Amministratore
    The Old Farmhouse
    Biddenden Road
    TN17 2BE Frittenden
    Kent
    British104281560001
    BROOKS, Timothy Stephen
    3 Bowers Way
    AL5 4EP Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Bowers Way
    AL5 4EP Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish72643520002
    BROWN, Philippa Anne
    93 Studdridge Street
    SW6 3TD London
    Amministratore
    93 Studdridge Street
    SW6 3TD London
    United KingdomBritish64176480004
    BYNG-THORNE, Zillah Ellen
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    Amministratore
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    EnglandBritish182681640004
    CARAYOL, Rene Roland
    3 Victoria Rise
    Hilgrove Road
    NW6 4TH Swiss Cottage
    London
    Amministratore
    3 Victoria Rise
    Hilgrove Road
    NW6 4TH Swiss Cottage
    London
    United KingdomBritish155413470001
    CHEAL, Paul Andrew
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Amministratore
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    United KingdomBritish112376740002
    CLAYTON, Michael Aylwin
    Sunnyside Cottage
    Braunston
    LE15 8QW Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    Sunnyside Cottage
    Braunston
    LE15 8QW Oakham
    Leicestershire
    British64639900001
    CRACE, Georgina
    Garden Flat
    14 Lawn Road
    NW3 2XS London
    Amministratore
    Garden Flat
    14 Lawn Road
    NW3 2XS London
    British55927170001
    D'EMIC, Susana Alves
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Amministratore
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    United StatesAmerican265525580001
    DAVIDSON, Nigel James
    Luton Cottage The Street
    Selling
    ME13 9RQ Faversham
    Kent
    Amministratore
    Luton Cottage The Street
    Selling
    ME13 9RQ Faversham
    Kent
    British18237320001
    DAVIES, Andrea Clare
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Amministratore
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    United KingdomBritish266948310001
    DENT, Fiona Ann
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Amministratore
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    EnglandBritish192515270001
    DRINKALL, Christopher John Julian
    39 Saltoun Road
    SW2 1EN London
    Amministratore
    39 Saltoun Road
    SW2 1EN London
    EnglandBritish76437030001
    EDEN, Keith Leslie
    6 Friends Walk
    CB11 4EA Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    6 Friends Walk
    CB11 4EA Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritish53429470001
    EVANS, Richard John
    41 King Edwards Grove
    TW11 9LZ Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    41 King Edwards Grove
    TW11 9LZ Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish77303490001
    EVANS, Sylvia Kathleen
    401 Alaska Building 61 Grange Road
    SE1 3BB London
    Amministratore
    401 Alaska Building 61 Grange Road
    SE1 3BB London
    United KingdomNew Zealander70941240001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TI MEDIA LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    United Kingdom
    20 apr 2020
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaCorporate
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleEngland & Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03757874
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Marsh Wall
    E14 9AP London
    161
    United Kingdom
    15 mar 2018
    Marsh Wall
    E14 9AP London
    161
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione11157141
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    15 mar 2018
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione11157309
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    06 apr 2016
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3464980
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Time Inc.
    Corporation Trust Center, 1209 Orange Street
    19801 Wilmington
    C/O The Corporation Trust Company
    De
    United States
    06 apr 2016
    Corporation Trust Center, 1209 Orange Street
    19801 Wilmington
    C/O The Corporation Trust Company
    De
    United States
    Forma giuridicaCorporate
    Paese di registrazioneState Of Delaware, Usa
    Autorità legaleState Of Delaware, Usa
    Luogo di registrazioneState Of Delaware, Usa
    Numero di registrazione13-3486363
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    TI MEDIA LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 05 apr 2018
    Consegnato il 11 apr 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Intellectual property with trademark number 270056.. please see instrument for further details.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Management Limited
    Transazioni
    • 11 apr 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 apr 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 ago 1999
    Consegnato il 02 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Part basement and ground and fourth fifth and sixth floors 237-247 tottenham court road london W1P oau; ground floor workshop and first and second floor offices in westover house west quay road poole dorset; 39 car parking spaces at westover house west quay road poole dorset t/nos: NGL78946 and DT42610 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of amendment dated 22 december 1998 deed of accession dated 12 october 1998 supplemental to the debenture dated 19 january 1998
    Creato il 22 dic 1998
    Acquisito il 15 feb 1999
    Consegnato il 03 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 1999Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession dated 12 october 1998 supplemental to the debenture dated 19 january 1998
    Creato il 12 ott 1998
    Acquisito il 15 feb 1999
    Consegnato il 03 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 1999Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture (to a debenture dated 19 january 1998)
    Creato il 12 ott 1998
    Consegnato il 15 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents (each as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 gen 1998
    Consegnato il 06 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee under each or any of the senior finance documents and/or mezzanine finance documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 06 nov 1968
    Consegnato il 22 nov 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing debenture stock of international publishing corporation limited amounting to £16,960,172 inclusive of £6,960,172 secured by a trust deed dated 27/6/63 and deeds supplemental.
    Brevi particolari
    The property comprised in a trust deed dated 27/06/1963.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation LTD
    Transazioni
    • 22 nov 1968Registrazione di un'ipoteca
    • 02 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 27 giu 1963
    Consegnato il 01 lug 1963
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing £6,960,172 debenture stock of international publishing corporation limited
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets including uncalled capital within the UK.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation LTD
    Transazioni
    • 01 lug 1963Registrazione di un'ipoteca
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0