TI MEDIA LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TI MEDIA LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00053626 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TI MEDIA LIMITED?
- Edizione di riviste per il grande pubblico e per le imprese (58142) / Informazione e comunicazione
Dove si trova TI MEDIA LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Quay House The Ambury BA1 1UA Bath England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TI MEDIA LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TIME INC. (UK) LTD | 03 set 2014 | 03 set 2014 |
| IPC MEDIA LIMITED | 08 giu 2000 | 08 giu 2000 |
| I.P.C. MAGAZINES LIMITED | 05 ago 1897 | 05 ago 1897 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TI MEDIA LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per TI MEDIA LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Nomina di Mr Andrew John Thomas come amministratore in data 01 mar 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Penelope Anne Ladkin-Brand come amministratore in data 01 mar 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Oliver James Foster come amministratore in data 01 mar 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Oliver James Foster come amministratore in data 30 mag 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr David John Bateson come segretario in data 31 mar 2023 | 2 pagine | AP03 | ||
Nomina di Mr David John Bateson come amministratore in data 31 mar 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Zillah Ellen Byng-Thorne come amministratore in data 31 mar 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Robert William Tompkins come amministratore in data 18 dic 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 set 2021 | 18 pagine | AA | ||
legacy | 182 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Penelope Anne Ladkin-Brand il 20 apr 2022 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Zillah Ellen Byng-Thorne il 17 feb 2022 | 2 pagine | CH01 | ||
Nomina di Penelope Anne Ladkin-Brand come amministratore in data 01 nov 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Rachel Bernadette Addison come amministratore in data 31 ott 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Modifica dei dettagli di Sapphire Bidco Limited come persona con controllo significativo il 18 ago 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 set 2020 | 27 pagine | AA | ||
legacy | 172 pagine | PARENT_ACC | ||
Chi sono gli amministratori di TI MEDIA LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATESON, David John | Segretario | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | 307920790001 | |||||||
| BATESON, David John | Amministratore | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | United Kingdom | British | 259939150001 | |||||
| THOMAS, Andrew John | Amministratore | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | British | 137715700001 | |||||
| TOMPKINS, Robert William | Amministratore | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | British | 303888570001 | |||||
| GORE, John Francis | Segretario | 14 Chantry Hurst Woodcote Green KT18 7BW Epsom Surrey | British | 352680001 | ||||||
| KLEIN, Lauren Ezrol | Segretario | Liberty Street 10281 New York City 225 New York Usa | British | 127397780001 | ||||||
| MCCARTHY, Robert | Segretario | 3 Woods Lane Chatham New Jersey 07928 Usa | British | 78644500001 | ||||||
| REDPATH, John | Segretario | 331 East 83rd Street New York New York 10028 Usa | British | 88622150001 | ||||||
| WILLIAMS, Sally Jane | Segretario | 13 Ranelagh Road RH1 6BJ Redhill Surrey | British | 3660830002 | ||||||
| ADDISON, Rachel Bernadette | Amministratore | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | United Kingdom | British | 250816460001 | |||||
| ALEY, William Robert | Amministratore | Grove Cottage Woodham Walter CM9 6RX Maldon Essex | British | 25440920002 | ||||||
| ANDERSON, Alun, Dr | Amministratore | 2 Park Avenue South N8 8LT London | England | British | 54339140001 | |||||
| ARCULUS, Thomas David Guy | Amministratore | Flat 193 County Hall North Block 1a Belvedere Road SE1 7GH London | British | 80344070001 | ||||||
| ATKINSON, Richard Gordon | Amministratore | 100 Grace Church Street Rye New York 10580 Usa | British | 78644420001 | ||||||
| AUTON, Sylvia Jean | Amministratore | Fernholme House, 54 Camlet Way Hadley Wood EN4 0NS Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 59045280002 | |||||
| AVERILL, Howard | Amministratore | 20 Church Tavern Road South Salem New York 10590 Usa | Usa | Usa | 127283350001 | |||||
| BAILEY, Sylvia | Amministratore | 5 Blyths Wharf Narrow Street E14 8DQ London | British | 67232740001 | ||||||
| BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr. | Amministratore | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | Usa | American | 181954550002 | |||||
| BOREHAM, Edward Charles | Amministratore | 19 The Meads Cranham RM14 3YP Upminster Essex | British | 18237280001 | ||||||
| BOYD, Christopher James | Amministratore | The Old Farmhouse Biddenden Road TN17 2BE Frittenden Kent | British | 104281560001 | ||||||
| BROOKS, Timothy Stephen | Amministratore | 3 Bowers Way AL5 4EP Harpenden Hertfordshire | England | British | 72643520002 | |||||
| BROWN, Philippa Anne | Amministratore | 93 Studdridge Street SW6 3TD London | United Kingdom | British | 64176480004 | |||||
| BYNG-THORNE, Zillah Ellen | Amministratore | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | British | 182681640004 | |||||
| CARAYOL, Rene Roland | Amministratore | 3 Victoria Rise Hilgrove Road NW6 4TH Swiss Cottage London | United Kingdom | British | 155413470001 | |||||
| CHEAL, Paul Andrew | Amministratore | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United Kingdom | British | 112376740002 | |||||
| CLAYTON, Michael Aylwin | Amministratore | Sunnyside Cottage Braunston LE15 8QW Oakham Leicestershire | British | 64639900001 | ||||||
| CRACE, Georgina | Amministratore | Garden Flat 14 Lawn Road NW3 2XS London | British | 55927170001 | ||||||
| D'EMIC, Susana Alves | Amministratore | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United States | American | 265525580001 | |||||
| DAVIDSON, Nigel James | Amministratore | Luton Cottage The Street Selling ME13 9RQ Faversham Kent | British | 18237320001 | ||||||
| DAVIES, Andrea Clare | Amministratore | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United Kingdom | British | 266948310001 | |||||
| DENT, Fiona Ann | Amministratore | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | England | British | 192515270001 | |||||
| DRINKALL, Christopher John Julian | Amministratore | 39 Saltoun Road SW2 1EN London | England | British | 76437030001 | |||||
| EDEN, Keith Leslie | Amministratore | 6 Friends Walk CB11 4EA Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | 53429470001 | |||||
| EVANS, Richard John | Amministratore | 41 King Edwards Grove TW11 9LZ Teddington Middlesex | England | British | 77303490001 | |||||
| EVANS, Sylvia Kathleen | Amministratore | 401 Alaska Building 61 Grange Road SE1 3BB London | United Kingdom | New Zealander | 70941240001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TI MEDIA LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Plc | 20 apr 2020 | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Sapphire Topco Limited | 15 mar 2018 | Marsh Wall E14 9AP London 161 United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Sapphire Bidco Limited | 15 mar 2018 | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Ipc Magazines Holdings Limited | 06 apr 2016 | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Time Inc. | 06 apr 2016 | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street 19801 Wilmington C/O The Corporation Trust Company De United States | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
TI MEDIA LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 05 apr 2018 Consegnato il 11 apr 2018 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Intellectual property with trademark number 270056.. please see instrument for further details. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 13 ago 1999 Consegnato il 02 set 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever | |
Brevi particolari Part basement and ground and fourth fifth and sixth floors 237-247 tottenham court road london W1P oau; ground floor workshop and first and second floor offices in westover house west quay road poole dorset; 39 car parking spaces at westover house west quay road poole dorset t/nos: NGL78946 and DT42610 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of amendment dated 22 december 1998 deed of accession dated 12 october 1998 supplemental to the debenture dated 19 january 1998 | Creato il 22 dic 1998 Acquisito il 15 feb 1999 Consegnato il 03 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession dated 12 october 1998 supplemental to the debenture dated 19 january 1998 | Creato il 12 ott 1998 Acquisito il 15 feb 1999 Consegnato il 03 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental debenture (to a debenture dated 19 january 1998) | Creato il 12 ott 1998 Consegnato il 15 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents (each as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 19 gen 1998 Consegnato il 06 feb 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee under each or any of the senior finance documents and/or mezzanine finance documents | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 06 nov 1968 Consegnato il 22 nov 1968 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Securing debenture stock of international publishing corporation limited amounting to £16,960,172 inclusive of £6,960,172 secured by a trust deed dated 27/6/63 and deeds supplemental. | |
Brevi particolari The property comprised in a trust deed dated 27/06/1963. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 27 giu 1963 Consegnato il 01 lug 1963 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Securing £6,960,172 debenture stock of international publishing corporation limited | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets including uncalled capital within the UK. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0