HUGGINS AND COMPANY,LIMITED

HUGGINS AND COMPANY,LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHUGGINS AND COMPANY,LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00056674
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di HUGGINS AND COMPANY,LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HUGGINS AND COMPANY,LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Westgate Brewery
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Suffolk
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di HUGGINS AND COMPANY,LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2025
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 dic 2024

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per HUGGINS AND COMPANY,LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al07 mar 2026
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma21 mar 2026
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al07 mar 2025
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per HUGGINS AND COMPANY,LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Bilancio redatto al 29 dic 2024

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 mar 2025 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2023

    17 pagineAA

    Seconda presentazione della Dichiarazione di conformità datata 07 mar 2024

    3 pagineRP04CS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 mar 2024 con aggiornamenti

    6 pagineCS01
    Note
    DataNota
    29 mar 2024Clarification A second filed CS01 (Statement of Capital, Shareholder information) was registered on 29/03/2024

    Memorandum e Statuto

    10 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Stato del capitale al 21 nov 2023

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Amount arising from reduction credited to the reserves 17/11/2023
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 01 gen 2023

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Matthew Robert Lee come amministratore in data 31 mar 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Nicholas D'cruz come amministratore in data 31 mar 2023

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 mar 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 16 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 18 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 17 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    2 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 02 gen 2022

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Richard Smothers come amministratore in data 15 ott 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Matthew Robert Lee come amministratore in data 15 ott 2021

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 03 gen 2021

    11 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 26 apr 2020

    11 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HUGGINS AND COMPANY,LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KESWICK, Lindsay Anne
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Segretario
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    207561780001
    D'CRUZ, Simon Nicholas
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish242723610001
    ADAMS, Susanne Margaret
    Azalea
    167 High Street Northchurch
    HP4 3QT Berkhamsted
    Hertfordshire
    Segretario
    Azalea
    167 High Street Northchurch
    HP4 3QT Berkhamsted
    Hertfordshire
    British28738400002
    CUTHBERTSON, Colin
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    Segretario
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    British26369940001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Segretario
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592190001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172445070001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEVENS, Mark
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    Segretario
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    British80951870001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181022120001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Segretario
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    BUBB, Stewart Edmund Conyers
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    Amministratore
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    British36779040001
    CRICHTON, Roger Wells
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    British67937290001
    CUMMING, Johanna Louise
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    Amministratore
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    United KingdomBritish111108910001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    GRIFFITHS, Andrew Lawrence
    Galane House
    Kimbers Drive
    SL1 8JE Burnham
    Berkshire
    Amministratore
    Galane House
    Kimbers Drive
    SL1 8JE Burnham
    Berkshire
    British66013840001
    HANNAH, Ian George
    Whitelocks
    Featherbed Lane Felden
    HP3 0BT Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    Whitelocks
    Featherbed Lane Felden
    HP3 0BT Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British37054780001
    IVELL, Robert Lewis
    Boltons Hill
    Barham Road
    PE28 0YT Spaldwick
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Boltons Hill
    Barham Road
    PE28 0YT Spaldwick
    Cambridgeshire
    United KingdomEnglish96389110001
    IZATT, George Gordon Maclean
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    Amministratore
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    United KingdomBritish895970001
    JACOBS, David Michael
    Riverside House
    Hall Cottages Lodden Drive
    RG10 8ND Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Riverside House
    Hall Cottages Lodden Drive
    RG10 8ND Reading
    Berkshire
    British47141160001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Amministratore
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    KNIGHT, Andrew Ronald
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    Amministratore
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    British81555100002
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135408140001
    LEE, Matthew Robert
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritish286667680001
    LESLIE, John Stewart
    Bec House Church End
    HP27 9PD Bledlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Bec House Church End
    HP27 9PD Bledlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish59934350001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170590800001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HUGGINS AND COMPANY,LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    06 apr 2016
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione57987
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0