CORDIANT GROUP LIMITED

CORDIANT GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCORDIANT GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00063031
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CORDIANT GROUP LIMITED?

    • Agenzie pubblicitarie (73110) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CORDIANT GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sea Containers House
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CORDIANT GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SAATCHI & SAATCHI GROUP LTD17 dic 198717 dic 1987
    SAATCHI & SAATCHI COMPTON GROUP LIMITED14 set 198414 set 1984
    SAATCHI & SAATCHI COMPTON P L C 31 dic 197631 dic 1976
    COMPTON PARTNERS LIMITED21 lug 189921 lug 1899

    Quali sono gli ultimi bilanci di CORDIANT GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per CORDIANT GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Cessazione della carica di Richard James Payne come amministratore in data 29 set 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Charles Ward Van Der Welle come amministratore in data 27 set 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Daniel Patrick Conaghan come amministratore in data 08 lug 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Richard James Payne come amministratore in data 01 lug 2022

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 apr 2022 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Stato del capitale al 30 mar 2022

    • Capitale: GBP 1.348840
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2020

    14 pagineAA

    legacy

    146 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Modifica dei dettagli di Cordiant Group Communications Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Cordiant Group Communications Limited come persona con controllo significativo il 20 nov 2018

    2 paginePSC05

    Dettagli del segretario cambiati per Wpp Group (Nominees) Limited il 26 nov 2018

    1 pagineCH04

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2019

    13 pagineAA

    legacy

    185 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Chi sono gli amministratori di CORDIANT GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    Segretario
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione2757919
    80143770001
    PAYNE, Andrew Robertson
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers
    United Kingdom
    Amministratore
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers
    United Kingdom
    EnglandBritish202208380001
    BINDING, David Wyn
    48 Midhurst Avenue
    Muswell Hill
    N10 3EN London
    Segretario
    48 Midhurst Avenue
    Muswell Hill
    N10 3EN London
    British5994480001
    CALOW, David Ferguson
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Segretario
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    British91285750001
    EVANS, Fiona Maria
    85 Ravensmede Way
    Chiswick
    W4 1TQ London
    Segretario
    85 Ravensmede Way
    Chiswick
    W4 1TQ London
    British49259690002
    JANS, Annamaria
    20 Underhill Road
    East Dulwich
    SE22 0AH London
    Segretario
    20 Underhill Road
    East Dulwich
    SE22 0AH London
    British1085040008
    WEATHERSEED, David Ian Cameron
    The Larches
    22 Claremont Road
    KT10 0PL Claygate
    Surrey
    Segretario
    The Larches
    22 Claremont Road
    KT10 0PL Claygate
    Surrey
    British37857730001
    WILLIAMS, Denise
    Marie Cottage
    Holmbury Lane
    RH5 6ND Holmbury St Mary
    Surrey
    Segretario
    Marie Cottage
    Holmbury Lane
    RH5 6ND Holmbury St Mary
    Surrey
    British24311940004
    BINDING, David Wyn
    48 Midhurst Avenue
    Muswell Hill
    N10 3EN London
    Amministratore
    48 Midhurst Avenue
    Muswell Hill
    N10 3EN London
    British5994480001
    BOLAND, Andrew Kenneth
    25 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    25 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    British71264540005
    BUNTON, Christopher John
    12 The Chowns
    AL5 2BN Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    12 The Chowns
    AL5 2BN Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish1321820001
    BUSS, Jeremy David
    34 Goddington Road
    SL8 5TZ Bourne End
    Buckinghamshire
    Amministratore
    34 Goddington Road
    SL8 5TZ Bourne End
    Buckinghamshire
    United Kingdom British 26720550002
    CONAGHAN, Daniel Patrick
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers
    United Kingdom
    Amministratore
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers
    United Kingdom
    EnglandBritish260161530001
    DELANEY, Paul
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Amministratore
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    United KingdomBritish69254240002
    HAM, David Fenton
    25 Chestnut Avenue
    TN4 0BT Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    25 Chestnut Avenue
    TN4 0BT Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish103819950001
    HOWARD, Stuart Michael
    2 Enbrook Park
    CT20 3SE Folkestone
    Kent
    Amministratore
    2 Enbrook Park
    CT20 3SE Folkestone
    Kent
    United KingdomBritish160271430001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Amministratore
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    UkBritish62634010001
    JANS, Annamaria
    20 Underhill Road
    East Dulwich
    SE22 0AH London
    Amministratore
    20 Underhill Road
    East Dulwich
    SE22 0AH London
    British1085040008
    MUIRHEAD, William Mortimer
    "Knowl Wood"
    29 Park Avenue
    BR6 8LJ Farnborough Park
    Kent
    Amministratore
    "Knowl Wood"
    29 Park Avenue
    BR6 8LJ Farnborough Park
    Kent
    EnglandBritish167103390001
    PAYNE, Richard James
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    United Kingdom
    Amministratore
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    United Kingdom
    EnglandBritish298052910001
    RICHARDSON, Paul Winston George
    125 Park Avenue
    New York
    Ny 10017-5529
    Usa
    Amministratore
    125 Park Avenue
    New York
    Ny 10017-5529
    Usa
    British45700660003
    SAATCHI, Charles
    26 St Leonard's Terrace
    Chelsea
    SW3 4QG London
    Amministratore
    26 St Leonard's Terrace
    Chelsea
    SW3 4QG London
    British11321230001
    SAATCHI, Maurice Nathan, The Lord
    44 Bruton Place
    Berkeley Square
    W1X 7AA London
    Amministratore
    44 Bruton Place
    Berkeley Square
    W1X 7AA London
    United KingdomBritish33348130002
    SCOTT, Andrew Grant Balfour
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Amministratore
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    United KingdomBritish67078370001
    SINCLAIR, Jeremy Theodorson
    Millfield Cottage Millfield Lane
    Highgate
    N6 6JH London
    Amministratore
    Millfield Cottage Millfield Lane
    Highgate
    N6 6JH London
    EnglandBritish12006490001
    SWEETLAND, Christopher Paul
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Amministratore
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    EnglandBritish56529540005
    VAN DER WELLE, Charles Ward
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    United Kingdom
    Amministratore
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    United Kingdom
    EnglandBritish183827730001
    WEATHERSEED, David Ian Cameron
    The Larches
    22 Claremont Road
    KT10 0PL Claygate
    Surrey
    Amministratore
    The Larches
    22 Claremont Road
    KT10 0PL Claygate
    Surrey
    British37857730001
    WEATHERSEED, David Ian Cameron
    The Larches
    22 Claremont Road
    KT10 0PL Claygate
    Surrey
    Amministratore
    The Larches
    22 Claremont Road
    KT10 0PL Claygate
    Surrey
    British37857730001
    WILLIAMS, Denise
    Marie Cottage
    Holmbury Lane
    RH5 6ND Holmbury St Mary
    Surrey
    Amministratore
    Marie Cottage
    Holmbury Lane
    RH5 6ND Holmbury St Mary
    Surrey
    British24311940004
    WILSON, Stephen Michael
    9 Boulters Lock
    Giffard Park
    MK14 5QR Milton Keynes
    Amministratore
    9 Boulters Lock
    Giffard Park
    MK14 5QR Milton Keynes
    British81144620001
    WINTERS, Steve Richard
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    United Kingdom
    Amministratore
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    United Kingdom
    EnglandBritish210160610001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CORDIANT GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    06 apr 2016
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 1948 To 1989
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1320869
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CORDIANT GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 19 apr 2002
    Consegnato il 26 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC (And Its Successors in Title) for and on Behalf of Itself Thenoteholders and the Banks and Financial Institutions from Time to Time Parties to the Finance Documents
    Transazioni
    • 26 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 04 apr 2002
    Consegnato il 12 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC for and on Behalf of Itself and the Banks Andfinancial Institutions from Time to Time Parties to the Bridge Facility Agreement
    Transazioni
    • 12 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 15 dic 1997
    Consegnato il 24 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the agreement dated 30TH september 1997 (as defined) and/or the security documents (as defined) when the same become due for payment or discharge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the property (if any); by way of first fixed charge all present and future f/h and l/h property wheresoever situate; all plant machinery and other equipment; all book and other debts; the goodwill and uncalled capital; by way of first floating charge its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee)
    Transazioni
    • 24 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 apr 1993
    Consegnato il 04 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the guarabtee and the standby facility agreement (as defined)
    Brevi particolari
    71,73,75,77 and 79 whitfield street and 4 - 11 north court. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank, N.A. (As Security Agent)
    Transazioni
    • 04 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge
    Creato il 27 mar 1991
    Consegnato il 09 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from he company and/or any of the other parties named therein other than the beneficiaries (as defined) to the chargee under the terms of a debenture dated 4TH january 1991 and/or this charge
    Brevi particolari
    All estates rights and other interests in the registered and unregistered land described in the schedule l/h property comprising 71, 73, 75, 77 and 79 whitfield street and 4/11 north court and a piece of land bounded by numbers 4/9 north court t/no: LN134138. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank N.A. as Security Agent for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 09 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 mar 1991
    Consegnato il 08 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facilites (as defined) and/or this charge
    Brevi particolari
    All estates and other interests in f/h l/h and other immoveable property situate at the date of the debenture at the l/h property t/no: LN134138 comprising 71, 73, 75, 77 and 79 whitfield street and 4/11 north court a piece of land bounded by number 4/9 north court the l/h land t/no: ngl 47667 being part of the site of north court. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank N.A. as Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 08 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge
    Creato il 27 mar 1991
    Consegnato il 09 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an original debenture dated 4TH january 1991 and/or any of the other parties defined therein other than the beneficiaries (as defined)
    Brevi particolari
    All estates rights and other interests in the registered and unregistered land of which the company is the registered proprietor or owner and which is specified or referred to in the schedule l/h property comprising 71, 73, 75, 77 and 79 whitfield street and 4/11 north court and a piece of land bounded by numbers 4/9 north court. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank N.A. as Security Agent for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 09 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 gen 1991
    Consegnato il 15 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank N.A. as Trustee for the Benefciaries (As Defined)
    Transazioni
    • 15 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 gen 1991
    Consegnato il 15 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank N.A. as Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 15 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0