PANTHER GATESHEAD (VAT) LTD

PANTHER GATESHEAD (VAT) LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPANTHER GATESHEAD (VAT) LTD
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00063674
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di PANTHER GATESHEAD (VAT) LTD?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova PANTHER GATESHEAD (VAT) LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Unicorn House
    Station Close
    EN6 1TL Potters Bar
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PANTHER GATESHEAD (VAT) LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PANTHER DEVELOPMENTS LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    J.B.JACQUEMIN BROTHERS,LIMITED26 set 189926 set 1899

    Quali sono gli ultimi bilanci di PANTHER GATESHEAD (VAT) LTD?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per PANTHER GATESHEAD (VAT) LTD?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al18 giu 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma02 lug 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al18 giu 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per PANTHER GATESHEAD (VAT) LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Bilancio redatto al 31 dic 2023

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2024 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 000636740015, creata il 28 mar 2024

    87 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2022

    23 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Simon Jeffrey Peters come segretario in data 04 gen 2022

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Raphael Rotstein come segretario in data 04 gen 2022

    2 pagineAP03

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    20 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 000636740013, creata il 16 lug 2021

    84 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 000636740014, creata il 16 lug 2021

    32 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    22 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 000636740010 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 000636740011 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 000636740009 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 000636740012, creata il 05 lug 2019

    11 pagineMR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name01 mag 2019

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 30 apr 2019

    RES15

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 000636740011, creata il 27 apr 2018

    77 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di PANTHER GATESHEAD (VAT) LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROTSTEIN, Raphael
    Station Close
    EN6 1TL Potters Bar
    Unicorn House
    England
    Segretario
    Station Close
    EN6 1TL Potters Bar
    Unicorn House
    England
    291485890001
    PERLOFF, Andrew Stewart
    Station Close
    EN6 1TL Potters Bar
    Unicorn House
    England
    Amministratore
    Station Close
    EN6 1TL Potters Bar
    Unicorn House
    England
    EnglandBritishCompany Director1474150001
    PERLOFF, John Henry
    Station Close
    EN6 1TL Potters Bar
    Unicorn House
    England
    Amministratore
    Station Close
    EN6 1TL Potters Bar
    Unicorn House
    England
    EnglandBritishCompany Director71915800002
    PETERS, Simon Jeffrey
    Station Close
    EN6 1TL Potters Bar
    Unicorn House
    England
    Amministratore
    Station Close
    EN6 1TL Potters Bar
    Unicorn House
    England
    EnglandBritishCompany Director81322700006
    PETERS, Simon Jeffrey
    Station Close
    EN6 1TL Potters Bar
    Unicorn House
    England
    Segretario
    Station Close
    EN6 1TL Potters Bar
    Unicorn House
    England
    British81322700003
    ROWSON, Peter Aston
    Croft Lodge
    Church Lane Great Longstone
    DE45 1TB Bakewell
    Derbyshire
    Segretario
    Croft Lodge
    Church Lane Great Longstone
    DE45 1TB Bakewell
    Derbyshire
    British94699120001
    BLOCH, Malcolm Lawrence
    7 The Pavilions
    24-26 Avenue Road
    NW8 6BU London
    Amministratore
    7 The Pavilions
    24-26 Avenue Road
    NW8 6BU London
    BritishCompany Director1474160002
    DOYLE, John Terence
    Station Close
    EN6 1TL Potters Bar
    Unicorn House
    England
    Amministratore
    Station Close
    EN6 1TL Potters Bar
    Unicorn House
    England
    EnglandBritishSurveyor84324470002
    ROWSON, Peter Aston
    Croft Lodge
    Church Lane Great Longstone
    DE45 1TB Bakewell
    Derbyshire
    Amministratore
    Croft Lodge
    Church Lane Great Longstone
    DE45 1TB Bakewell
    Derbyshire
    BritishCompany Director94699120001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PANTHER GATESHEAD (VAT) LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Station Close
    EN6 1TL Potters Bar
    Unicorn House
    England
    06 apr 2016
    Station Close
    EN6 1TL Potters Bar
    Unicorn House
    England
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00293147
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    PANTHER GATESHEAD (VAT) LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 28 mar 2024
    Consegnato il 05 apr 2024
    In corso
    Breve descrizione
    The properties known as land and buildings at jackson street, gateshead under title number TY459539. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 05 apr 2024Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 16 lug 2021
    Consegnato il 26 lug 2021
    In corso
    Breve descrizione
    Not applicable.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 26 lug 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 16 lug 2021
    Consegnato il 26 lug 2021
    In corso
    Breve descrizione
    The property known as land and buildings at jackson street, gateshead registered at the land registry with title number TY459539.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 26 lug 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 05 lug 2019
    Consegnato il 10 lug 2019
    In corso
    Breve descrizione
    The freehold property known as land and buildings at jackson street, gateshed, with title number TY459539.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 10 lug 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 apr 2018
    Consegnato il 15 mag 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The freehold property known as 20 blucher street, birmingham registered at the land registry with title number WK121387. For more details please refer to schedule 2 of the charging instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Trustee for the Secured Parties (Security Trustee)
    Transazioni
    • 15 mag 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 gen 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 04 lug 2017
    Consegnato il 13 lug 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The freehold land being part of prestage house, 49 and 51 holloway head, birmingham registered at the land registry with title number WM713464. For further details please refer to the schedule of the charging instrument.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Agent for the Finance Parties (Security Agent)
    Transazioni
    • 13 lug 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 gen 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 19 apr 2016
    Consegnato il 29 apr 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The freehold property known as 20 blucher street, birmingham registered at the land registry with title number WK121387 and the freehold property known as 29 gough street, birmingham registered at the land registry with title number WM453815. To see all charges, please refer to schedule 2 of the charging document attached to this form.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Trustee for the Secured Parties (Security Trustee)
    Transazioni
    • 29 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 gen 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 lug 2011
    Consegnato il 05 ago 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of further properties charged, please refer to form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Third party floating charge
    Creato il 01 dic 1999
    Consegnato il 08 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from panther securities PLC to the chargee on any account whatsoever pursuant to the security documents (as defined in the deed)
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Third party legal charge
    Creato il 01 dic 1999
    Consegnato il 08 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from panther securities PLC to the chargee on any account whatsoever pursuant to the security documents (as defined in the deed)
    Brevi particolari
    F/H land being land and buildings on the east side of eaton road and on the north side of station square being copthall house station square coventry west midlands t/no: WM78458 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and all rental income .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Third party legal charge
    Creato il 23 gen 1998
    Consegnato il 28 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from panther securities PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the east side of eaton road and on the north side of station square t/n WM78458 with all buildings erections fixtures fittings fixed plant machinery benefit of all leases underleases floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture equipment fixed charge over rents licence fees all monies rights contracts proceeds of sale insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 28 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third party floating charge
    Creato il 23 gen 1998
    Consegnato il 28 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from panther securities PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over the company's undertaking property and other assets of whatsoever nature both present and future including its uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 28 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 mar 1984
    Consegnato il 31 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H offices stores and premises of the back at 136 and 138 high street, slough, berkshire. T.N. bk 176103.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais Bank Nederland N.V.
    Transazioni
    • 31 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 28 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 nov 1981
    Consegnato il 07 nov 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 136/138 high st slough. All assets of the company both present and future including book debts and all other property & assets. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • International Resources & Finance Bank S A
    Transazioni
    • 07 nov 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 28 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Series of debentures
    Creato il 02 mag 1935
    Consegnato il 02 mag 1935
    Soddisfatta integralmente
    Transazioni
    • 02 mag 1935Registrazione di un'ipoteca
    • 05 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0